MACARTHY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MACARTHY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00168702 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MACARTHY LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MACARTHY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MACARTHY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MACARTHYS PHARMACEUTICALS P.L.C. | 30. Juni 1920 | 30. Juni 1920 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MACARTHY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MACARTHY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Aktienkonsolidierung am 12. Juni 2012 | 5 Seiten | SH02 | ||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012
| 4 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Sillitto als Geschäftsführer am 26. Jan. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Engelen als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Jason Grover als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Martin Sillitto am 04. Apr. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard De Souza als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Thomas Engelen als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Philip Edward Parry als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MACARTHY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE SOUZA, Richard Anthony | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex | England | British | 154817550001 | |||||
| GROVER, Jason | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex | England | British | 71645160002 | |||||
| PARRY, Philip Edward | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex | United Kingdom | British | 153299600001 | |||||
| BUCKELL, Stephen William | Sekretär | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Sekretär | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| EARNSHAW, Jeremy Waring | Sekretär | 5 Thorntons Dale Newlaithes Road Horsforth LS18 4UW Leeds West Yorkshire | British | 47388900001 | ||||||
| KNIGHT, Anthony | Sekretär | 122 Ongar Road Writtle CM1 3NX Chelmsford Essex | British | 126965310001 | ||||||
| LOFTHOUSE, Stephen David | Sekretär | Windsor House Cornwall Road HG1 2PW Harrogate North Yorkshire | British | 111617880001 | ||||||
| NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| OAKLEY, Stephen Edward | Sekretär | 31 Barlings Road AL5 2AW Harpenden Hertfordshire | British | 438640001 | ||||||
| PINCHIN, Nicholas John | Sekretär | 19 Sutton Place E9 6EH London | British | 54411540001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Sekretär | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| WEST, David William | Sekretär | 10 Brindles RM11 2RU Hornchurch Essex | English | 18533210002 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| AXTEN, Godfrey Clive | Geschäftsführer | 21 Oakhill Road TN13 1NS Sevenoaks Kent | Uk | British | 112949110001 | |||||
| BRYANT, Derek | Geschäftsführer | 14 Lordswood View Leaden Roding CM6 1SE Dunmow Essex | British | 54411450001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Geschäftsführer | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| EARNSHAW, Jeremy Waring | Geschäftsführer | 5 Thorntons Dale Newlaithes Road Horsforth LS18 4UW Leeds West Yorkshire | British | 47388900001 | ||||||
| ENGELEN, Thomas | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex | United Kingdom | Netherlands | 136783900002 | |||||
| FELLOWS, Jonathan | Geschäftsführer | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| KAY, Andrew George | Geschäftsführer | 9 Back Lane Whixley Gate YO26 8BG Whixley Yorkshire | British | 41347920003 | ||||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Geschäftsführer | 24 Oakfield Road HD2 2XF Huddersfield Yorkshire | British | 8991780009 | ||||||
| LLOYD, Allen John | Geschäftsführer | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Geschäftsführer | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| LOFTHOUSE, Stephen David | Geschäftsführer | Windsor House Cornwall Road HG1 2PW Harrogate North Yorkshire | British | 111617880001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Geschäftsführer | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| OADES, Andrew Giovanni | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Cardinal Health Essex | United Kingdom | British | 108839700002 | |||||
| OAKLEY, Stephen Edward | Geschäftsführer | 31 Barlings Road AL5 2AW Harpenden Hertfordshire | England | British | 438640001 | |||||
| PARKER, John Francis | Geschäftsführer | Beck House 10 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | British | 47002780001 | ||||||
| PARSONS, Ian Dominic | Geschäftsführer | 72 Spindlewood Elloughton HU15 1LL Brough North Humberside | England | British | 63325310001 | |||||
| READ, John Leslie | Geschäftsführer | 2 Milbrook KT10 9EJ Esher Surrey | England | British | 58899370001 | |||||
| SAUNDERS, Martin John | Geschäftsführer | 17 Bromley Road BN25 3ES Seaford East Sussex | England | British | 34627480001 | |||||
| SILLITTO, Martin | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Essex | United Kingdom | British | 126965260002 | |||||
| STEELE, Richard John | Geschäftsführer | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | 1415570001 | |||||
| TAYLOR, Malcolm Archibald, Doctor | Geschäftsführer | The Acorns Drury Lane, Pannal HG3 1ET Harrogate North Yorkshire | British | 7445580002 |
Hat MACARTHY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 12. Mai 2010 Geliefert am 21. Mai 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. Okt. 2002 Geliefert am 24. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Okt. 2000 Geliefert am 11. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All and any of all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the other secured parties (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 26. Okt. 2000 Geliefert am 11. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee including those under the guarantee and indemnity (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 08. Aug. 1997 Geliefert am 20. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of off-set | Erstellt am 08. Aug. 1997 Geliefert am 15. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) or any of them to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents (as defined in the facilities agreement of even date) | |
Kurze Angaben All monies at the date of the charge or at any tine thereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books are charged by way of fixed and specific charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set off 10.1.83 | Erstellt am 10. Jan. 1983 Geliefert am 24. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set-off | Erstellt am 13. Mai 1980 Geliefert am 28. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Any sums standing to the credit of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memo of deposit | Erstellt am 06. März 1944 Geliefert am 10. März 1944 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £5000 | |
Kurze Angaben No. 18 duke st, chelmesford essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MACARTHY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0