MACARTHY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMACARTHY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00168702
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MACARTHY LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MACARTHY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MACARTHY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MACARTHYS PHARMACEUTICALS P.L.C.30. Juni 192030. Juni 1920

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MACARTHY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MACARTHY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 02. Okt. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    4 SeitenSH19

    Aktienkonsolidierung am 12. Juni 2012

    5 SeitenSH02

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 15. Juni 2012

    • Kapital: GBP 5,780,899.20
    4 SeitenSH06

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share prem reduced/ b pref shares cancelled/ consolidated 12/06/2012
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Martin Sillitto als Geschäftsführer am 26. Jan. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Thomas Engelen als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    11 SeitenAA

    Ernennung von Mr Jason Grover als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Martin Sillitto am 04. Apr. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    12 SeitenAA

    Ernennung von Mr Richard De Souza als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Thomas Engelen als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Philip Edward Parry als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Okt. 2010Part Rectified THE DATE OF TERMINATION ON THE TM01 WAS REMOVED FROM THE PUBLIC REGISTER ON 07/10/10 AS IT WAS FACTUALLY INACCURATE OR DERIVED FROM SOMETHING FACTUALLY INACCURATE

    Wer sind die Geschäftsführer von MACARTHY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DE SOUZA, Richard Anthony
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    EnglandBritish154817550001
    GROVER, Jason
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    EnglandBritish71645160002
    PARRY, Philip Edward
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomBritish153299600001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Sekretär
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Sekretär
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    KNIGHT, Anthony
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    British126965310001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Sekretär
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    OAKLEY, Stephen Edward
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    British438640001
    PINCHIN, Nicholas John
    19 Sutton Place
    E9 6EH London
    Sekretär
    19 Sutton Place
    E9 6EH London
    British54411540001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Sekretär
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Sekretär
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    English18533210002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    AXTEN, Godfrey Clive
    21 Oakhill Road
    TN13 1NS Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    21 Oakhill Road
    TN13 1NS Sevenoaks
    Kent
    UkBritish112949110001
    BRYANT, Derek
    14 Lordswood View
    Leaden Roding
    CM6 1SE Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Lordswood View
    Leaden Roding
    CM6 1SE Dunmow
    Essex
    British54411450001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    ENGELEN, Thomas
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomNetherlands136783900002
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    KAY, Andrew George
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    British41347920003
    KERSHAW, Graham Anthony
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    British8991780009
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Geschäftsführer
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    OADES, Andrew Giovanni
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritish108839700002
    OAKLEY, Stephen Edward
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish438640001
    PARKER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    British47002780001
    PARSONS, Ian Dominic
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    EnglandBritish63325310001
    READ, John Leslie
    2 Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    EnglandBritish58899370001
    SAUNDERS, Martin John
    17 Bromley Road
    BN25 3ES Seaford
    East Sussex
    Geschäftsführer
    17 Bromley Road
    BN25 3ES Seaford
    East Sussex
    EnglandBritish34627480001
    SILLITTO, Martin
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomBritish126965260002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TAYLOR, Malcolm Archibald, Doctor
    The Acorns
    Drury Lane, Pannal
    HG3 1ET Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Acorns
    Drury Lane, Pannal
    HG3 1ET Harrogate
    North Yorkshire
    British7445580002

    Hat MACARTHY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Group debenture
    Erstellt am 12. Mai 2010
    Geliefert am 21. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2002
    Geliefert am 24. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 2000
    Geliefert am 11. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All and any of all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the other secured parties (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 26. Okt. 2000
    Geliefert am 11. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee including those under the guarantee and indemnity (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Aug. 1997
    Geliefert am 20. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee )
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of off-set
    Erstellt am 08. Aug. 1997
    Geliefert am 15. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) or any of them to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents (as defined in the facilities agreement of even date)
    Kurze Angaben
    All monies at the date of the charge or at any tine thereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books are charged by way of fixed and specific charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set off 10.1.83
    Erstellt am 10. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Letter of set-off
    Erstellt am 13. Mai 1980
    Geliefert am 28. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    Any sums standing to the credit of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1980Registrierung einer Belastung
    Memo of deposit
    Erstellt am 06. März 1944
    Geliefert am 10. März 1944
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £5000
    Kurze Angaben
    No. 18 duke st, chelmesford essex.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1944Registrierung einer Belastung
    • 17. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MACARTHY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Juli 2013Aufgelöst am
    02. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0