NIDD VALE MOTORS,LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNIDD VALE MOTORS,LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00169796
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NIDD VALE MOTORS,LIMITED?

    • Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich NIDD VALE MOTORS,LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NIDD VALE MOTORS,LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für NIDD VALE MOTORS,LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    26 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ zum Riverside House Irwell Street Manchester Lancashire M3 5EN am 10. Dez. 2020

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Nov. 2019

    24 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Nov. 2018

    27 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Nov. 2017

    23 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Charles Richard Jackson als Geschäftsführer am 08. Aug. 2017

    2 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Nov. 2016

    23 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Nov. 2015

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Okt. 2015

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Apr. 2015

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Okt. 2014

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Apr. 2014

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Mai 2013

    19 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    5 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    15 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Nidd Vale Corner 91 Leeds Road Harrogate North Yorkshire HG2 8EY* am 14. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Wer sind die Geschäftsführer von NIDD VALE MOTORS,LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PULLAN, Nigel Waite
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Sekretär
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    BritishCompany Director79509270001
    CROSSLEY, Neil Martin
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director152186310001
    PULLAN, Nigel Waite
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director79509270001
    WATSON, Tony Mortimer
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Riverside House
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director91716790001
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    British1676810002
    SMITH, Robert John
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    Sekretär
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    BritishCompany Director7211250002
    STOKES, Paul
    Rose Cottage
    Water End Brompton
    DL6 2RN Northallerton
    Sekretär
    Rose Cottage
    Water End Brompton
    DL6 2RN Northallerton
    BritishCommercial Director90970840003
    CLARK, Simon Nicholas
    16 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector91716650001
    CORNER, Robin
    Riseholm
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1DW Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Riseholm
    Haggs Road Follifoot
    HG3 1DW Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director58645060002
    GORDON, Ray
    19 Skelwith Drive
    Wincobank
    S4 8BN Sheffield
    Geschäftsführer
    19 Skelwith Drive
    Wincobank
    S4 8BN Sheffield
    BritishService Director92008080001
    HAINSTOCK, Colin George
    Pheasants Hill
    Kilburn
    YO61 4AG York
    Geschäftsführer
    Pheasants Hill
    Kilburn
    YO61 4AG York
    BritishCompany Director94619630001
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1676810002
    JACKSON, Charles Richard
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Loftus Hill
    Ferrensby
    HG5 9JT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1676810002
    JACKSON, John David
    Red Oaks Manor House Lane
    LS17 9JD Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Oaks Manor House Lane
    LS17 9JD Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director1051970002
    JACKSON, Susan
    South Lawns Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    South Lawns Wigton Lane
    LS17 8SJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director22773660001
    PULLAN, Nigel Waite
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    18
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director79509270001
    RYCROFT, John Gordon
    1 The Glade
    Scarcroft
    LS14 3JG Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 The Glade
    Scarcroft
    LS14 3JG Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2728860001
    SMITH, Robert John
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    Geschäftsführer
    Fairfield Layton Road
    Horsforth
    LS18 5ET Leeds
    United KingdomBritishCompany Director7211250002
    STOKES, Paul
    Nidd Vale Corner
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Nidd Vale Corner
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director90970840006
    WALKER, Ian Geoffrey
    17 Newcastle Close
    Drighlington
    BD11 1DF Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    17 Newcastle Close
    Drighlington
    BD11 1DF Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector91715880001
    WILSON, Graham Michael
    Nidd Vale Corner
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Nidd Vale Corner
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishSales Director153545880001
    WILSON, Graham Michael
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    Nidd Vale Corner
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    91 Leeds Road
    HG2 8EY Harrogate
    Nidd Vale Corner
    North Yorkshire
    EnglandBritishSales Director153545880001

    Hat NIDD VALE MOTORS,LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2012
    Geliefert am 14. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the east side of deighton road south east side of deighton road north east side of deighton road and garage premises on the north west side of sandbeck lane wetherby t/nos WYK83540, WYK95425, WYK721531 and WYK532593 together with all buildings and fixtures by way of assignment the rental income the proceeds of any disposal in respect of the charged assets the proceeds of any claim under any insurance policy and the property rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nigel Pullan and Richard Jackson
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2012
    Geliefert am 11. Apr. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings lying to the south west of hornbeam park avenue harrogate t/no NYK100629 fixed charge all the company's right title and interest in any insurance policy relating to the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hornbeam Park Developments Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 17. Feb. 2012
    Geliefert am 24. Feb. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The chattels,the insurance policies and the contracts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2010
    Geliefert am 04. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander Consumer (UK) PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juli 2010
    Geliefert am 30. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the east side of deighton road t/no WYK83540,land and buildings on the south east side of deighton road t/no WYK721531 and garage premises on the north west side of sandbeck lane t/no WYK532593 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 07. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge on vehicle stocks
    Erstellt am 03. Feb. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All new and used motor vehicles and all proceeds of sale and all monies from time to time.all the benefit of any obligations guarantees and warranties.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Bank Limited Trading as Ge Money Motor Finance
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge on vehicle stocks
    Erstellt am 02. Dez. 2003
    Geliefert am 05. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all such of the present and future propery and assets - rent hire charges etc, vehicles leased hired or sold, contracts deposited, title and interest, proceeds, insurance monies, benefits of guarantees indemnites and securities, debts, enforcement rights.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 2003
    Geliefert am 05. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fce Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2003
    Geliefert am 16. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 05. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the east of leeds road harrogate t/n's NYK62723 and NYK246765. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 05. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the south west of hornbeam park avenue harrogate t/n NYK100629. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2003
    Geliefert am 05. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. Sept. 2001
    Geliefert am 04. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 2 centurion park clifton moorgate york north yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cragside mercedes dealership leeds road pamal harrogate t/no: NYK129671. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Sept. 2000
    Geliefert am 28. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All those monies from time to time be owing to the company by saab great britain limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to saab great britain limited by deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Saab Finance Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. März 2000
    Geliefert am 30. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The secured amount which is the additional consideration as defined in an overage agreement dated the 27 march 2000 and made between appleyard motor company limited and nidd vale motors limited which becomes payable under clause 4.5 of the legal charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of leeds road,harrogate.t/no.NYK62723.
    Berechtigte Personen
    • Appleyard Motor Company Limited
    Transaktionen
    • 30. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. März 2000
    Geliefert am 30. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    91/97 leeds road harrogate. T/no. NYK62723. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. März 2000
    Geliefert am 11. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of equipment
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 02. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Such sum or sums as shall become payable to the chargee under the provisions of the offer letter (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee arising out of or in connection with the offer letter or in the supply agreement (both as defined)
    Kurze Angaben
    1-Bradbury 4.41 dw mot package complete with post life chock ramps jacking beam brake tester and head lamp tester and other items of equipment please see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Shell U.K. Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 15. Nov. 1991
    Geliefert am 16. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Okt. 1991
    Geliefert am 05. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that parcel of land situate at nidd bridge nidd north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juli 1991
    Geliefert am 24. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land hereditments and premises being land and buildings lying on the west side of regent parade harrogate.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 07. Juni 1979
    Geliefert am 13. Juni 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land being 42, 44 and 46 bond end knaresborough together with all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank LTD
    Transaktionen
    • 13. Juni 1979Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NIDD VALE MOTORS,LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Nov. 2012Beginn der Verwaltung
    26. Nov. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Gerald Murphy
    Tower 12 Manchester House 18-20 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12 Manchester House 18-20 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Andrew Poxon
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    2
    DatumTyp
    26. Nov. 2015Beginn der Liquidation
    28. Apr. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Alexander Henry Maxwell
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    4th Floor Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Andrew Poxon
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praktiker
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Robert Alexander Henry Maxwell
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Vorgeschlagener Liquidator
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Andrew Poxon
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0