POLYCASA SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePOLYCASA SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00174111
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von POLYCASA SERVICES LIMITED?

    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich POLYCASA SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE (NI) LTD
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von POLYCASA SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    QUINN PLASTICS SERVICES LIMITED06. Okt. 200506. Okt. 2005
    QUINN PLASTICS LIMITED22. Okt. 200422. Okt. 2004
    BARLO PLASTICS LIMITED02. Sept. 199802. Sept. 1998
    IRG PLASTICS LIMITED04. Juli 199004. Juli 1990
    SKRENDER LIMITED07. Apr. 192107. Apr. 1921

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POLYCASA SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für POLYCASA SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Polycasa Services Limited C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB zum C/O Deloitte (Ni) Ltd 4 Brindley Place Birmingham Midlands B1 2HZ am 30. Juni 2016

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 15. Juni 2016

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Paul John O'brien als Geschäftsführer am 06. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 24. Juli 2015

    • Kapital: GBP 5,149
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Emma Louise Duffy am 31. März 2015

    1 SeitenCH03

    Beendigung der Bestellung von Paul John O'brien als Geschäftsführer am 31. Mai 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Francis Donnelly als Geschäftsführer am 31. Mai 2015

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Paul Francis Donnelly als Direktor am 01. Juni 2015

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Paul John O'brien als Direktor am 01. Juni 2015

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Paul Williams als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ash Road Elton Cheshire, CH2 4LF United Kingdom zum Polycasa Services Limited C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 28. Jan. 2015

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Imperial Park Newport Wales NP10 8FS zum Ash Road Elton Cheshire, CH2 4LF am 17. Okt. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 17. Juli 2014

    • Kapital: GBP 5,149
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Emma Louise Duffy am 17. Juli 2014

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul John O'brien am 17. Juli 2014

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von POLYCASA SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DUFFY, Emma Louise
    c/o Deloitte (Ni) Ltd
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Midlands
    Sekretär
    c/o Deloitte (Ni) Ltd
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    Midlands
    British164646540001
    DONNELLY, Paul Francis
    Castle Buildings
    Paget Square
    BT74 7HS Enniskillen
    Polycasa Services Limited
    Fermanagh
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Castle Buildings
    Paget Square
    BT74 7HS Enniskillen
    Polycasa Services Limited
    Fermanagh
    United Kingdom
    IrelandIrishCompany Director174644790001
    BANNON, Brenda Mary
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    Sekretär
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    IrishCompany Director143227940001
    BOURKE, John
    No 7 St Johns Road
    IRISH Sandymount
    Dublin 4
    Sekretär
    No 7 St Johns Road
    IRISH Sandymount
    Dublin 4
    IrishCompany Director31795130002
    MCGLYNN, Hugh Francis
    27 The Village
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Ireland
    Sekretär
    27 The Village
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Ireland
    Irish2102190001
    O'REILLY, John Dara
    16 Cherrymount
    Keadue Lane
    IRISH Cavan
    Ireland
    Sekretär
    16 Cherrymount
    Keadue Lane
    IRISH Cavan
    Ireland
    IrishCompany Director143227900001
    GOODBODY NORTHERN IRELAND SECRETARIAL LIMITED
    Fountain Street
    BT1 5EF Belfast
    42-46
    County Antrim
    Northern Ireland
    Sekretär
    Fountain Street
    BT1 5EF Belfast
    42-46
    County Antrim
    Northern Ireland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerNI059866
    179250450001
    BANNON, Brenda Mary
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    Geschäftsführer
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    Northern IrelandIrishCompany Director143227940001
    BEAUSANG, Brian
    2 Orwell Park
    Rathgar
    IRISH Dublin
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    2 Orwell Park
    Rathgar
    IRISH Dublin
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishAccountant102081750001
    BELOFF, Jeremy
    Glenwood
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Glenwood
    Templewood Lane
    SL2 3HW Farnham Common
    Buckinghamshire
    BritishCo. Director31802870001
    BOURKE, John
    17 Longford Terrace
    Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    17 Longford Terrace
    Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director31795130001
    BRAEKERS, Joannes Trudo
    De Slogen 95
    Zolder
    FOREIGN
    Belgium
    Geschäftsführer
    De Slogen 95
    Zolder
    FOREIGN
    Belgium
    BelgianProduction Director13148710001
    BRAZIL, Patrick Vincent
    9 Standhouse Road
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Eire
    Geschäftsführer
    9 Standhouse Road
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Eire
    IrishDirector1942150001
    BURKE, David
    1 Heathfield Road
    Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Geschäftsführer
    1 Heathfield Road
    Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishCompany Director37114520001
    CADDICK, Robert Anthony
    6 Carmarthen Way
    NN10 0TN Rushden
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    6 Carmarthen Way
    NN10 0TN Rushden
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director28896650002
    CRICHTON, Michael
    11 Glencairn
    Harbour Road
    IRISH Dalkey
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    11 Glencairn
    Harbour Road
    IRISH Dalkey
    Dublin
    Ireland
    BritishCompany Director34629940002
    CRICHTON, Michael
    Tewkesbury
    Ballinclea Road
    Killiney
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    Tewkesbury
    Ballinclea Road
    Killiney
    Dublin
    Ireland
    BritishCompany Director34629940001
    DELAHUNTY, Michael
    97 Orwell Gardens
    Dublin 14
    Ireland
    Geschäftsführer
    97 Orwell Gardens
    Dublin 14
    Ireland
    IrishCompany Director34756550001
    DIXON, Paul Edward
    Gortmullan
    BT92 9AU Derrylin
    Quinn Group
    Co Fermanagh
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gortmullan
    BT92 9AU Derrylin
    Quinn Group
    Co Fermanagh
    United Kingdom
    IrelandIrishDirector160840400001
    DONAGHY, Jack
    16 Temple Villas
    Palmerston Road Rathmines
    IRISH Dublin 6
    Geschäftsführer
    16 Temple Villas
    Palmerston Road Rathmines
    IRISH Dublin 6
    IrishAccountant51406410001
    DONNELLY, Paul Francis
    Gortmullan
    BT92 9AU Derrylin
    C/O Polycasa Services Limited
    Co. Fermanagh, Northern Ireland
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gortmullan
    BT92 9AU Derrylin
    C/O Polycasa Services Limited
    Co. Fermanagh, Northern Ireland
    United Kingdom
    IrelandIrishCompany Director174644790001
    FARRELL, John Patrick
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    Geschäftsführer
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    United KingdomBritishCompany Director702300001
    FAURE, Adriaan Pierre Johan
    Koolmeeslaan 26
    Zandhoven 2243
    Belgium
    Geschäftsführer
    Koolmeeslaan 26
    Zandhoven 2243
    Belgium
    DutchDirector14608730001
    FORD, John Alexander
    2 Crow Hill
    London Road
    PE18 8LP Godmanchester
    Geschäftsführer
    2 Crow Hill
    London Road
    PE18 8LP Godmanchester
    BritishCompany Director31802880001
    HOWELL, Michael John
    Hill Farm Chapel Lane
    Maidford
    NN12 8HU Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Hill Farm Chapel Lane
    Maidford
    NN12 8HU Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Director44276240002
    KERR, David
    25 Hampton Park
    St. Helens Wood
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    25 Hampton Park
    St. Helens Wood
    Booterstown
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant75638200004
    LOOS, Renaat Achiel
    Stippelberg 54
    Herselt
    FOREIGN
    Belgium
    Geschäftsführer
    Stippelberg 54
    Herselt
    FOREIGN
    Belgium
    BelgianAccountant13148700001
    LUNNEY, Tony
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    Geschäftsführer
    c/o A & L Goodbody
    Austin Friars
    EC2N 2HA London
    Augustine House
    IrelandIrishCompany Director145242920001
    MASTERSON, Patrick
    Whitestones Lagore Road
    IRISH Dunshaughlin
    Meath
    Ireland
    Geschäftsführer
    Whitestones Lagore Road
    IRISH Dunshaughlin
    Meath
    Ireland
    IrishOperations Director99561480001
    MCCAFFREY, Liam Gerard
    7 Barnhill
    Tempo Road
    BT74 6FL Enniskillen
    Fermanagh
    Geschäftsführer
    7 Barnhill
    Tempo Road
    BT74 6FL Enniskillen
    Fermanagh
    Northern IrelandIrishCompany Director77350500001
    MCGLYNN, Hugh Francis
    27 The Village
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    27 The Village
    IRISH Newbridge
    Co Kildare
    Ireland
    IrishAccountant2102190001
    MORRIS, Henry James
    Aviary 1 Shannon Lawn
    Porth Circular Road
    IRISH Limerick
    Eire
    Geschäftsführer
    Aviary 1 Shannon Lawn
    Porth Circular Road
    IRISH Limerick
    Eire
    IrishCompany Director43608360001
    MULLINS, Anthony Patrick, Doctor
    Nutley Lodge
    Seaview Terrace Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Geschäftsführer
    Nutley Lodge
    Seaview Terrace Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrishCo Director37961810003
    MURPHY, Denis Patrick
    Augustine House
    EC2N 2HA Austin Friars
    C/O A & L Goodbody
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Augustine House
    EC2N 2HA Austin Friars
    C/O A & L Goodbody
    London
    United Kingdom
    IrelandIrishCompany Director148348260001
    O'BRIEN, Paul John
    Castle Buildings
    Paget Square
    BT74 7HS Enniskillen
    Polycasa Services Limited
    Fermanagh
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Castle Buildings
    Paget Square
    BT74 7HS Enniskillen
    Polycasa Services Limited
    Fermanagh
    United Kingdom
    IrelandIrishCompany Director171680330001

    Hat POLYCASA SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 2011
    Geliefert am 09. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 2011
    Geliefert am 09. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security assignment of contractual rights under intercompany loans
    Erstellt am 02. Dez. 2011
    Geliefert am 09. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security agent or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in under and to the contracts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Dez. 2011
    Geliefert am 09. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the real property,the tangible moveable property,the accounts,the intellectual property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 17. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transaktionen
    • 17. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 05. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies or any of them to the bilateral bank or otherwise to national irish bank limited save in its capacity as syndicate bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC (The Security Trustee for the Bilateral Bank (the Security Trustee))
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 2001
    Geliefert am 29. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the finance documents or any of them
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Banks(The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 29. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat POLYCASA SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Juni 2016Beginn der Liquidation
    23. Nov. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter Michael Allen
    19 Bedford Street
    BT2 7EJ Belfast
    Praktiker
    19 Bedford Street
    BT2 7EJ Belfast

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0