BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)
Überblick
Unternehmensname | BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 00174695 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
- Aktivitäten religiöser Organisationen (94910) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 20. Apr. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2015 ohne Mitgliederliste | 4 Seiten | AR01 | ||
Beendigung der Bestellung von Michael Moss als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Andrew Joseph Williams als Geschäftsführer am 13. Juli 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nora Whitham als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Philip Anthony Turner als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Colin David Blake als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul John Slater als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Quartus Tudge als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Roger Anthony Marks als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Macha als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stanley Noel Jenkins als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Harry Gibson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gary Stuart Hodgson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Ernest Gibbons als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von John David Nowell als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Marilyn Banister als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Baines als Geschäftsführer am 01. Feb. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 20. Apr. 2014 | 43 Seiten | AA | ||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2014 ohne Mitgliederliste | 13 Seiten | AR01 | ||
Beendigung der Bestellung von Susan Chambers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 20. Apr. 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 45 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILD, Deborah Anne | Sekretär | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | 152195600001 | |||||||
ARNOLD, Sharron Margaret | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 11715120003 | ||||
AYERS, Paul Nicholas, Revd Canon | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | United Kingdom | British | Vicar | 73611680001 | ||||
FLETCHER, Ian Jack | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Chartered Accountant | 4391620001 | ||||
LEE, David John, Venerable Dr | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Clerk In Holy Orders | 100725340002 | ||||
MAYO-SMITH, Peter, Reverend | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Clerk In Holy Orders | 136363330001 | ||||
HALLIDAY, Malcolm Keith | Sekretär | 7 Kirkstall Gardens BD21 5PN Keighley West Yorkshire | British | Diocesan Secretary | 58320670002 | |||||
ALEXANDER, William Samuel | Geschäftsführer | Cravendale Croft Road Ingleton LA6 3BZ Carnforth Lancashire | British | Furniture Restorer | 40756210001 | |||||
ASTON, Pamela | Geschäftsführer | Lindisfarne Harehills Lane, Oldfield BD22 0RU Keighley West Yorkshire | British | Headteacher | 69276660001 | |||||
BAINES, Nicholas, Rt Revd | Geschäftsführer | Elmsley Street Steeton BD20 6SE Keighley Bradford Dioesan Board Of Finance Kadugli House England | Engalnd | British | Bishop Of Bradford | 160346100001 | ||||
BANISTER, Marilyn | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | United Kingdom | British | Money Advice Supervisor | 43986220001 | ||||
BASSHAM, Sallie | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Lecturer (Retired) | 147445030001 | ||||
BASSHAM, Sallie | Geschäftsführer | 4 Penyghent View Horton In Ribblesdale BD24 0HE Settle North Yorkshire | British | Lecturer | 76036640001 | |||||
BLAKE, Colin David, Revd | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Clerk In Holy Orders | 177334530001 | ||||
BOTWRIGHT, Adrian Paul, Rev Canon | Geschäftsführer | The Rectory Rectory Lane BD23 1ER Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | Clerk In Holy Orders | 55030360001 | ||||
BOWER, Helen Janet | Geschäftsführer | Stone Croft Lothersdale BD20 8EE Keighley West Yorkshire | England | British | Social Worker | 19005630001 | ||||
BOWER, Helen Janet | Geschäftsführer | Stone Croft Lothersdale BD20 8EE Keighley West Yorkshire | England | British | Social Worker | 19005630001 | ||||
CHAMBERS, Susan Diana Joan | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | None | 38580030001 | ||||
CLARKE, Andrew John, The Revd | Geschäftsführer | Holy Trinity Vicarage Oak Avenue BD16 1ES Bingley West Yorkshire | British | Vicar | 73611940001 | |||||
CLARKE, Colin David Emrys, Reverend | Geschäftsführer | The Vicarage 12 Fairfax Gardens Menston LS29 6ET Ilkley West Yorkshire | British | Clerk In Holy Orders | 55030180002 | |||||
COOK, Harold Harlow, Lt Cdr | Geschäftsführer | Smithy Cottage Giggleswick BD24 0BA Settle N Yorkshire | British | Retired | 27523950001 | |||||
DAY, John Kenneth, Rev | Geschäftsführer | St Margarets Vicarage 2 Upper Rushton Road BD3 7HX Bradford West Yorkshire | British | Clerk In Holy Orders | 31338770001 | |||||
DEAN, Michael David | Geschäftsführer | Teenley House Wigglesworth BD23 4RJ Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | Marketing Manager | 119987020001 | ||||
DEO, Paul Ernest, Rev | Geschäftsführer | The Vicarage Parsonage Road Laisterdyke BD4 8PY Bradford West Yorkshire | British | Parish Priest | 110828650001 | |||||
DEY, Charles Gordon Norman, Revd Canon | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Clerk In Holy Orders | 55626660001 | ||||
DEY, Charles Gordon Norman, Revd Canon | Geschäftsführer | Tong Vicarage Holme Wood Road BD4 9EJ Bradford Yorkshire | England | British | Clergyman | 55626660001 | ||||
EVANS, David Richard John, Bishop-Rt Rev | Geschäftsführer | 30 Grosvenor Road BD18 4RN Shipley West Yorkshire | British | Assistant Bishop Of Bradford | 28089770001 | |||||
EVANS, Simon Robert | Geschäftsführer | 6 Vicarage Close Wyke BD12 8QW Bradford West Yorkshire | British | Minister Of Religion | 123227000001 | |||||
FAWCETT, John Harold | Geschäftsführer | 2 Queens Square Dent LA10 5QL Sedbergh Cumbria | British | Retired Diplomat | 27523960001 | |||||
FELL, Alan William, Reverend Canon | Geschäftsführer | The Vicarage Loftus Hill LA10 5SQ Sedbergh Cumbria | United Kingdom | British | Clerk In Holy Orders | 37541520001 | ||||
FORT, Robert | Geschäftsführer | Higher Hague Farm Kelbrook BB8 6LW Colne Lancashire | British | Engineer | 40564100001 | |||||
GARNETT, Geoffrey Frank | Geschäftsführer | The Hey Barn Back Lane Newton In Bowland BB7 3EE Clitheroe Lancs | British | Retired | 116782010001 | |||||
GIBBONS, Paul Ernest | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Consultant | 115587880001 | ||||
GIBSON, David Harry | Geschäftsführer | Kadugli House Elmsley Street, Steeton BD20 6SE Keighley | England | British | Administrator | 91643490001 | ||||
GRAINGER, Bruce, The Revd Canon | Geschäftsführer | The Vicarage Gledhow Drive Oxenhope BD22 9SA Keighley West Yorkshire | British | Clerk In Holy Orders | 19005720001 |
Hat BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 04. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 tranfield close leeds t/no WYK387141 fixed charge any other interest in the property,all rents receivable,all fixtures and fittings by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 27. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 2B nab lane shipley bradford west yorkshire t/no WYK687078 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 27. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property woodlands cononley t/no NYK37870 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 27. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 6 glenhurst road nab wood shipley t/no WYK122597 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 27. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 6 woodvale crescent bingley t/no WYK102804 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. März 2009 Geliefert am 27. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property 15 chatts wood fold bradford t/no WYK650657 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 04. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 15 brooklyn threshfield north yorkshire t/no NYK65572, all fixtures and fittings affixed to the property, floating charge all other moveable plant machinery implements building materials utensils furniture and equipment and assigns the goodwill see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 2008 Geliefert am 27. Nov. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 14 park cliffe road undercliffe bradford west yorkshire t/no WYK666794 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Juli 2007 Geliefert am 07. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 10 carleton avenue skipton north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 08. Juni 1967 Geliefert am 21. Juni 1967 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Sterling pounds 1,000 & further advances | |
Kurze Angaben 95 pallen ave, eccleshill,bradford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 10. Sept. 1966 Geliefert am 01. Okt. 1966 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Sterling pounds 400 and further advances | |
Kurze Angaben All that plot of land containing about 1210 sq.yds. Situate at alleston bradford, and also all that church hall and other buildings and outbuildings erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Okt. 1965 Geliefert am 01. Nov. 1965 | Ausstehend | Gesicherter Betrag Sterling pounds 1,850 and all other monies due etc. | |
Kurze Angaben 22 park avenue bingley yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0