BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)

BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung nach Garantie ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 00174695
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    • Aktivitäten religiöser Organisationen (94910) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis20. Apr. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A4H8MCZ6

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2015 ohne Mitgliederliste

    4 SeitenAR01
    X4BOI71M

    Beendigung der Bestellung von Michael Moss als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI42J

    Beendigung der Bestellung von Andrew Joseph Williams als Geschäftsführer am 13. Juli 2013

    1 SeitenTM01
    X4BOI4XN

    Beendigung der Bestellung von Nora Whitham als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI4JL

    Beendigung der Bestellung von Philip Anthony Turner als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI4H5

    Beendigung der Bestellung von Colin David Blake als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI2X5

    Beendigung der Bestellung von Paul John Slater als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI4DS

    Beendigung der Bestellung von Paul Quartus Tudge als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI4EG

    Beendigung der Bestellung von Roger Anthony Marks als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI3WA

    Beendigung der Bestellung von David Macha als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI3L4

    Beendigung der Bestellung von Stanley Noel Jenkins als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI3NC

    Beendigung der Bestellung von David Harry Gibson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI36A

    Beendigung der Bestellung von Gary Stuart Hodgson als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI3K8

    Beendigung der Bestellung von Paul Ernest Gibbons als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI37U

    Beendigung der Bestellung von John David Nowell als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI2ZL

    Beendigung der Bestellung von Marilyn Banister als Geschäftsführer am 20. Apr. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI2S0

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Baines als Geschäftsführer am 01. Feb. 2014

    1 SeitenTM01
    X4BOI2PK

    Jahresabschluss erstellt bis zum 20. Apr. 2014

    43 SeitenAA
    A40NV58Z

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Apr. 2014 ohne Mitgliederliste

    13 SeitenAR01
    X38UZVXE

    Beendigung der Bestellung von Susan Chambers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X38UZVX6

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 20. Apr. 2014

    1 SeitenAA01
    X2L6LUPK

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    45 SeitenAA
    R2HHLM3T

    Wer sind die Geschäftsführer von BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHILD, Deborah Anne
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Sekretär
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    152195600001
    ARNOLD, Sharron Margaret
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    United KingdomBritishChartered Accountant11715120003
    AYERS, Paul Nicholas, Revd Canon
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    United KingdomBritishVicar73611680001
    FLETCHER, Ian Jack
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishChartered Accountant4391620001
    LEE, David John, Venerable Dr
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishClerk In Holy Orders100725340002
    MAYO-SMITH, Peter, Reverend
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishClerk In Holy Orders136363330001
    HALLIDAY, Malcolm Keith
    7 Kirkstall Gardens
    BD21 5PN Keighley
    West Yorkshire
    Sekretär
    7 Kirkstall Gardens
    BD21 5PN Keighley
    West Yorkshire
    BritishDiocesan Secretary58320670002
    ALEXANDER, William Samuel
    Cravendale
    Croft Road Ingleton
    LA6 3BZ Carnforth
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Cravendale
    Croft Road Ingleton
    LA6 3BZ Carnforth
    Lancashire
    BritishFurniture Restorer40756210001
    ASTON, Pamela
    Lindisfarne
    Harehills Lane, Oldfield
    BD22 0RU Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lindisfarne
    Harehills Lane, Oldfield
    BD22 0RU Keighley
    West Yorkshire
    BritishHeadteacher69276660001
    BAINES, Nicholas, Rt Revd
    Elmsley Street
    Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Bradford Dioesan Board Of Finance Kadugli House
    England
    Geschäftsführer
    Elmsley Street
    Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Bradford Dioesan Board Of Finance Kadugli House
    England
    EngalndBritishBishop Of Bradford160346100001
    BANISTER, Marilyn
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    United KingdomBritishMoney Advice Supervisor43986220001
    BASSHAM, Sallie
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishLecturer (Retired)147445030001
    BASSHAM, Sallie
    4 Penyghent View
    Horton In Ribblesdale
    BD24 0HE Settle
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Penyghent View
    Horton In Ribblesdale
    BD24 0HE Settle
    North Yorkshire
    BritishLecturer76036640001
    BLAKE, Colin David, Revd
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishClerk In Holy Orders177334530001
    BOTWRIGHT, Adrian Paul, Rev Canon
    The Rectory Rectory Lane
    BD23 1ER Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Rectory Rectory Lane
    BD23 1ER Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishClerk In Holy Orders55030360001
    BOWER, Helen Janet
    Stone Croft
    Lothersdale
    BD20 8EE Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stone Croft
    Lothersdale
    BD20 8EE Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishSocial Worker19005630001
    BOWER, Helen Janet
    Stone Croft
    Lothersdale
    BD20 8EE Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stone Croft
    Lothersdale
    BD20 8EE Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishSocial Worker19005630001
    CHAMBERS, Susan Diana Joan
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishNone38580030001
    CLARKE, Andrew John, The Revd
    Holy Trinity Vicarage
    Oak Avenue
    BD16 1ES Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Holy Trinity Vicarage
    Oak Avenue
    BD16 1ES Bingley
    West Yorkshire
    BritishVicar73611940001
    CLARKE, Colin David Emrys, Reverend
    The Vicarage 12 Fairfax Gardens
    Menston
    LS29 6ET Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Vicarage 12 Fairfax Gardens
    Menston
    LS29 6ET Ilkley
    West Yorkshire
    BritishClerk In Holy Orders55030180002
    COOK, Harold Harlow, Lt Cdr
    Smithy Cottage
    Giggleswick
    BD24 0BA Settle
    N Yorkshire
    Geschäftsführer
    Smithy Cottage
    Giggleswick
    BD24 0BA Settle
    N Yorkshire
    BritishRetired27523950001
    DAY, John Kenneth, Rev
    St Margarets Vicarage 2 Upper Rushton Road
    BD3 7HX Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Margarets Vicarage 2 Upper Rushton Road
    BD3 7HX Bradford
    West Yorkshire
    BritishClerk In Holy Orders31338770001
    DEAN, Michael David
    Teenley House
    Wigglesworth
    BD23 4RJ Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Teenley House
    Wigglesworth
    BD23 4RJ Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishMarketing Manager119987020001
    DEO, Paul Ernest, Rev
    The Vicarage
    Parsonage Road Laisterdyke
    BD4 8PY Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Vicarage
    Parsonage Road Laisterdyke
    BD4 8PY Bradford
    West Yorkshire
    BritishParish Priest110828650001
    DEY, Charles Gordon Norman, Revd Canon
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishClerk In Holy Orders55626660001
    DEY, Charles Gordon Norman, Revd Canon
    Tong Vicarage Holme Wood Road
    BD4 9EJ Bradford
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Tong Vicarage Holme Wood Road
    BD4 9EJ Bradford
    Yorkshire
    EnglandBritishClergyman55626660001
    EVANS, David Richard John, Bishop-Rt Rev
    30 Grosvenor Road
    BD18 4RN Shipley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 Grosvenor Road
    BD18 4RN Shipley
    West Yorkshire
    BritishAssistant Bishop Of Bradford28089770001
    EVANS, Simon Robert
    6 Vicarage Close
    Wyke
    BD12 8QW Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Vicarage Close
    Wyke
    BD12 8QW Bradford
    West Yorkshire
    BritishMinister Of Religion123227000001
    FAWCETT, John Harold
    2 Queens Square
    Dent
    LA10 5QL Sedbergh
    Cumbria
    Geschäftsführer
    2 Queens Square
    Dent
    LA10 5QL Sedbergh
    Cumbria
    BritishRetired Diplomat27523960001
    FELL, Alan William, Reverend Canon
    The Vicarage Loftus Hill
    LA10 5SQ Sedbergh
    Cumbria
    Geschäftsführer
    The Vicarage Loftus Hill
    LA10 5SQ Sedbergh
    Cumbria
    United KingdomBritishClerk In Holy Orders37541520001
    FORT, Robert
    Higher Hague Farm
    Kelbrook
    BB8 6LW Colne
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Higher Hague Farm
    Kelbrook
    BB8 6LW Colne
    Lancashire
    BritishEngineer40564100001
    GARNETT, Geoffrey Frank
    The Hey Barn
    Back Lane Newton In Bowland
    BB7 3EE Clitheroe
    Lancs
    Geschäftsführer
    The Hey Barn
    Back Lane Newton In Bowland
    BB7 3EE Clitheroe
    Lancs
    BritishRetired116782010001
    GIBBONS, Paul Ernest
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishConsultant115587880001
    GIBSON, David Harry
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    Geschäftsführer
    Kadugli House
    Elmsley Street, Steeton
    BD20 6SE Keighley
    EnglandBritishAdministrator91643490001
    GRAINGER, Bruce, The Revd Canon
    The Vicarage Gledhow Drive
    Oxenhope
    BD22 9SA Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Vicarage Gledhow Drive
    Oxenhope
    BD22 9SA Keighley
    West Yorkshire
    BritishClerk In Holy Orders19005720001

    Hat BRADFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 04. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 tranfield close leeds t/no WYK387141 fixed charge any other interest in the property,all rents receivable,all fixtures and fittings by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 27. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 2B nab lane shipley bradford west yorkshire t/no WYK687078 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 27. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property woodlands cononley t/no NYK37870 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 27. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 6 glenhurst road nab wood shipley t/no WYK122597 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 27. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 6 woodvale crescent bingley t/no WYK102804 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 2009
    Geliefert am 27. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 15 chatts wood fold bradford t/no WYK650657 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Nov. 2008
    Geliefert am 04. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 brooklyn threshfield north yorkshire t/no NYK65572, all fixtures and fittings affixed to the property, floating charge all other moveable plant machinery implements building materials utensils furniture and equipment and assigns the goodwill see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 2008
    Geliefert am 27. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 14 park cliffe road undercliffe bradford west yorkshire t/no WYK666794 and all its fixtures and all income relating to the property and the proceeds of sale of the company in relation to the property.assigns the related rights.by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the undertaking and all other property assets and rights present and future.assigns goodwill and intellectual property.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juli 2007
    Geliefert am 07. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    10 carleton avenue skipton north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Skipton Building Society
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Juni 1967
    Geliefert am 21. Juni 1967
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 1,000 & further advances
    Kurze Angaben
    95 pallen ave, eccleshill,bradford.
    Berechtigte Personen
    • Halifax Building Society
    Transaktionen
    • 21. Juni 1967Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 10. Sept. 1966
    Geliefert am 01. Okt. 1966
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 400 and further advances
    Kurze Angaben
    All that plot of land containing about 1210 sq.yds. Situate at alleston bradford, and also all that church hall and other buildings and outbuildings erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • The Halifax Building Society
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1966Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1965
    Geliefert am 01. Nov. 1965
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    Sterling pounds 1,850 and all other monies due etc.
    Kurze Angaben
    22 park avenue bingley yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Keighley and Craven Building Society
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1965Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0