ENNSTONE PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENNSTONE PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 00185664
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENNSTONE PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich ENNSTONE PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENNSTONE PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALBRIGHTON PLC30. Mai 199030. Mai 1990
    G F LOVELL PUBLIC LIMITED COMPANY11. Nov. 192211. Nov. 1922

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENNSTONE PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENNSTONE PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. März 2012

    4 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    15 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    14 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. März 2011

    7 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Llp 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 23. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. März 2010

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. März 2010

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    17 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Breedon Hall Breedon on the Hill Derby DE73 8AN am 15. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Sept. 2009

    29 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von Colin Mcleod als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Vorschlag des Verwalters

    80 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    58 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von ENNSTONE PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCDONALD, Ross Edward
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44092870005
    COOPER, Julian Edward Peregrine
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    Geschäftsführer
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    United KingdomBritish91049680001
    JOHNSTON, John Michael Stuart
    The Garth Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Garth Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    British12314380002
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Robertson Road
    KY15 5YR Cupar
    29
    Fife
    Geschäftsführer
    Robertson Road
    KY15 5YR Cupar
    29
    Fife
    ScotlandNorthern Irish43853920001
    SMITH, Stephen Rushworth
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6894950002
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Sekretär
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    British55010900001
    COX, Philip Allan
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    Sekretär
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    British45742480001
    GIBBINS, Malcolm
    6 Merion Grove
    DE23 4YR Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    6 Merion Grove
    DE23 4YR Derby
    Derbyshire
    British106989750001
    HUGHES, Philip John
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    Sekretär
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    British1601150001
    ADCOCK, John Robert
    Baddesley Holt
    Cressetts Wood Road
    B26 6EX Lapworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Baddesley Holt
    Cressetts Wood Road
    B26 6EX Lapworth
    Warwickshire
    British13991270001
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Geschäftsführer
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    United KingdomBritish55010900001
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Geschäftsführer
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    United KingdomBritish55010900001
    BERWICK, Gerald Richard Gray
    Garden Lodge
    Hill House Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Garden Lodge
    Hill House Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Hampshire
    EnglandBritish81937150001
    BOWDEN, Philip
    3 Tealby Close
    Gilmorton
    LE17 5PT Lutterworth
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    3 Tealby Close
    Gilmorton
    LE17 5PT Lutterworth
    Leicestershire
    British28032710001
    BREALEY, Peter Ian
    Southfield House 67 High Street
    Braunston
    NN11 4BQ Daventry
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Southfield House 67 High Street
    Braunston
    NN11 4BQ Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish9847020001
    BROWN, Graham Marshall
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish9631280002
    COX, Philip Allan
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    Geschäftsführer
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    British45742480001
    CUTTER, Andrew James
    Oakwood 38 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Oakwood 38 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    British82531800001
    ELLIOTT, Mark
    6116 New Pembroke Lane
    IRISH Fredricks Burg
    Virginia, Va 22407
    Usa
    Geschäftsführer
    6116 New Pembroke Lane
    IRISH Fredricks Burg
    Virginia, Va 22407
    Usa
    British104226710001
    GADSDEN, Eric John Spencer
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13515270003
    HOWE, William Henry
    Tollbar House
    Hassop
    DE45 1NX Bakewell
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Tollbar House
    Hassop
    DE45 1NX Bakewell
    Derbyshire
    British42418700001
    HUGHES, Philip John
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    British1601150001
    MARRIOTT, Philippa Ann
    9 Stratford Grove
    Putney
    SW15 1NU London
    Geschäftsführer
    9 Stratford Grove
    Putney
    SW15 1NU London
    British12342520001
    MAWDSLEY, Jack
    The Old Vicarage
    Bishops Castle
    SY9 5AF Shropshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Bishops Castle
    SY9 5AF Shropshire
    British33669120001
    MCLEOD, Colin Vaughan
    The Homestead
    Ratcliffe Road
    LE7 4UF Thrussington
    Leicester
    Geschäftsführer
    The Homestead
    Ratcliffe Road
    LE7 4UF Thrussington
    Leicester
    EnglandBritish32924830001
    ROSS, Timothy Stuart
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    EnglandBritish33564830003
    ROSS, Timothy Stuart
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    EnglandBritish33564830003
    SCANNELL, Patrick John
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    British8097790001
    SCOBIE, Kenneth Charles
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish8867190001
    TAYLOR, Robert
    Mill House
    Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Mill House
    Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1601190001
    WOOD, John Humphrey Askey
    Albyn House 239 New Kings Road
    SW6 4XG London
    Geschäftsführer
    Albyn House 239 New Kings Road
    SW6 4XG London
    United KingdomBritish2109820001
    WOODMAN, Peter Brian
    31 High Street
    Albrighton
    WV7 3JF Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    31 High Street
    Albrighton
    WV7 3JF Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1601200001

    Hat ENNSTONE PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 04. März 2009
    Geliefert am 12. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon details of charged account number 53029107 sort code 200771 account name bb re ennstone PLC.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 23. Mai 2008
    Geliefert am 02. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and ennstone concrete products limited and each company (as defined) to the chargee on any account whatosever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All present and future interest in the real property being breedon hall, breedon on the hill, derby LT331613, together with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery and the benefit of any covenants for title given or entered into in respect of that property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brian Watkins and John Campbell and Hr Trustees Limited, as Trustees of the Johnston Management Holdings Limited Pension and Life Assurance Scheme (Together as the Trustees and Each a Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental security deed
    Erstellt am 17. Mai 2007
    Geliefert am 25. Mai 2007
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the relevant obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All property undertaking and assets of the company charged under the security documents to which the company is a party. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 25. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2007
    Geliefert am 25. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 25. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 11. Nov. 2004
    Geliefert am 22. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7,717,351 ordinary shares of 10P each in the share capital of johnston group PLC and any further or other securities deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees in substitution for or in addition to such securities all dividends and interest all such rights moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption bonus preference option or otherwise any bonus stock or shares or other new securities of a similar nature be deposited or transferred to the bank and become part of the securities.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2001
    Geliefert am 29. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture dated 7TH july 1997
    Kurze Angaben
    Land and buildings at northwest hadley.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 19. Okt. 2000
    Geliefert am 26. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re ennstone PLC gts bid deposit deal number 87811522. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 07. Aug. 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account no 00716405. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Sept. 1996
    Geliefert am 12. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity in respect of (a) the guarantees and (b) the charge over credit balances
    Kurze Angaben
    (A) albrighton house 135 allport street cannock staffs t/n-SF279216. (B) bolton woods quarry shipley bradford west yorkshire and (c) all estates or interest in any other f/h or l/h property wheresoever situate now belonging to the company; .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Colin Vaughan Mcleod
    • Pontylue Development Company Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 31. März 1995
    Geliefert am 04. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £750,000.00 together with all sums due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Various chattels which include: telescopic 18T mobile crane serial number 17108, swivel head bridge type crane serial number 5032, instln GB110 edge polishing h/c serial number 29318. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 10. Mai 1994
    Geliefert am 16. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sun alliance defective title indemnity policy number 937Y308347 policy dated 1/3/90.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1994
    Geliefert am 16. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bolton woods quarry, shipley, bradford, west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £110,250
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tarmac Quarry Products Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £209,500
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tarmac Building Materials Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 26. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 1993
    Geliefert am 26. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Albrighton house 135 allport street cannock staffordshire t/n SF279216.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 22. Jan. 1992
    Geliefert am 07. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or transplastix limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £250,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account no:78238218 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. Feb. 1990
    Geliefert am 28. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the former regional offices of british coal & situate at all port street cannock staffordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Feb. 1990
    Geliefert am 16. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 43 marquis park wimblebury road, littleworth cannock staffordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 30. Aug. 1989
    Geliefert am 02. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 21. Jan. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. März 1989
    Geliefert am 31. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 30. März 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 1987
    Geliefert am 30. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures l/h property k/a 15A, high street, bargoda. L/h propety k/a 4, alderney street newport gwent. Property k/a rexville newport gwent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kirby & West Limited.
    Transaktionen
    • 30. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 18. Nov. 1985
    Geliefert am 26. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kirby & West Limited
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 14. Okt. 1985
    Geliefert am 23. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kirby & West Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1985Registrierung einer Belastung

    Hat ENNSTONE PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. März 2009Beginn der Verwaltung
    10. März 2010Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicholas James Dargan
    Po Box 810
    66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810
    66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DatumTyp
    10. März 2010Beginn der Liquidation
    07. Sept. 2012Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicholas James Dargan
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0