ERS (A&H) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ERS (A&H) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00192785 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ERS (A&H) LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ERS (A&H) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 52 - 54 Leadenhall Street EC3A 2BJ London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ERS (A&H) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EQUITY RED STAR (ACCIDENT & HEALTH) LIMITED | 02. Aug. 2004 | 02. Aug. 2004 |
| ANTHONY KIDD AGENCIES LIMITED | 29. Sept. 1923 | 29. Sept. 1923 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ERS (A&H) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ERS (A&H) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian David Parker am 05. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian David Parker am 01. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Turner als Sekretär am 14. Juli 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Haviland Bacon als Geschäftsführer am 06. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James David Seton Adams als Sekretär am 14. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Haviland Bacon am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James David Seton Adams als Sekretär am 07. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Terence Hunter Griffin als Sekretär am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD zum 52 - 54 Leadenhall Street London EC3A 2BJ am 16. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 3 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 4 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victoria Louise Cuggy als Sekretär am 01. Mai 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ERS (A&H) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNER, David Charles | Sekretär | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 236361500001 | |||||||
| PARKER, Ian David | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | England | British | 165728150009 | |||||
| WADE, Katharine Anne | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | England | British | 152543610003 | |||||
| ADAMS, James David Seton | Sekretär | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 203469020001 | |||||||
| CUGGY, Victoria Louise | Sekretär | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | British | 105782010002 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Sekretär | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 186665480001 | |||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Sekretär | Holliwell Chandlers CM0 8NY Burnham On Crouch Essex | British | 85213650001 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Sekretär | 21 Burrow Road SE22 8DU London | British | 63143680001 | ||||||
| NURCOMBE, Brian William Frank | Sekretär | Dabrian 21 Palace View Road Chingford E4 9EN London | British | 16018470001 | ||||||
| RINGROSE, Christopher James | Sekretär | Lindum Lodge, Orchard Close Risby IP28 6QL Bury St Edmunds Suffolk | British | 46372950001 | ||||||
| WILKINSON, Sidney James | Sekretär | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||
| AYRTON, Robert | Geschäftsführer | 14 Chigwell Rise IG7 6AB Chigwell Essex | British | 16029460002 | ||||||
| BACON, Mark Haviland | Geschäftsführer | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | United Kingdom | British | 251875420001 | |||||
| BAREHAM, Robert Edward | Geschäftsführer | Squirrels 33 Bidborough Ridge TN4 0UT Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 8522090001 | |||||
| BURNHAM, John Richard | Geschäftsführer | 16 Tufted Close Great Notley Garden Village CM7 8YE Black Notley Essex | British | 77862640001 | ||||||
| CHARLES, Colin David | Geschäftsführer | The Holt 48 Woodcote Avenue SM6 0QY Wallington Surrey | England | British | 46667150002 | |||||
| DODDS, Paul Gavin | Geschäftsführer | Badgers Barn Sparrow Lane CM22 7BA Hatfield Broad Oak Hertfordshire | England | British | 160890670001 | |||||
| FOY, Ian Russell | Geschäftsführer | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex | United Kingdom | British | 154913420002 | |||||
| GIBSON, Andrew James | Geschäftsführer | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex United Kingdom | England | British | 51599670003 | |||||
| GREENMAN, Stephen Mark | Geschäftsführer | 22 Mayflower Gardens CM23 4PA Bishops Stortford Hertfordshire | British | 51025590002 | ||||||
| GREENMAN, Stephen Mark | Geschäftsführer | 6 Normill Terrace Aston Clinton HP22 5AG Aylesbury Buckinghamshire | British | 51025590001 | ||||||
| HEATH, Duncan Rodney | Geschäftsführer | Larkins Farm Stondon Road CM4 0JY Blackmoor Essex | British | 13823360001 | ||||||
| HEATH, Stuart Roger | Geschäftsführer | Fair Green House Vantorts Road, Fair Green CM21 9AJ Sawbridgeworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 64352350003 | |||||
| JOSIAH, John Edward | Geschäftsführer | 22 Norsey Close CM11 1AP Billericay Essex | England | British | 76943870001 | |||||
| KENT, Alan James | Geschäftsführer | Fir Tree Lodge School Road CM7 8ST Rayne Essex | British | 31429740001 | ||||||
| KIER, Michael Hector | Geschäftsführer | 23 Belmont Road TW2 5DA Twickenham Middlesex | Danish | 8719670001 | ||||||
| MORGAN, Douglas Michael | Geschäftsführer | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex | United Kingdom | British | 164736290001 | |||||
| MOWL, Donald William | Geschäftsführer | 4 Ridgeway CM12 9NT Billericay Essex | British | 2850940001 | ||||||
| NICE, Richard Frederick | Geschäftsführer | 70 Heritage Drive ME7 3EH Gillingham Kent | British | 2850930001 | ||||||
| PEXTON, Richard Anthony | Geschäftsführer | 5 Endlesham Road SW12 8JX London | British | 36011070002 | ||||||
| SLAUGHTER, Anne Patricia | Geschäftsführer | Trinest Beehive Chase Hook End CM15 0PG Brentwood Essex | British | 43304840002 | ||||||
| TIMBRELL, Sharon | Geschäftsführer | 33 Glenton Way Rise Park RM1 4AG Romford Essex | British | 70189110001 | ||||||
| WARBURTON, Brian | Geschäftsführer | Great Mead Standon Green End High Cross SG11 1BP Ware Hertfordshire | British | 8514310001 | ||||||
| WHITE, Raymond Leonard | Geschäftsführer | 6 Greenways Goffs Oak EN7 5JY Cuffley Hertfordshire | British | 56012860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ERS (A&H) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers Insurance Group Limited | 16. Apr. 2016 | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52-54 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ERS (A&H) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 13. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Mai 2002 Geliefert am 31. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders"). | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 07. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second guarantee and debenture | Erstellt am 03. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 18. Okt. 1993 Geliefert am 29. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For varying the terms of a lloyds brokers security and trust deed dated 18/10/89 | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of or pursuant to the byelaw. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security and trust deed | Erstellt am 18. Okt. 1989 Geliefert am 25. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for creditors for the time being of the company in respect of insurance transactions under the terms of the deed | |
Kurze Angaben All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 23. Feb. 1983 Geliefert am 04. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (for full details see doc M122). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1975 Geliefert am 14. Okt. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property known as "fairlawns" 79 crossbrook street, cheshunt, herts. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0