FIRTH RIXSON AURORA LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FIRTH RIXSON AURORA LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00201071 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Firth Rixson House 26a Atlas Way S4 7QQ Sheffield South Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AURORA PLC | 29. Juni 1982 | 29. Juni 1982 |
AURORA PLC | 17. Okt. 1924 | 17. Okt. 1924 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung von Kay Louise Dowdall als Direktor am 20. Nov. 2014 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Simon Bland als Geschäftsführer am 20. Nov. 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Firth House P.O. Box 644 Meadowhall Road Sheffield South Yorkshire S9 1JD* am 16. Jan. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher David Seymour am 31. Juli 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 5 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christopher David Seumour am 31. Juli 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Hart als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher David Seumour als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYMOUR, Christopher David | Sekretär | 26a Atlas Way S4 7QQ Sheffield Firth Rixson House South Yorkshire England | British | 158366440002 | ||||||
DOWDALL, Kay Louise, Dr | Geschäftsführer | 26a Atlas Way S4 7QQ Sheffield Firth Rixson House South Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 82722960002 | ||||
SEYMOUR, Christopher David | Geschäftsführer | 26a Atlas Way S4 7QQ Sheffield Firth Rixson House South Yorkshire England | England | British | Chartered Accountant | 158310680001 | ||||
BERGIN, John Charles Michael Francis | Sekretär | 24 Northgate Tickhill DN11 9HY Doncaster South Yorkshire | British | Company Secretary | 12452990001 | |||||
COOMER, John Andrew | Sekretär | 12 Chorley Avenue S10 3RP Sheffield | British | 37571230001 | ||||||
DUNLEVY, Terence Francis | Sekretär | 123 Knowle Lane S11 9SN Sheffield South Yorkshire | Australian | 987090002 | ||||||
HART, James Thomas | Sekretär | Firth House P.O. Box 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | British | 115557140002 | ||||||
PILGRIM, Roy Malcolm | Sekretär | Marchwood Roebuck Drive NG18 5AW Mansfield Nottinghamshire | British | 1790630001 | ||||||
WILSON, Peter William Frederick | Sekretär | Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane Fulwood S10 3RF Sheffield South Yorkshire | British | 987080001 | ||||||
BERGIN, John Charles Michael Francis | Geschäftsführer | 24 Northgate Tickhill DN11 9HY Doncaster South Yorkshire | England | British | Company Secretary | 12452990001 | ||||
BLAND, Peter Simon | Geschäftsführer | 26a Atlas Way S4 7QQ Sheffield Firth Rixson House South Yorkshire England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 42351130005 | ||||
BRIGHTMORE, Eric Arthur | Geschäftsführer | 6 Kilburn Road Dronfield Woodhouse S18 5QA Sheffield South Yorkshire | England | British | Director | 1435570001 | ||||
BUNYON, Ross Murdoch | Geschäftsführer | 132 Morshead Drive 2220 Hurstville Grove Nsw Australia | Australian | Chief General Manager | 58154840001 | |||||
CASTAN, George | Geschäftsführer | 26 Coppin Grove 3122 Hawthorn Victoria Australia | Australian | Director | 62993940001 | |||||
DUNLEVY, Terence Francis | Geschäftsführer | 123 Knowle Lane S11 9SN Sheffield South Yorkshire | Australian | Finance Director | 987090002 | |||||
FITCH, Peter George Edward | Geschäftsführer | 3 Ridge Lane New Lambton Heights New South Wales Nsw 2305 Australia | Australian | Chief Executive | 34075380002 | |||||
HALL, David John | Geschäftsführer | Craglands Ashopton Road, Bamford S33 0DB Hope Valley Derbyshire | British | Company Director | 40070600001 | |||||
HART, James Thomas | Geschäftsführer | Firth House P.O. Box 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 115557140002 | ||||
MACDONALD, Neil Andrew | Geschäftsführer | 21 Clarendon Road S10 3TQ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 3696630003 | ||||
NEWMAN, Peter John | Geschäftsführer | 1 Riverside Crescent DE45 1HF Bakewell Derbyshire | British | Engineer | 77363340001 | |||||
PILGRIM, Roy Malcolm | Geschäftsführer | Marchwood Roebuck Drive NG18 5AW Mansfield Nottinghamshire | British | Accountant | 1790630001 | |||||
READING, Paul George | Geschäftsführer | 52a Parriwi Road FOREIGN Mosman New South Wales 2088 Australia | New Zealander | Director | 35821240001 | |||||
REES, Henry Evan | Geschäftsführer | 14 Julian Street Mosman New South Wales 2088 FOREIGN Australia | Australian | Chief Operating Executive | 1853660001 | |||||
ROBINSON, Gregory Allan | Geschäftsführer | 87 Hallamshire Road S10 4FN Sheffield South Yorkshire | Australia | Group Finance Director | 55134620001 | |||||
SANDOW, Maxwell Thomas | Geschäftsführer | 314 Hudson Parade Clareville Beach New South Wales 2107 FOREIGN Australia | Australian | Company Director | 20205310001 | |||||
SCOTT, Bryan | Geschäftsführer | 3 Majura Close 2075 St Ives Nsw Australia | Australian/British | Group General Manager Business | 58155920001 | |||||
SHEEHAN, Alan John | Geschäftsführer | 2 Dore Road Dore S17 3NB Sheffield Yorkshire | British | Group Managing Director | 75517320001 | |||||
SMORGON, Graham Joseph | Geschäftsführer | 2 Linlithgow Road 3142 Toorak Victoria Australia | Australian | Director | 62996170001 | |||||
STANCLIFFE, Peter William | Geschäftsführer | 1895 Pittwater Road Bayview New South Wales FOREIGN Nsw 2104 Australia | British | Managing Director | 47330950001 | |||||
WILSON, Peter William Frederick | Geschäftsführer | Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane Fulwood S10 3RF Sheffield South Yorkshire | England | British | Personnel Director | 987080001 |
Hat FIRTH RIXSON AURORA LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2012 Geliefert am 11. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 20. Dez. 2007 Geliefert am 29. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Sept. 2006 Geliefert am 20. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 21. Feb. 2003 Geliefert am 27. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge over all properties listed in schedule with all buildings and fixtures thereon and by way of first equitable charge over all subsidiary shares,investments and all distribution rights and all freehold/leasehold property not charged pursuant to clause 2.3(a) of the deed; all book debts,rights and claims,all monetary claims and monies standing to the credit of its accounts; the goodwill and uncalled capital; floating charge over all assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Agreement | Erstellt am 05. Aug. 1983 Geliefert am 05. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat FIRTH RIXSON AURORA LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0