LITESOME SPORTSWEAR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LITESOME SPORTSWEAR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00207867 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||
Ernennung von Mr Thomas James Piper als Sekretär am 01. Juli 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Cameron John Olsen als Sekretär am 01. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alastair Peter Orford Dick am 01. Mai 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||
Ernennung von Mr Alastair Peter Orford Dick als Direktor am 14. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Rachel Isabel Lilian Stockton als Geschäftsführer am 14. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 30. Apr. 2016 | 7 Seiten | AAMD | ||||||
legacy | 17 Seiten | CS01 | ||||||
| ||||||||
Ernennung von Miss Rachel Isabel Lilian Stockton als Direktor am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von David Michael Forsey als Geschäftsführer am 14. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Ernennung von Adedotun Ademola Adegoke als Direktor am 14. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Wallace Ashley als Geschäftsführer am 14. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Thomas James | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260021610001 | |||||||
| ADEGOKE, Adedotun Ademola | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 203129860001 | |||||
| DICK, Alastair Peter Orford | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 256598390002 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Sekretär | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MELLORS, Robert Frank | Sekretär | The Warrener Warren Row RG10 8QS Reading Berkshire | British | 30104540002 | ||||||
| MOODIE, Gordon Murray | Sekretär | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| OLSEN, Cameron John | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183504980001 | |||||||
| RITCHIE, Alistair John, Sol | Sekretär | Waterman's Lodge 15 Beales Lane KT13 8JS Weybridge Surrey | British | 6417760002 | ||||||
| SIMPSON, Brian Charles | Sekretär | 15 Langham Way RG10 8AX Wargrave Berkshire | British | 47141350001 | ||||||
| TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Sekretär | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | British | 131967270001 | ||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||
| ASHLEY, Michael James Wallace | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 95500210002 | |||||
| AUSTEN, Patrick George | Geschäftsführer | 14 Chantry View Road GU1 3XR Guildford Surrey | British | 55015730001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Geschäftsführer | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| FORSEY, David Michael | Geschäftsführer | NG20 8RY Shirebrook Unit A Brook Park East United Kingdom | England | British | 147207580002 | |||||
| GRIFFITHS, Andrew Lawrence | Geschäftsführer | Galane House Kimbers Drive SL1 8JE Burnham Berkshire | British | 66013840001 | ||||||
| JACOBS, David Michael | Geschäftsführer | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| LOVELL, Alan Charles | Geschäftsführer | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Geschäftsführer | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MARNOCH, Alasdair, Mr. | Geschäftsführer | Bramble Bottom Wedmans Lane RG27 9BX Rotherwick Hampshire | England | British | 216655900001 | |||||
| MELLORS, Robert Frank | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 30104540005 | |||||
| MOODIE, Gordon Murray | Geschäftsführer | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| PARNELL, Philip John | Geschäftsführer | The Old Bell House The Common HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | 57485400001 | |||||
| PETERS, Andrew Robert Gerald, 151298 | Geschäftsführer | 1 Josephine Avenue KT20 7AB Lower Kingswood Surrey | British | 56810170001 | ||||||
| RONNIE, Christopher | Geschäftsführer | 18 Macclesfield Road SK9 2AA Wilmslow Cheshire | British | 79360390001 | ||||||
| STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Geschäftsführer | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 245592990001 | |||||
| THOM, James Demmink | Geschäftsführer | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Geschäftsführer | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WYCHERLEY, Peter | Geschäftsführer | 394 Barnsley Road Sandal WF2 6BW Wakefield West Yorkshire | British | 130910001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slazenger Carlton (Holdings) Ltd | 16. Dez. 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LITESOME SPORTSWEAR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 10. März 1996 Geliefert am 26. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to the financing documents (as therein defined) and all liabilities payable or owing by pixelframe limited (to be renamed dunlop slazenger group limited) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed, as therein defined) under or in connection with the vendor a note (as defined in the inter-creditor deed) including (without limitation) the guarantee liabilities of the company to pay all monies due and owing to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trade marks & patents charge | Erstellt am 10. März 1996 Geliefert am 26. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to the financing documents (as therein defined) and all liabilities payable or owing by pixelframe limited (to be renamed dunlop slazenger group limited) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed, as therein defined) under or in connection with the vendor a note (as defined in the inter-creditor deed) including (without limitation) the guarantee liabilities of the company to pay all monies due and owing to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Kurze Angaben First fixed charge all the trade marks as set out in the schedule to form 395 together with all the goodwill of the business and any other rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Mai 1984 Geliefert am 06. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/hold and l/hold property with all fixtures thereon the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital for further details see doc M121. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0