VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00215909 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
- (5010) /
Wo befindet sich VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wedgnock Lane Warwick CV34 5YA Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PRINCES COMMERCIALS (SOUTHAMPTON) LIMITED | 07. Feb. 1985 | 07. Feb. 1985 |
| J.H.PRINCE & CO.,LIMITED | 27. Aug. 1926 | 27. Aug. 1926 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 122 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGREAL, Anthony Gerard | Sekretär | 7 Abbey Close B49 5QW Alcester Warwickshire | British | 13719400003 | ||||||
| HUNTER, David | Geschäftsführer | Loxley Heights Banbury Road CV37 7HX Stratford Upon Avon 3 Warwickshire | England | Australian | 107771720003 | |||||
| PRINCE, Hazel Valerie | Sekretär | Yew Tree Cottage Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | British | 8759860001 | ||||||
| BENZOW, Carl Jan Mikael | Geschäftsführer | Avenue De L'Ete 57 Waterloo 1410 Belgium | Swedish | 87936020001 | ||||||
| BRANDTZAEG, Bernt | Geschäftsführer | 1 The Orchards Wilmcote CV37 9XF Stratford Upon Avon | Norwegian | 566080001 | ||||||
| BRANDTZAEG, Bernt | Geschäftsführer | 1 The Orchards Wilmcote CV37 9XF Stratford Upon Avon | Norwegian | 566080001 | ||||||
| FROMMELT, Otto Christian | Geschäftsführer | 87 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | Liechtenstein Citizen | 79591040001 | ||||||
| HENDRIKSE, Albert Johannes | Geschäftsführer | 97 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | Dutch | 73122500002 | ||||||
| HINRICH, Michael Colin | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage Park Lane Great Alne B49 6HS Alcester Warwickshire | British | 46812470001 | ||||||
| JOHNSON, Stephen Andrew | Geschäftsführer | Hasty Leys Farm Brailes OX15 5AF Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | 31861840002 | |||||
| MARTIN, Malcolm | Geschäftsführer | The Mews 233 Nithsdale Road G41 5PY Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 121711020001 | |||||
| OLKINUORA, Markku Heikki | Geschäftsführer | 97 Northumberland Road CV32 6HQ Leamington Spa Warwickshire | Finnish | 97638770003 | ||||||
| PRINCE, Hazel Valerie | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | British | 8759860001 | ||||||
| PRINCE, Henry John | Geschäftsführer | The Lilacs Noads Way Dibden Purlieu SO45 4PD Southampton Hampshire | British | 8759890001 | ||||||
| PRINCE, Marjorie Constance | Geschäftsführer | The Lilacs Noads Way Dibden Purlieu SO45 4PD Southampton Hampshire | British | 8759870001 | ||||||
| PRINCE, Michael John | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage Church Lane SO51 0QH Braishfield Hampshire | England | British | 8759880001 | |||||
| REBELING, Orjan Christer Ewald | Geschäftsführer | Tresco 154a Loxley Road CV37 7DT Stratford Upon Avon Warwickshire | Swedish | 40658190001 | ||||||
| ROBINSON, Alexander William | Geschäftsführer | Little Oak Norton Grange, Little Kineton CV35 0DP Warwick Warwickshire | British | 84166850001 | ||||||
| RYDIN, Jan Staffan | Geschäftsführer | Tresco 154a Loxley Road CV37 7DT Stratford Upon Avon Warwickshire | Swedish | 145501470001 | ||||||
| SMITH, David Michael | Geschäftsführer | Longstone Myddle Wood, Myddle SY4 3RY Shrewsbury Shropshire | England | English | 86324790001 | |||||
| SMITH, David Michael | Geschäftsführer | Longstone Myddle Wood, Myddle SY4 3RY Shrewsbury Shropshire | England | English | 86324790001 | |||||
| SVENSSON, Tommy Ebenhard | Geschäftsführer | Avon House High Street Welford On Avon CV37 8EA Stratford Upon Avon Warwickshire | Swedish | 56801510003 | ||||||
| TODD, Thomas Kevin | Geschäftsführer | The Mount 198 High Street Henley In Arden B95 5HT Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 194024730001 |
Hat VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 1992 Geliefert am 05. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (See form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 09. Juli 1990 Geliefert am 12. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 21.4.37 | |
Kurze Angaben Fixed charge over all vehicles plant machinery & equipment, the benefit of all contracts for the sale rental etc. all book & other debts in respect of the vehicles or contracts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Apr. 1988 Geliefert am 13. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining repcon premises, test lane, nursling, southampton hampshire. Title no hp 152637. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Feb. 1988 Geliefert am 10. Feb. 1988 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Repcon premises test lane, nursling, southampton, hampshire T.no:- HP152637. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed stock and book debt charge | Erstellt am 20. Mai 1987 Geliefert am 21. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 21.4.87 and all moneys due or to become due under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all the vehicles plant machinery, equipment. The benefit of all contracts for the sale rental conditional sale hire purchase or other finance or credit arrangements all book and other debts owing to the company (see 395 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 05. Aug. 1982 Geliefert am 07. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee | |
Kurze Angaben Undertaking and property whatsoever and wheresoever both present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 18. Sept. 1981 Geliefert am 28. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H corbridge depot beddow way, aylesford kent as comprised in a transfer dated 18/9/81. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juli 1980 Geliefert am 01. Aug. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over the company's undertaking & all its property & assets whatsoever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 1980 Geliefert am 28. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and bldgs on east side of new road, newhaven, east sussex title no:- esx 26434. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Apr. 1979 Geliefert am 03. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings fixtures, fuxed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0