LAVA CAPITAL UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LAVA CAPITAL UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00224601 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LAVA CAPITAL UK LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Chancery House 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHELLEY OAK LIMITED | 15. Dez. 2008 | 15. Dez. 2008 |
| SHELLEY OAK PLC | 20. März 2006 | 20. März 2006 |
| QUINCUNX PLC | 11. Jan. 1995 | 11. Jan. 1995 |
| SR RESTAURANT PLC | 10. Aug. 1994 | 10. Aug. 1994 |
| SCOTT'S RESTAURANT, PUBLIC LIMITED COMPANY | 22. Sept. 1927 | 22. Sept. 1927 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip James Curwen als Sekretär am 29. Juni 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 30. Juni 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Snaebjorn Sigurdsson als Geschäftsführer am 26. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von So Director Limited als Direktor am 26. Juni 2014 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRY, Alan | Geschäftsführer | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom | England | British | 125162690001 | |||||||||
| SO DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom |
| 190248950001 | ||||||||||
| BLAND, Geoffrey Charles | Sekretär | 1 Hollowmead Claverham BS49 4LF Bristol | British | 1763600001 | ||||||||||
| CURWEN, Philip James | Sekretär | High Street Knaphill GU21 2PG Woking 1 Surrey United Kingdom | 155749400001 | |||||||||||
| CURWEN, Philip James | Sekretär | High Street Knaphill GU21 2PG Woking 1 Surrey United Kingdom | British | 161979510001 | ||||||||||
| FOKES, Brian Ronald | Sekretär | 34 Rowan Way Rottingdean BN2 7FP Brighton East Sussex | British | 14013980001 | ||||||||||
| PRICHARD-JONES, Kenneth Victor | Sekretär | 1 Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 37769570002 | ||||||||||
| NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 50353670001 | |||||||||||
| BENNISON, Peter James | Geschäftsführer | 5 Ashley Close NW4 1PH London | England | British | 88640070003 | |||||||||
| BLAND, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | 1 Hollowmead Claverham BS49 4LF Bristol | England | British | 1763600001 | |||||||||
| HELGASON, Arni | Geschäftsführer | 19 Reykjavik Kambasel 109 Iceland | Iceland | Icelander | 137732190002 | |||||||||
| KERMAN, Anthony David | Geschäftsführer | 5 Saint Jamess Square SW1Y 4JU London | United Kingdom | British | 72531870002 | |||||||||
| KERMAN, Isidore | Geschäftsführer | 11 Mansfield Street W1M 0AH London | British | 35542530001 | ||||||||||
| KERMAN, Nicholas | Geschäftsführer | 25 Eaton Mews South SW1W 9HR London | England | British | 55578530001 | |||||||||
| LORENZ, Robert Jacques | Geschäftsführer | 97 St Johns Wood Terrace NW8 6PP London | British | 3397220001 | ||||||||||
| OSBORNE, Clarke Anthony | Geschäftsführer | 1 Malthouse Barn Barn Lane Chelwood BS18 4NN Bristol | British | 48713080003 | ||||||||||
| PRICHARD JONES, Kenneth Victor | Geschäftsführer | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 118944980001 | |||||||||
| PRICHARD JONES, Sebastian James | Geschäftsführer | Flat 4 26/27 Great Tower Street EC3R 5AQ London | England | British | 69343350002 | |||||||||
| PRICHARD-JONES, Dagmar Eve | Geschäftsführer | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 6556330001 | ||||||||||
| PRICHARD-JONES, Kenneth Victor | Geschäftsführer | 1 Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 37769570002 | ||||||||||
| SCHINDLER, Darren | Geschäftsführer | 86 Stag Leys KT21 2TL Ashtead Surrey | British | 118944850001 | ||||||||||
| SIGURDSSON, Snaebjorn | Geschäftsführer | Kirkjusandi 2 155 Reyjavik Islandsbanki Hf Iceland | Iceland | Icelandic | 168776090001 | |||||||||
| COLERIDGE PARTNERS LLP | Geschäftsführer | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 120033030001 | |||||||||||
| CONSOLIDATED HOLDINGS PLC | Geschäftsführer | PO BOX 134 4th North Suite Town Mills Trinity Square GY1 3HN St Peter Port Guernsey Channel Islands | 109847110001 | |||||||||||
| DRAGON DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 85218910001 | |||||||||||
| ENTERPRISE CORPORATION | Geschäftsführer | P O Box 556 Charlestown Nevis West Indies | 52245280001 | |||||||||||
| MANAGEMENT CORPORATION | Geschäftsführer | P O Box 556 Charlestown Nevis West Indies | 51797180001 | |||||||||||
| STJORNARMENN ENF | Geschäftsführer | Skofarhlid 12 FOREIGN Reykjavik 105 Iceland | 126702600001 | |||||||||||
| STJORNARZ EHF | Geschäftsführer | Borgartun 18, FOREIGN Reykjavik 105 Iceland | 120033190001 | |||||||||||
| STJORNARZ EHF | Geschäftsführer | Borgartun 18, Reykjavik 105 Iceland | 120033190001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LAVA CAPITAL UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Jason Scott Haigh | 06. Apr. 2016 | CM23 4FS Bishops Stortford 19 Ploughmans Close Hertfordshire England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Christopher James Duncan Mcdougall | 06. Apr. 2016 | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom | Nein |
Nationalität: Australian Staatsangehörigkeit: Australia | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat LAVA CAPITAL UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of priorities containing a charging clause | Erstellt am 03. Juli 2009 Geliefert am 21. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any money or assets which the company receives in contravention of the deed which has not been agreed by the senior creditor see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of priorities | Erstellt am 31. März 2008 Geliefert am 09. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from consero homes dartnell ave limited to the chargee and the senior creditor not exceeding £4,205,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any money or assets which the company receives in contravention of the deed, which has not been agreed by the senior creditor see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of priorities | Erstellt am 24. Okt. 2007 Geliefert am 01. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from consero more lane limited (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any money or assets which the company receives. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture and charge | Erstellt am 12. März 2007 Geliefert am 29. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All assets and undertaking of the company including uncalled capital and including all monies due under and all security for loans made by the company from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 1992 Geliefert am 21. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage bristol lawn tennis & squash centre, redland green, redland, bristol by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property the plant machinery and fixtures and fittings, furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business of a licenced publican etc the benefit of all licences (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 1992 Geliefert am 04. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge of licensed premises | Erstellt am 31. März 1992 Geliefert am 04. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a 1 pont street l/b of kensington and chelsea, greater london title no. 334759 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the goodwill of the business the benefit of all justices, excise or other licences (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Okt. 1991 Geliefert am 07. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a 4-7 (inclusive) victoria buildings, terminus place, l/b of city of westminster, greater london, title no. 353505 fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture andequipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1987 Geliefert am 12. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Mirabelle restaurant 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. März 1987 Geliefert am 12. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 9, 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Feb. 1987 Geliefert am 02. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H premises at pickering place vaults (title no 106860) l/h premises at 5 st.jame's street (title no ln U04252) l/h premises at 4/7 victoria buildings (title no ln 65915). (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 1984 Geliefert am 27. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 81 & 83 buckingham alace road and 164 victoria street, london SW1 title no. 249201. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 10. Jan. 1966 Geliefert am 12. Jan. 1966 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 | |
Kurze Angaben 1 & 2 great windmill street 18, 19, 20 coventry street W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0