RECORD SHOP 2 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRECORD SHOP 2 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00229249
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RECORD SHOP 2 LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HMV MUSIC LIMITED08. Mai 199808. Mai 1998
    EMI GROUP HOME ELECTRONICS (UK) LIMITED16. Aug. 199616. Aug. 1996
    THORN EMI HOME ELECTRONICS (UK) LIMITED28. Apr. 198628. Apr. 1986
    HMV SHOPS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    EMI RECORD SHOPS LIMITED29. März 192829. März 1928

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Apr. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    22 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2019

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2018

    25 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    9 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2017

    22 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2016

    23 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juli 2015

    17 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Juli 2014

    26 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Juni 2014

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Mai 2014

    29 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Nov. 2013

    36 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 14. Juli 2013

    32 Seiten2.24B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed hmv music LIMITED\certificate issued on 30/04/13
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name30. Apr. 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 29. Apr. 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    2 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    6 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenF2.18

    Wer sind die Geschäftsführer von RECORD SHOP 2 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Sekretär
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Sekretär
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    GEERS, James Alfred
    33 Private Road
    EN1 2EH Enfield
    Middlesex
    Sekretär
    33 Private Road
    EN1 2EH Enfield
    Middlesex
    British942060001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Sekretär
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    BritishCompany Secretary62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Sekretär
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Sekretär
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    British40470020001
    MURRAY, Wayne Roger
    Glebe House
    Southend Bradfield
    Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Glebe House
    Southend Bradfield
    Reading
    Berkshire
    British2581850001
    RITCHIE, Alistair John
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    Sekretär
    The Coach House
    68 York Road
    KT13 9DY Weybridge
    Surrey
    British6417760001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    Sekretär
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Sekretär
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    ANDERSON, Douglas Donald
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    Geschäftsführer
    South Grange Manor
    Bagshot Road
    SL5 9SP Sunninghill
    Berkshire
    AmericanDirector31392950001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    BritishDirector9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Geschäftsführer
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director180993450001
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    BritishDirector27960300001
    CAMPBELL, Ronald Alexander Lamont
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    Shalbourne
    Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector7919580002
    CHARLTON, Robin
    Bullbeggars Lodge
    Potten End
    HP4 2RS Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Bullbeggars Lodge
    Potten End
    HP4 2RS Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary14721300001
    DUFFY, Simon Patrick
    Galionsvej 42
    1437 Copenhagen K
    Denmark
    Geschäftsführer
    Galionsvej 42
    1437 Copenhagen K
    Denmark
    BritishGroup Finance Director78047990001
    FEAVIOUR, Nicholas David
    Fir Tree House
    18 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fir Tree House
    18 Crossway
    HP5 3LW Chesham
    Buckinghamshire
    BritishTreasurer83587700001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Executive156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    Geschäftsführer
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritishCompany Secretary62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Geschäftsführer
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    EnglandBritishDirector107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritishHuman Resources Director76768320001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritishDirector76768320001
    MARRINER, Elaine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Geschäftsführer
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    EnglandBritishChartered Secretary40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    BritishDirector9406880001
    METCALF, Michael Edward
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandBritishDirector61013220001
    MILES, Martin Terence
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Geschäftsführer
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    EnglandBritishChartered Accountant124119090001
    MOORE, Trevor Philip
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Geschäftsführer
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritishDirector113047410001
    SMITH, George Marsden
    71 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    Geschäftsführer
    71 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    BritishSolicitor15729150001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    Geschäftsführer
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63502600001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant63502600001
    WOOD, Christopher John
    Flat J
    The Dormy House Portnall Drive
    GU25 4NP Wentworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat J
    The Dormy House Portnall Drive
    GU25 4NP Wentworth
    Surrey
    BritishDirector44524800001

    Hat RECORD SHOP 2 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security interest agreement
    Erstellt am 30. Juni 2011
    Geliefert am 01. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each grantor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral being- 2A ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company and the derivative assets see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 01. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Juni 2011
    Geliefert am 01. Juli 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 01. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Commercial trading terms and terms and conditions of trade
    Erstellt am 20. Jan. 2011
    Geliefert am 21. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The title to and ownership of any goods delivered until such time as the supplier has been paid in full in respect of all goods in relation to an individual; and all other goods supplied under the terms whatsoever see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Universal Pictures (UK) Limited
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 30. Juli 2010
    Geliefert am 03. Aug. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 25. Sept. 2009
    Geliefert am 08. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 11 may 2009 and
    Erstellt am 17. Juli 2009
    Geliefert am 24. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 11. Mai 2009
    Geliefert am 12. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 31. März 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h & l/h property, rights in respect of the contracts or policies of insurance and all rights in respect of know-how, patent, trade amrk, service mark, design, business name, topographical or similar right. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 05. Aug. 2003
    Geliefert am 21. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all the assets and the whole of the undertaking present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Mai 2002
    Geliefert am 24. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the secured parties (the "facility agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to a debenture dated 28TH march 1998
    Erstellt am 13. Aug. 2001
    Geliefert am 14. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as defined in the debenture) on the terms and conditions set out in the senior facility agreement dated 25TH february 1998 (the "security agent") under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in resepct of any further advances made thereunder
    Kurze Angaben
    L/H premises as ground floor 19-23 oxford street and 1-6 falconberg court london W1 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 1999
    Geliefert am 03. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture)
    Kurze Angaben
    The leasehold premises known as unit 1 royal house, prices gate, homer road, solihull, west midlands title number WM620352 all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery rights, title supplier or installer of such property any builder any lessee, sub-lessee or licensee of other property hiring leasing rental contract guarantee indemnity or security covenants agreements undertakings or obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag (The Security Agent) as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 03. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1998
    Geliefert am 23. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may now or in the future have to the chargee as trustee for the beneficiaries ("the security agent") or any of the beneficiaries (as defined) under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture)including any liability in respect of further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum now or hereafter owing,due or incurred by the company
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a 82 gower street and 42/56 torrington place london W1 t/n NGL589565 (the other principal property) and the real property all estates or interest in f/h or l/h propertyt and all buildings trade and other fixtures fixed plant and macxhniery for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge supplemental to the debenture dated 22ND may 1998
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 08. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior facility agreement dated 25TH february 1998 (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the principal leasehold property known as unit S9,the bentall centre,kingston-u-thames;all rights and claims thereunder and the benefit of the agreements for sale/lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 08. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 04. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment deed (to a debenture dated 28TH march 1998 as amended and restated on 14TH may 1998 the "amended and restated debenture")
    Erstellt am 22. Mai 1998
    Geliefert am 03. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including all buildings fixtures book debts plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND june 1998
    Erstellt am 18. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Kurze Angaben
    Lease of 172,174 and 176 argyle street glasgow GLA97005.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 4TH june 1998
    Erstellt am 18. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 28TH march 1998
    Kurze Angaben
    Lease of 269 and 271 union street aberdeen ABN3659.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    Erstellt am 14. Mai 1998
    Geliefert am 15. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 15. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the senior facility agreement
    Kurze Angaben
    L/H first floor offices 40 west street marlow bucks t/n BM112289 unit 2 roman gate high street exeter t/n DN270835 2/4 st ann's square and 3,5,7 barton square manchester t/n GM590998 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Bank Corporation(Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RECORD SHOP 2 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Jan. 2013Beginn der Verwaltung
    17. Juli 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    2
    DatumTyp
    17. Juli 2014Beginn der Liquidation
    01. Jan. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Robert James Harding
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Vorgeschlagener Liquidator
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Robert James Harding
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Neville Barry Khan
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0