BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED

BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00233961
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Waterside
    Po Box 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Kulbinder Dosanjh als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kulbinder Dosanjh als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Andrew Ian Fleming als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Courtney Kate Adams als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 510,510
    SH01

    Ernennung von Mrs Kulbinder Kaur Dosanjh als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Robert Leonard French als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Alan Buchanan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2011 bis 31. Dez. 2010

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Kulbinder Dosanjh am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Beschlüsse

    Resolutions
    29 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ADAMS, Courtney Kate
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Sekretär
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    182727730001
    FLEMING, Andrew Ian
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    United KingdomBritish182722200001
    FRENCH, Robert Leonard
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    PO BOX 365
    Speedbird Way
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United Kingdom
    EnglandBritish102273970001
    WILLIAMS, Keith
    Waterside
    PO BOX 365, Harmondsworth
    UB7 0GB West Drayton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Waterside
    PO BOX 365, Harmondsworth
    UB7 0GB West Drayton
    Middlesex
    United KingdomBritish62266660002
    BUCHANAN, Alan Kerr
    PO BOX 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    Sekretär
    PO BOX 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    British140989190001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Waterside
    P O Box 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    British Airways Plc
    England
    Sekretär
    Waterside
    P O Box 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    British Airways Plc
    England
    British231199720001
    JARVIS, Paul Henry
    Foxdale
    195 Ambleside Road
    GU18 5UW Lightwater
    Surrey
    Sekretär
    Foxdale
    195 Ambleside Road
    GU18 5UW Lightwater
    Surrey
    British11658650001
    BUCHANAN, Alan Kerr
    PO BOX 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    Geschäftsführer
    PO BOX 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    Waterside
    United KingdomBritish140989190001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Waterside
    P O Box 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    British Airways Plc
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Waterside
    P O Box 365
    UB7 0GB Harmondsworth
    British Airways Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish231199720001
    REDWOOD, Gail Felicity
    Herreway
    Finchampstead Ridges
    RG40 3SU Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Herreway
    Finchampstead Ridges
    RG40 3SU Wokingham
    Berkshire
    British7366140005
    WALSH, Stephen John
    4 Leinster Avenue
    SW14 7JP London
    Geschäftsführer
    4 Leinster Avenue
    SW14 7JP London
    British19349300002

    Hat BRITISH CALEDONIAN AIRWAYS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First fixed charge on rebates of rental
    Erstellt am 12. Nov. 1987
    Geliefert am 16. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of a sub lease of even date
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all and any monies.
    Berechtigte Personen
    • Nissho Iwai Corporation and Five Other Companies.
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    An assignment of insurances
    Erstellt am 03. Sept. 1987
    Geliefert am 12. Sept. 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a conditional sale agreement dated 3/9/87 a works completion agreement dated 3/9/87 and a purchase agreement novation dated 9/9/87
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to all the plicies of insurance in respect of loss or damage to the boeing model 747 2D313 aircraft with the manufacturers serial no 22579 serial letters GC17B.
    Berechtigte Personen
    • Japan Leasing (Europe) Limited
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    Fixed charge on deposit
    Erstellt am 05. Aug. 1987
    Geliefert am 10. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All expenses whatsoever incurred in or about or incidental to the recovery to the accounts forming the security fund and the exercise of any of nissho iwai corporations powers thereunder and all moneys due or to become due from the company to nissho iawai corporation, showa leasing company limited. Nichimen corporation, tokyo leasing company limited, kyodo leasing company limited under the terms of a sub underlease dated 5/8/87
    Kurze Angaben
    All the mortgagers right, title and interest in and to the security fund, details below grindlays bank minerva house, po box 7 montago close, london, SE1 9DH account no 8629028-102 amount £5,000,000 period 23/4/87 to 20/10/87 standard chartered bank, 37 gracechurch street, london account no 030989665.01 amount £3,500,000 period 23.4.87 to 20.10.87 and bank as above account no 03-098966502 amount £306,415.52 period as above.
    Berechtigte Personen
    • Kyodo Leasing Co LTD
    • Showa Leasing Co. LTD
    • Mussho Iwai Corporationas Their Agent
    • Apollo Leasing Co LTD
    • Tokyo Leasing LTD
    • Mchimes Corporation
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    First fixed charge
    Erstellt am 05. Aug. 1987
    Geliefert am 10. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to nissho iwai corpoation as agent for itself and the companies named in the charge under the terms of a subunderlease dated 5/8/87
    Kurze Angaben
    All the companys rights title and interest in and to all monies payable by lombard facilities limited relating to the aircraft.
    Berechtigte Personen
    • Nissho Iwai Corporation as Their Agent
    • Leasing Company Limited
    • Showa Leasing Company Limited
    • Michimer Corpoation,
    • Tokyo Leasing Company Limited
    • Kyodo Leasing Company Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    Assignment of insurances
    Erstellt am 18. März 1987
    Geliefert am 31. Mai 1987
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargees under the terms of a conditional sale agreement, a works completion agreement and a purchase agreement novation all dated 18/3/87
    Kurze Angaben
    All the right title and interest of bcal in and to all policies of insurance taken out pursuant to the conditional sale agreement clause 13/02 and in respect of loss or damage of the boeing with manufacturers. Serail no 21517.
    Berechtigte Personen
    • Marubeni UK PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    Sub lease
    Erstellt am 05. Dez. 1986
    Geliefert am 23. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to the sub lease dated 5/12/86
    Kurze Angaben
    Assignment by way of security all its right and title to and interest in any proceeds of the insurance on a total loss.
    Berechtigte Personen
    • Mitsui and Company Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    An agreement
    Erstellt am 09. Apr. 1986
    Geliefert am 21. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under or pursuant to the loan agreement dated 19/3/84 and/or the security documents and/or the charge.
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in the debt represented by the deposit.ct of the aircraft please see doc M44(see doc M444).
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 26. März 1986
    Geliefert am 04. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of a lease agreement dated 26/3/86
    Kurze Angaben
    The right title and interest in and to all policies and contracts of insurance in respect of the aircraft please see doc M443.
    Berechtigte Personen
    • Mitsubishi Corporation
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 31. Okt. 1985
    Geliefert am 20. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under a lease agreement dated 20/12/85 and a back up agreement dated 20/12/85
    Kurze Angaben
    All the companys right title and interest in and to all policies and contracts of insurance and all benefits thereof. All proceeds sue 20/12/85 in respect of one mcdonnell douglas DC10-30 aircraft, man-serial no 46921 UK nationality and regmark g-bebm including any of the three gen electric CF6 50C2 engines and any other engines. All applicances, accessories or other equipment and records, logs, manuals on other docs see doc M433.
    Berechtigte Personen
    • Midland Montagu Leasing Limited
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 31. Okt. 1985
    Geliefert am 20. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under ther termsof a lease agreement dated 31/10/85
    Kurze Angaben
    An assignment by way of first fixed charge to nordic of all bcal`s right title and interest in and to all policies and contracts of insurance. All proceeds due and to become due thereunder in respect of the whole or part of one mcdonnell douglas DC10-30 aircraft with serial no 46921 and reg mark g-bebmthree general electric CF6 50C2 engines (serial numbers 517,727,455,738 and 455,258 respectively) (see doc M429).
    Berechtigte Personen
    • Nordic Finance Nederland Bvc
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Security assignment
    Erstellt am 29. Okt. 1985
    Geliefert am 07. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 29/10/85 and the ancillarty agreements
    Kurze Angaben
    All of bcal's rights, title, benefit and interest, in and under the lease, including all moneys whatsoever payalbe see doc M432.
    Berechtigte Personen
    • Chemco Equipment Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Facility agreement
    Erstellt am 29. Okt. 1985
    Geliefert am 07. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee on any acccount whatsoever
    Kurze Angaben
    All of bcal's rights, title, benefit and interest, in and under the lease, including all moneys whatsoever payable (see doc M431) pursuant to the facility agreement.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Bank and Chemco Equipment Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Security assignment
    Erstellt am 29. Okt. 1985
    Geliefert am 07. Nov. 1985
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of a facility agreement dated 29/10/85 and the ancillary agreements.
    Kurze Angaben
    All bcal`s rights, title, benefit and intersest in and under the lease, including all moneys whatsoever payable.(see doc M426).
    Berechtigte Personen
    • Chemical Bank
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Deed of agreement
    Erstellt am 29. März 1985
    Geliefert am 19. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease agreement dated 29/3/85
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all policies and contracts of insurance please see doc M426.
    Berechtigte Personen
    • Midland Montagu Leasing (B) Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 29. März 1985
    Geliefert am 19. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from marubeni corporation and mitsui and company limited under the terms of the lease agreements dated 29.03.85 to the chargee.
    Kurze Angaben
    Fixed charge of all bcals right title and interest in and to all policies and contracts of insurance taken out by bcal and all benefits thereof and all proceeds dye tgereybder please see doc M425.
    Berechtigte Personen
    • Lunar Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 1985
    Geliefert am 30. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a credit agreement dated 28/1/85 and the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north and south side of church road gatwick airport, crawley, west sussex. Title no wsx 58762 land and buildings at gatwick airport, crawley, west sussex title no wsx 2121 wsx 2122 wsx 2123 wsx 18407 together with all buildings fixed plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    • Standard Chartered Bank
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee)
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 28. Jan. 1985
    Geliefert am 30. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee pursuant to a credit agreement dated 28/01/85
    Kurze Angaben
    Floating charge and fixed charge over all book and other debts now and from time to time owing (see doc M423).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • Standard Charrtered Bank Lloyds Bank PLC
    • National Westminster Bank PLC
    • Lloyds Bank PLC (As Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Amending agreement
    Erstellt am 07. Sept. 1984
    Geliefert am 25. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Three accounts of the company with the royal bank of canada (at its branch at 6 lothbury, london EC2) and called respectively "b cal/mcalpine sterling security deposit account nos 229,234 and 238 (see doc M422).
    Berechtigte Personen
    • Mcalpine Air Services Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Deposit agreement
    Erstellt am 07. Sept. 1984
    Geliefert am 17. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in and to the account referred to in the deposit agreement as "the deposit account" and all moneys from time to time standing to the credit of such account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Sale and purchase agreement
    Erstellt am 08. Mai 1984
    Geliefert am 11. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the charge a conditional sale agreement dated 8/5/84 and a loan agreement dated 8/5/84
    Kurze Angaben
    Five bac 1-11 series 500 aircraft and 10 rolls royce spey S11-14 engines plus any other replacement engines. All appliances, spare parts, instruments accessories and other equipment plus any replacements for the above items. All records, logs, manuals and other documents registration and serial nos as follows reg mark serial no engine serig-awyr 174 7724/7731 g-awys 175 7776/7812 g-awyt 176 7737/7720 g/awyu 177 7841/7717 g-axjk 191 7751/7757.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America Nt and Sa and National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Sale and purchase agreement
    Erstellt am 08. Mai 1984
    Geliefert am 11. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the charge, a conditional sale agreement dated 08/05/84 and aloan agreement dated 8/5/84
    Kurze Angaben
    Bac 1-11 series 500 aircraft UK reg mark g-axjm manufacturers serial no 214 to 2 rolls royce plcs relating to each leasespey S11-14 engines serial nos 7768 and 7723 together with any other replacement, engines, all appliances, spare parts, instruments, accessories and other equipment plus any replacements for the above items all records, logs, manuals and other doc(see doc M419.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International Limited(As Agent for the Banks Trustee for Itself)
    Transaktionen
    • 11. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Deed of mortgage
    Erstellt am 21. März 1984
    Geliefert am 29. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the loan agreement dated 19.3.84, the security docs (as defined) and the deed of indemnity dated 19.3.84 or otherwise by virtue of payments made under the first loss guarantee or the engines guarantee or any sums recovered under the guarantee charge (all as defined in the loan agreement)
    Kurze Angaben
    First fixed charge over airbus industrie a 310 - 200 aircraft s no 306 UK nationality rg no g -bkwu engines S.no 585-159, 585-160 the insuranses, the registration compensation &- all moneys which shall become payable in respect thereof, & the airframe waranties (please see schedule attached to doc M417).
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International Limited(As Agent for the Banks)
    Transaktionen
    • 29. März 1984Registrierung einer Belastung
    Deed of mortgage
    Erstellt am 21. März 1984
    Geliefert am 29. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the loan agreement dated 19/03/84 and for the security documents (as defined in the loan agreement) and all costs, charges & expenses incurred by the chargees in the cash charge & in recovering monies payable by the co under the financing documents (as defined in the loan agreement)
    Kurze Angaben
    First fixed charge over airbus industrie A310-200 aircraft sno 306 UK nationality reg no g-bkwu engins s no 585-159,585-160 the insurances, the requisition compensation and all moneys which shall become payable in respect thereof, and the airframe warranties. (Please see schedule attached to doc M415.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International LTD (As Agent for the Banks)
    Transaktionen
    • 29. März 1984Registrierung einer Belastung
    Deed of mortgage
    Erstellt am 20. März 1984
    Geliefert am 30. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of the indemnity and the loan agreement both dated 19/03/84
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right and title to and interes in the engines general electric CF6/80 the insurances relating to the above engines. The benefit of all powers and remedies for enforcing same, all monies which shall become payable thereunder (see doc M418).
    Berechtigte Personen
    • Mtu Motore and Turbinen Union Ulunchen Gmbh
    • General Elctric Company
    • Societe Nationale D`Etude Et De Construction De Moteurs D`Aviation
    • Airbus Industrie,
    Transaktionen
    • 30. März 1984Registrierung einer Belastung
    Deed of mortgage
    Erstellt am 20. März 1984
    Geliefert am 29. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the loan agreement dated 19.3.84 and.or the security documents (as defined in the loan agreement)
    Kurze Angaben
    Fist fixed charge over the engines general elctric CF6-80, the engine warranties, the insurances relating to each leased aircraft, all moneys which shall become payable thereunder which sahll become p(please see schedule attached to doc M416).
    Berechtigte Personen
    • Bank of America International Limited(As Agent for the Banks)
    Transaktionen
    • 29. März 1984Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0