CHAS.ROSE & CO.LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHAS.ROSE & CO.LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00235418 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2020
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 79 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 24. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 002354180010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF zum Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE am 08. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Punch Taverns (Rh) Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francesca Appleby als Sekretär am 29. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Geschäftsführer | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627400001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Sekretär | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175487970001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161623700001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Geschäftsführer | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| CONSTANTINE, Peter Anthony | Geschäftsführer | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 114160540001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| JONES, Bruce Abbott | Geschäftsführer | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | 29595900002 | ||||||
| KEMP, Deborah Jane | Geschäftsführer | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| TANNAHILL, David James | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 | |||||
| WHITEHEAD, Gordon William George | Geschäftsführer | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | 13507460001 | ||||||
| WILFORD, Nicholas James | Geschäftsführer | The Virgate Church Street Swepstone Coalville LE6 7SA Leicester Leicestershire | British | 33328990001 | ||||||
| WILKINSON, Anthony Eric | Geschäftsführer | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | 4656080002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHAS.ROSE & CO.LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29. Aug. 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Taverns (Rh) Limited | 06. Apr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHAS.ROSE & CO.LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. Okt. 2014 Geliefert am 15. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental deed of charge | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 08. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 08. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 28. Juni 2000 Geliefert am 15. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 05. Okt. 1999 Geliefert am 21. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1942 Geliefert am 13. Mai 1942 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3000 | |
Kurze Angaben Central hotel castle road scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge (supplemental to legal charge dated 7TH jany 1929 for securing all moneys due etc to barclays bank LTD) | Erstellt am 26. März 1941 Geliefert am 06. Apr. 1941 | Vollständig erfüllt | ||
Kurze Angaben Land and the tennyson arms dean road scarborough yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 07. Jan. 1929 Geliefert am 12. Jan. 1929 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys etc. | |
Kurze Angaben Brewery and premises in castlegate malton york the nags head inn and no 28 oxford st scarborough the borough arms and 11 union st and 23 and 24 bedford st scarborough the black swan inn no 25 queen st scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Dez. 1928 Geliefert am 04. Jan. 1929 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2100 | |
Kurze Angaben Inn hotel & premises in wheelgate malton york golden lion inn premises 3 cottages lana in great borugh york. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0