SERCO LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SERCO LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00242246 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SERCO LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
- Allgemeine öffentliche Verwaltung (84110) / öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Sozialversicherung
Wo befindet sich SERCO LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SERCO LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
R.C.A.LIMITED | 10. Sept. 1929 | 10. Sept. 1929 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERCO LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SERCO LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Juni 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 29. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Juni 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für SERCO LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Serco House 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way Hook Hampshire RG27 9UY verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 43 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Verschiedenes The accounts have been removed as it was processed on the wrong company record. The accounts are now on the correct company record of 02048608 serco group PLC | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Ernennung von Nickesha Graham-Burrell als Sekretär am 15. Sept. 2023 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Charles Eveleigh als Sekretär am 15. Sept. 2023 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 80 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Anthony Andrew Kirby am 01. Juni 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Winston Irwin als Geschäftsführer am 01. Jan. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Helen Shaw als Direktor am 01. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 101 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David Charles Eveleigh als Sekretär am 25. Juni 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart John Haydon als Sekretär am 25. Juni 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Stuart John Haydon als Sekretär am 08. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Serco Corporate Services Limited als Sekretär am 08. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 98 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nazim Girnary als Direktor am 14. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Winston Irwin als Direktor am 14. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Crossley als Geschäftsführer am 14. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin David Craven als Geschäftsführer am 14. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von SERCO LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM-BURRELL, Nickesha | Sekretär | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | 313952930001 | |||||||||||
GIRNARY, Nazim | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | United Kingdom | British | Director | 282413400001 | ||||||||
KIRBY, Anthony Andrew | Geschäftsführer | 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9UY Hook Serco House Hampshire United Kingdom | England | British | Company Director | 261213120002 | ||||||||
SHAW, Helen | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | England | British | Chief Financial Officer | 299920070002 | ||||||||
BRYAN, Everton | Sekretär | 1 Hartland Close Elmscott Gardens Winchmore Hill N21 2BG London | British | Company Director | 70901650001 | |||||||||
CLEMENT, Thomas | Sekretär | 31 Wester Links IV10 8RZ Fortrose Ross Shire | British | Accountant | 633700001 | |||||||||
EVELEIGH, David Charles | Sekretär | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | 297823970001 | |||||||||||
HAYDON, Stuart John | Sekretär | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | 288681900001 | |||||||||||
ILAN, Ronen | Sekretär | 1 Saint Andrews Drive HA7 2LY Stanmore Middlesex | British | 60757970003 | ||||||||||
MCGREGOR-SMITH, Ruby | Sekretär | 84 Harvest Road Englefield Green TW20 0QR Egham Surrey | British | Finance Director | 39857280001 | |||||||||
ROBSON, Alan Lewis | Sekretär | 134 The Avenue TW16 5EA Sunbury On Thames Middlesex | British | 8210750001 | ||||||||||
TODD, Francesca Anne | Sekretär | 26 Glebe Road SM2 7NT Cheam Surrey | British | 72249980001 | ||||||||||
WELLMAN, Glenys | Sekretär | 112 Walsall Road Aldridge WS9 0JW Walsall West Midlands | British | Director | 103599160001 | |||||||||
SERCO CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9UY Hook Serco House Hampshire United Kingdom |
| 115435410002 | ||||||||||
ADAMS, Lucy Kate Germanda | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | British | Hr Director | 99063720003 | |||||||||
ASTON, Leslie Harvey | Geschäftsführer | Farthings 32 Mill Road MK44 1NX Sharnbrook Bedfordshire | British | Company Director | 33887700001 | |||||||||
BARTON, Clive Stephen | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | British | Marketing Director | 147088640001 | |||||||||
BARTON, Clive Stephen | Geschäftsführer | Garsby House 110 Rickmonsworth Lane SL9 7NT Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | Marketing Director | 68603390002 | |||||||||
BEESTON, Kevin Stanley | Geschäftsführer | Serco House 16bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | British | Company Director | 45842770004 | |||||||||
BEESTON, Kevin Stanley | Geschäftsführer | 4 Millfield TW16 7HL Sunbury On Thames Middlesex | British | Company Director | 45842770002 | |||||||||
BENISON, Elizabeth Michelle | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | England | British | General Management | 283639230001 | ||||||||
BROWN, Michael Peter | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | Director | 74096230003 | ||||||||
BROWN, Nicholas James Forster | Geschäftsführer | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | Director | 111996870002 | ||||||||
BRYAN, Everton | Geschäftsführer | 1 Hartland Close Elmscott Gardens Winchmore Hill N21 2BG London | British | Company Director | 70901650001 | |||||||||
BRYAN, Everton | Geschäftsführer | 1 Hartland Close Elmscott Gardens Winchmore Hill N21 2BG London | British | Company Director | 70901650001 | |||||||||
BRYDEN, Gordon | Geschäftsführer | 28 Pirbright Road GU14 7AD Farnborough Hampshire | British | Company Director | 53913100001 | |||||||||
CASEY, Peter Anthony | Geschäftsführer | No 6 Hotcham Grange Hill Farm Road SL6 0SD Taplow Berks | British | Company Director | 29543230001 | |||||||||
CAVANAGH, Julia Naomi | Geschäftsführer | 27 Langdon Park TW11 9PR Teddington Middlesex | British | Chartered Accountant | 58204140006 | |||||||||
CLEMENT, Thomas | Geschäftsführer | 31 Wester Links IV10 8RZ Fortrose Ross Shire | British | Accountant | 633700001 | |||||||||
CORNWELL, Anthony Bruce | Geschäftsführer | The Cottage 134 London Road GU19 5BZ Bagshot Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 3471920001 | ||||||||
CRAVEN, Kevin David | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | England | British | Ceo Uk Central Government Division | 194869650001 | ||||||||
CRAWSHAW, Andrew | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | United Kingdom | British | Director | 133479600001 | ||||||||
CROSSLEY, Nigel | Geschäftsführer | Serco House 16 Bartley Wood Business Park RG27 9UY Bartley Way Hook Hampshire | England | British | Financial Controller | 145901880001 | ||||||||
CUTHILL, Stephen Michael | Geschäftsführer | Rye Cottage Tunworth Road RG25 2LU Mapledurwell Hampshire | British | Director | 126687240001 | |||||||||
DIXON, Josephine | Geschäftsführer | Hotspur House Allendale NE47 9BW Northumberland | United Kingdom | British | Company Director | 148347760001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SERCO LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serco Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9UY Hook Serco House Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SERCO LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 14. Sept. 2012 Geliefert am 28. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £40,218.75 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All of the companys interest in an interest earning deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 14. Sept. 2012 Geliefert am 28. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag 13,406.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All of the companys interest in an interest earning deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Sept. 2012 Geliefert am 28. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag 31,250.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All of the companys interest in an interest earning deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Sept. 2012 Geliefert am 26. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £58,750.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All of the company's interest in an interest earning deposit account opened at the royal bank of scotland PLC in which the deposit sum has been placed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 05. März 2010 Geliefert am 12. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The amount from time to time held in the deposit account pursuant to the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An assignment of maintenance programmes | Erstellt am 20. Okt. 2009 Geliefert am 09. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assignor assigned and agreed to assign with full title guarantee absolutely to the assignee as a continuing security for the discharge on demand of the secured obliations all the assignor's right title benefit and interest in and to the assigned contracts including without limitation all sums payable thereunder see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of insurances and requisition proceeds | Erstellt am 17. Juni 2008 Geliefert am 19. Juni 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the assigned property being the assigned insurance property and the assigned requisition property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of insurances and requisition proceeds | Erstellt am 28. Apr. 2008 Geliefert am 12. Mai 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assigned property being the assigned insurance property and the assigned requisition property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Tenancy agreement | Erstellt am 25. Juli 2006 Geliefert am 15. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The interest in the deposited sum and the interest earned thereon and all money from time to time appropriated by breckland district council. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Tenancy agreement dated 25 july 2006 and | Erstellt am 25. Juli 2006 Geliefert am 15. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company's interest in the "deposited sum" and all money from time to time appropriated by breckland district council. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Stock charge | Erstellt am 07. März 2006 Geliefert am 14. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge all stocks both present and future from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of contracts | Erstellt am 27. März 2001 Geliefert am 30. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies whatsoever due or to become due from the company and tis to the secured beneficiaries (as defined) in respect of the banks' financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben The assigned assets (as defined) with all beneficial interests thereunder and any proceeds of sale or other realisation of such property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 22. Mai 2000 Geliefert am 25. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,500.00 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £2,500. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Subordinated deed of charge | Erstellt am 07. Nov. 1996 Geliefert am 27. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lowdham grange prison services limited to the chargee as security trustee for the finance parties under each or any of the financing agreements (as defined) and all other monies due in any manner whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the securities specified in the initial schedule the certificate or other documents of title. Such other securities in lgps as shall be specified in an additional schedule all other securities in lgps and all distributions and all securities rights moneys or property of whatsoever nature. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over shares and securities | Erstellt am 07. Nov. 1996 Geliefert am 14. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All documents of title and securities,rights and moneys thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 16. Nov. 1993 Geliefert am 03. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Jan. 1987 Geliefert am 16. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or dealmove PLC. To the chaargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0