SERCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSERCO LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00242246
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SERCO LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
    • Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
    • Andere Forschung und experimentelle Entwicklung in Naturwissenschaften und Ingenieurwesen (72190) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
    • Allgemeine öffentliche Verwaltung (84110) / öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Sozialversicherung

    Wo befindet sich SERCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SERCO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    R.C.A.LIMITED10. Sept. 192910. Sept. 1929

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SERCO LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für SERCO LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis15. Juni 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung29. Juni 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis15. Juni 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für SERCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Serco House 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way Hook Hampshire RG27 9UY verlegt

    1 SeitenAD04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    43 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2024 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Verschiedenes

    The accounts have been removed as it was processed on the wrong company record. The accounts are now on the correct company record of 02048608 serco group PLC
    1 SeitenMISC

    Ernennung von Nickesha Graham-Burrell als Sekretär am 15. Sept. 2023

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von David Charles Eveleigh als Sekretär am 15. Sept. 2023

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    80 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Anthony Andrew Kirby am 01. Juni 2021

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Mark Winston Irwin als Geschäftsführer am 01. Jan. 2023

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Helen Shaw als Direktor am 01. Jan. 2023

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    101 SeitenAA

    Ernennung von Mr David Charles Eveleigh als Sekretär am 25. Juni 2022

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stuart John Haydon als Sekretär am 25. Juni 2022

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company documents/company business 14/12/2021
    RES13

    Ernennung von Mr Stuart John Haydon als Sekretär am 08. Okt. 2021

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Serco Corporate Services Limited als Sekretär am 08. Okt. 2021

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    98 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Nazim Girnary als Direktor am 14. Apr. 2021

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mark Winston Irwin als Direktor am 14. Apr. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Crossley als Geschäftsführer am 14. Apr. 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kevin David Craven als Geschäftsführer am 14. Apr. 2021

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re-facility agreement 23/02/2021
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von SERCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRAHAM-BURRELL, Nickesha
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    313952930001
    GIRNARY, Nazim
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector282413400001
    KIRBY, Anthony Andrew
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director261213120002
    SHAW, Helen
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    EnglandBritishChief Financial Officer299920070002
    BRYAN, Everton
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    Sekretär
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    BritishCompany Director70901650001
    CLEMENT, Thomas
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    Sekretär
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    BritishAccountant633700001
    EVELEIGH, David Charles
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    297823970001
    HAYDON, Stuart John
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Sekretär
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    288681900001
    ILAN, Ronen
    1 Saint Andrews Drive
    HA7 2LY Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    1 Saint Andrews Drive
    HA7 2LY Stanmore
    Middlesex
    British60757970003
    MCGREGOR-SMITH, Ruby
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    Sekretär
    84 Harvest Road
    Englefield Green
    TW20 0QR Egham
    Surrey
    BritishFinance Director39857280001
    ROBSON, Alan Lewis
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    Sekretär
    134 The Avenue
    TW16 5EA Sunbury On Thames
    Middlesex
    British8210750001
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Sekretär
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    WELLMAN, Glenys
    112 Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0JW Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    112 Walsall Road
    Aldridge
    WS9 0JW Walsall
    West Midlands
    BritishDirector103599160001
    SERCO CORPORATE SERVICES LIMITED
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer04007730
    115435410002
    ADAMS, Lucy Kate Germanda
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    BritishHr Director99063720003
    ASTON, Leslie Harvey
    Farthings
    32 Mill Road
    MK44 1NX Sharnbrook
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Farthings
    32 Mill Road
    MK44 1NX Sharnbrook
    Bedfordshire
    BritishCompany Director33887700001
    BARTON, Clive Stephen
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    BritishMarketing Director147088640001
    BARTON, Clive Stephen
    Garsby House
    110 Rickmonsworth Lane
    SL9 7NT Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Garsby House
    110 Rickmonsworth Lane
    SL9 7NT Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishMarketing Director68603390002
    BEESTON, Kevin Stanley
    Serco House
    16bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    BritishCompany Director45842770004
    BEESTON, Kevin Stanley
    4 Millfield
    TW16 7HL Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 Millfield
    TW16 7HL Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishCompany Director45842770002
    BENISON, Elizabeth Michelle
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    EnglandBritishGeneral Management283639230001
    BROWN, Michael Peter
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector74096230003
    BROWN, Nicholas James Forster
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector111996870002
    BRYAN, Everton
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    Geschäftsführer
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    BritishCompany Director70901650001
    BRYAN, Everton
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    Geschäftsführer
    1 Hartland Close
    Elmscott Gardens Winchmore Hill
    N21 2BG London
    BritishCompany Director70901650001
    BRYDEN, Gordon
    28 Pirbright Road
    GU14 7AD Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    28 Pirbright Road
    GU14 7AD Farnborough
    Hampshire
    BritishCompany Director53913100001
    CASEY, Peter Anthony
    No 6 Hotcham Grange
    Hill Farm Road
    SL6 0SD Taplow
    Berks
    Geschäftsführer
    No 6 Hotcham Grange
    Hill Farm Road
    SL6 0SD Taplow
    Berks
    BritishCompany Director29543230001
    CAVANAGH, Julia Naomi
    27 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    27 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    BritishChartered Accountant58204140006
    CLEMENT, Thomas
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    Geschäftsführer
    31 Wester Links
    IV10 8RZ Fortrose
    Ross Shire
    BritishAccountant633700001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director3471920001
    CRAVEN, Kevin David
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    EnglandBritishCeo Uk Central Government Division194869650001
    CRAWSHAW, Andrew
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector133479600001
    CROSSLEY, Nigel
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Serco House
    16 Bartley Wood Business Park
    RG27 9UY Bartley Way Hook
    Hampshire
    EnglandBritishFinancial Controller145901880001
    CUTHILL, Stephen Michael
    Rye Cottage
    Tunworth Road
    RG25 2LU Mapledurwell
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Rye Cottage
    Tunworth Road
    RG25 2LU Mapledurwell
    Hampshire
    BritishDirector126687240001
    DIXON, Josephine
    Hotspur House
    Allendale
    NE47 9BW Northumberland
    Geschäftsführer
    Hotspur House
    Allendale
    NE47 9BW Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director148347760001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SERCO LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3970268
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SERCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Sept. 2012
    Geliefert am 28. Sept. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £40,218.75 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All of the companys interest in an interest earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Cosmopolitan Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Sept. 2012
    Geliefert am 28. Sept. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    13,406.25 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All of the companys interest in an interest earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Cosmopolitan Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Sept. 2012
    Geliefert am 28. Sept. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    31,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All of the companys interest in an interest earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Cosmopolitan Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 07. Sept. 2012
    Geliefert am 26. Sept. 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £58,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All of the company's interest in an interest earning deposit account opened at the royal bank of scotland PLC in which the deposit sum has been placed.
    Berechtigte Personen
    • Cosmopolitan Housing Association Limited
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. März 2010
    Geliefert am 12. März 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The amount from time to time held in the deposit account pursuant to the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Max Office Gp Limited
    Transaktionen
    • 12. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An assignment of maintenance programmes
    Erstellt am 20. Okt. 2009
    Geliefert am 09. Nov. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assignor assigned and agreed to assign with full title guarantee absolutely to the assignee as a continuing security for the discharge on demand of the secured obliations all the assignor's right title benefit and interest in and to the assigned contracts including without limitation all sums payable thereunder see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Leasing (No. 6) Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Assignment of insurances and requisition proceeds
    Erstellt am 17. Juni 2008
    Geliefert am 19. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the assigned property being the assigned insurance property and the assigned requisition property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banc of America Leasing & Capital, Llc
    Transaktionen
    • 19. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2013Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Assignment of insurances and requisition proceeds
    Erstellt am 28. Apr. 2008
    Geliefert am 12. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assigned property being the assigned insurance property and the assigned requisition property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banc of America Leasing & Capital Llc
    Transaktionen
    • 12. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Apr. 2013Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    Tenancy agreement
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 15. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The interest in the deposited sum and the interest earned thereon and all money from time to time appropriated by breckland district council.
    Berechtigte Personen
    • Breckland District Council
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Tenancy agreement dated 25 july 2006 and
    Erstellt am 25. Juli 2006
    Geliefert am 15. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's interest in the "deposited sum" and all money from time to time appropriated by breckland district council. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Breckland District Council
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Stock charge
    Erstellt am 07. März 2006
    Geliefert am 14. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all stocks both present and future from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Docklands Light Railway Limited
    Transaktionen
    • 14. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of contracts
    Erstellt am 27. März 2001
    Geliefert am 30. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies whatsoever due or to become due from the company and tis to the secured beneficiaries (as defined) in respect of the banks' financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The assigned assets (as defined) with all beneficial interests thereunder and any proceeds of sale or other realisation of such property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale,London Branch,as Security Trustee Forthe Secured Beneficiaries
    Transaktionen
    • 30. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Mai 2000
    Geliefert am 25. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,500.00 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    £2,500.
    Berechtigte Personen
    • Trevor Amos Blaber and Jennifer Lindsay Blaber
    Transaktionen
    • 25. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Subordinated deed of charge
    Erstellt am 07. Nov. 1996
    Geliefert am 27. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from lowdham grange prison services limited to the chargee as security trustee for the finance parties under each or any of the financing agreements (as defined) and all other monies due in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the securities specified in the initial schedule the certificate or other documents of title. Such other securities in lgps as shall be specified in an additional schedule all other securities in lgps and all distributions and all securities rights moneys or property of whatsoever nature.
    Berechtigte Personen
    • Serco Limited
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over shares and securities
    Erstellt am 07. Nov. 1996
    Geliefert am 14. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All documents of title and securities,rights and moneys thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1993
    Geliefert am 03. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Jan. 1987
    Geliefert am 16. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or dealmove PLC. To the chaargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    • 19. Dez. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0