TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00244045 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRIMDON MOTOR SERVICES,LIMITED | 30. Nov. 1929 | 30. Nov. 1929 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Mai 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Turner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Paul Turner am 30. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 30. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 30. Juli 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | 161250030001 | |||||
| LAUCHT, Robert Ian | Sekretär | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | British | 13774020001 | ||||||
| RICHARDS, Lewis | Sekretär | 16 Dove House Lane B91 2EX Solihull West Midlands | British | 2452070001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| WATSON, Kenneth James | Sekretär | 1 Portsmouth Place DL1 2XH Darlington County Durham | British | 29509590001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| GRACE, David Martin | Geschäftsführer | Woodhouse Back Lane Woolley WF4 2JT Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 27031320002 | |||||
| HODGSON, Gordon William | Geschäftsführer | Bramble House Easington Lane DH5 0QX Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 1108360001 | ||||||
| HODGSON, Kenneth | Geschäftsführer | The Grange Church Lane Elvington YO41 4HD York | United Kingdom | British | 9946200002 | |||||
| HUNTER, Michael John | Geschäftsführer | 100 Manygates Lane Sandal WF2 7DP Wakefield West Yorkshire | British | 1058260002 | ||||||
| KERSLAKE, Brian John | Geschäftsführer | Oaklands Coppenhall ST18 9BW Stafford Staffordshire | British | 34169610003 | ||||||
| LAUCHT, Robert Ian | Geschäftsführer | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | United Kingdom | British | 13774020001 | |||||
| LEEDER, David John | Geschäftsführer | 3 Juniper House 140 Narrow Street E14 8BP London | England | British | 110562870001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| SPINKS, Stanley | Geschäftsführer | 7 Fulthorpe Avenue DL3 9PU Darlington County Durham | British | 9946180001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| TURNER, David Paul | Geschäftsführer | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| WHITE, Philip Michael | Geschäftsführer | 25 Viceroy Close Bristol Road B5 7UR Birmingham West Midlands | British | 5721830002 | ||||||
| WIDMER, Michael Scott | Geschäftsführer | Stone Mole House Low Street, Leeming Bar DL7 9LU Northallerton North Yorkshire | British | 64205870001 | ||||||
| WOOLNER, Andrew Edward | Geschäftsführer | Green Farm Back Lane Shustoke B46 2AP Coleshill Warwickshire | British | 45409730001 |
Hat TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1995 Geliefert am 10. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Nov. 1993 Geliefert am 17. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. März 1990 Geliefert am 05. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Trindon f/h depot garage,county durham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 23. März 1990 Geliefert am 23. März 1990 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 23. März 1990 Geliefert am 29. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 1989 Geliefert am 28. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The old neele premises, boat house lane stockton-on-tees, cleveland t/n CE96794. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Juli 1988 Geliefert am 05. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Feb. 1988 Geliefert am 26. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H and singular the chattels, plant machinery aznd items described on the reverse of the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 24. Feb. 1988 Geliefert am 26. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H and singular the chattels, plant machinery and items described on the reverse of the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 10. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 25. Nov. 1985 Geliefert am 16. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Okt. 1984 Geliefert am 09. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Jan. 1984 Geliefert am 16. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TEESSIDE MOTOR SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0