LEON FRENKEL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LEON FRENKEL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00246315 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEON FRENKEL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LEON FRENKEL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEON FRENKEL LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEON FRENKEL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Cameron John Mackintosh als Geschäftsführer am 28. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. März 2024
| 6 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Cameron John Mackintosh als Direktor am 05. März 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen David Cardall als Direktor am 23. Feb. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tatsuo Okura als Geschäftsführer am 23. Feb. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen David Cardall als Sekretär am 23. Feb. 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tatsuo Okura als Sekretär am 23. Feb. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Tatsuo Okura als Sekretär am 01. Apr. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Tatsuo Okura als Direktor am 01. Apr. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kazuhito Suematsu als Geschäftsführer am 01. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kazuhito Suematsu als Sekretär am 01. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEON FRENKEL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDALL, Stephen David | Sekretär | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | 319757080001 | |||||||
CARDALL, Stephen David | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 228519590001 | ||||
FILMER, Stephen Thomas | Sekretär | 41 Lombardy Drive Woodlands ME14 5TB Maidstone Kent | British | 56857770001 | ||||||
FOSTER, Philip Joseph | Sekretär | 44 Brookfield Gardens L48 4EL Wirral Merseyside | British | 67861310001 | ||||||
ITO, Kazuo | Sekretär | Greenlands 35-37 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | Japanese | Company Director | 76001510002 | |||||
NARITA, Koichi | Sekretär | 80 Hazelwood Road SK9 2QA Wilmslow Cheshire | Japanese | Executive Director | 46902850002 | |||||
ODA, Manabu | Sekretär | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | Japanese | Director | 121331430003 | |||||
OKURA, Tatsuo | Sekretär | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | 294311380001 | |||||||
RIMMER, Thomas | Sekretär | Bassetts Cottage The Lane Fordcombe TN3 0RP Tunbridge Wells Kent | British | 12937680001 | ||||||
RIMMER, Thomas | Sekretär | Bassetts Cottage The Lane Fordcombe TN3 0RP Tunbridge Wells Kent | British | 12937680001 | ||||||
SUEMATSU, Kazuhito, Mr. | Sekretär | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | 245140080001 | |||||||
CAMPBELL, Colin Stephen | Geschäftsführer | 53 Mildmay Grove North N1 4PL London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 89866330001 | ||||
CRITCHLEY, Kenneth David | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | Company Director | 52787640001 | ||||
FRENKEL, Harold Leon | Geschäftsführer | Darenth Cottage 23 Chevering Road Chipstead Sevenoaks Kent | British | Director | 8597430001 | |||||
FRENKEL, Leona | Geschäftsführer | Bromley Court Hotel BR1 4JD Bromley Kent | British | Director | 7972670001 | |||||
FRENKEL, Richard Antony | Geschäftsführer | Flat A 65 Warwick Square SW1V 2AL London | United Kingdom | British | Director | 33204210001 | ||||
HARRISON, John David | Geschäftsführer | Greenside Cottage Lower Wyke Green Wyke BD12 9AD Bradford West Yorkshire | British | Director | 44234890001 | |||||
HUTCHESON, Ian Stuart | Geschäftsführer | The Bower Farm House Hever Road TN8 7LE Edenbridge Kent | British | Chairman | 13718760002 | |||||
ITO, Kazuo | Geschäftsführer | Greenlands 35-37 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | United Kingdom | Japanese | Company Director | 76001510002 | ||||
MACKINTOSH, Cameron John | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | England | British | Managing Director | 146972900001 | ||||
MANLEY, Stephen Brian | Geschäftsführer | Ightham Warren Ightham TN15 9AP Sevenoaks Kent | British | Company Director | 22567900003 | |||||
MUNDAY, Derek Frederick | Geschäftsführer | 57 Redhill Wood New Ash Green DA3 8QP Longfield Kent | British | Director | 8597410001 | |||||
MUTCH, John Ashton | Geschäftsführer | 94 Scarisbrick New Road PR8 6LQ Southport Merseyside | British | Company Director | 52787570001 | |||||
NARITA, Koichi | Geschäftsführer | 80 Hazelwood Road SK9 2QA Wilmslow Cheshire | Japanese | Executive Director | 46902850002 | |||||
ODA, Manabu | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | England | Japanese | Director | 121331430006 | ||||
OKURA, Tatsuo | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | England | Japanese | Director | 294308050001 | ||||
RIMMER, Thomas | Geschäftsführer | Bassetts Cottage The Lane Fordcombe TN3 0RP Tunbridge Wells Kent | England | British | Director | 12937680001 | ||||
SMITH, John Thomas | Geschäftsführer | 25 Vicarage Road Formby L37 1XT Liverpool Merseyside | British | Company Director | 59047700001 | |||||
SUEMATSU, Kazuhito | Geschäftsführer | Royal Liver Building Pier Head L3 1NX Liverpool Merseyside | England | Japanese | Director | 245135180001 | ||||
VARDON, Michael Edward | Geschäftsführer | 9 Orchard Rise TN3 9RU Groombridge Kent | British | Director | 50702880001 | |||||
WEIR, James | Geschäftsführer | 1 White Hart Wood TN13 1RR Sevenoaks Kent | British | Chartered Accountant | 54800830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEON FRENKEL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Princes Limited | 06. Apr. 2016 | Pier Head L3 1NX Liverpool Royal Liver Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LEON FRENKEL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 21. Sept. 2000 Geliefert am 27. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1996 Geliefert am 09. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Block 6, crabtree manorway, belvedere, l/b of bexley t/no: SGL568755. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Feb. 1988 Geliefert am 13. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings to the west side of crabtree manor way erith l/b of bexley T.n K47275 K31101 K31099 sgl 344326. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Okt. 1987 Geliefert am 11. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 1987 Geliefert am 04. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings to the west of crabtree manorway erith l/b of bexley t/ no K47275, K31101 K31099 sgl 344326. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Sept. 1987 Geliefert am 06. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Mai 1986 Geliefert am 07. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The companys undertaking all property and present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Jan. 1986 Geliefert am 05. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge f/h land situate and k/a land and buildings on the west side of crabtree manorway belvedere kent t/n 344326 all stocks shares or other securities (see doc M115 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Sept. 1985 Geliefert am 24. Sept. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H lands hereditaments and premises being land and buildings on the west side of crabtree manor way belvedere t/n sgl 344326. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 20. Apr. 1982 Geliefert am 21. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 15 mar 82 | |
Kurze Angaben Land at edgeworth gloucestershire title no gr 94 gr 270 gr 918 GR935 & gr 1024. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 08. Apr. 1960 Geliefert am 26. Apr. 1960 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben Land west of crabtree manor way erith kent title no K47275 together with all fittings present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 02. Mai 1951 Geliefert am 05. Mai 1951 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due etc | |
Kurze Angaben 31,39 and 33 hood avenue 85,72 and 145 parerest road (originally 9,62 and 63 sherwood road) 17 austin road 11 archer road all at st mary cray. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0