AFL REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAFL REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00246353
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AFL REALISATIONS LIMITED?

    • (2874) /

    Wo befindet sich AFL REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AFL REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARMSTRONG FASTENINGS LIMITED21. Juni 199021. Juni 1990
    ARMSTRONG PATENTS CO.LIMITED08. März 193008. März 1930

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AFL REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2005
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2006
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2004

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für AFL REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis04. Juni 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung18. Juni 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AFL REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für AFL REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Stephen Geoffrey Bailey als Sekretär am 24. Feb. 2010

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Patrick Dancaster als Geschäftsführer am 05. Juni 2015

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Geoffrey Bailey als Geschäftsführer am 24. Feb. 2010

    2 SeitenTM01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    6 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Juli 2009

    4 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009

    4 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    5 Seiten3.6

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    46 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed armstrong fastenings LIMITED\certificate issued on 22/05/06
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten405(1)

    Wer sind die Geschäftsführer von AFL REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Sekretär
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    British108203800001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Sekretär
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    GODWIN, Michael John
    8 Hartwell Grove
    ST16 1RW Stafford
    Staffordshire
    Sekretär
    8 Hartwell Grove
    ST16 1RW Stafford
    Staffordshire
    British6083440001
    GOODSHIP, Karen Lesley
    The Retreat
    6 Church Farm Mews Dosthill
    B77 1LU Tamworth
    Staffordshire
    Sekretär
    The Retreat
    6 Church Farm Mews Dosthill
    B77 1LU Tamworth
    Staffordshire
    British16697470002
    JONES, Kevin
    3 Quilter Close
    WV14 9AX Coseley
    West Midlands
    Sekretär
    3 Quilter Close
    WV14 9AX Coseley
    West Midlands
    British85295800001
    MILWARD, Roy Edward
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    British114078580001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Sekretär
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    STABLEFORD, Kevin William
    106 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    106 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British43235360003
    WARD, Elizabeth Katherine
    Thistledown House
    Cheltenham Road
    WR11 6LF Evesham
    Worcestershire
    Sekretär
    Thistledown House
    Cheltenham Road
    WR11 6LF Evesham
    Worcestershire
    British18385840002
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    EnglandBritish108203800001
    BIRDS, Kenneth Paul
    10 Maplewood
    ST17 4SG Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    10 Maplewood
    ST17 4SG Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish65859470001
    BUTLER, Richard Gareth John
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    EnglandBritish117859680001
    CLARKE, Ian Russell
    Kensington House
    Churchfields
    ST18 0HJ Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Kensington House
    Churchfields
    ST18 0HJ Stafford
    Staffordshire
    British104937880001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Geschäftsführer
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    DICKINSON, John Alan
    Monks Barn Maugersbury
    Stow On The Wold
    GL54 1HB Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Monks Barn Maugersbury
    Stow On The Wold
    GL54 1HB Cheltenham
    Gloucestershire
    British28823880003
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    GODWIN, Michael John
    8 Hartwell Grove
    ST16 1RW Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    8 Hartwell Grove
    ST16 1RW Stafford
    Staffordshire
    British6083440001
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    British12310490001
    HARLAND, Andrew David
    10 Clos Y Gwyddfid
    Morganstown
    CF15 8EX Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    10 Clos Y Gwyddfid
    Morganstown
    CF15 8EX Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish103589300001
    JONES, Kevin
    3 Quilter Close
    WV14 9AX Coseley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Quilter Close
    WV14 9AX Coseley
    West Midlands
    British85295800001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Geschäftsführer
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LYONS, Paul Anthony
    10 Drayson Lane
    NN6 7SR Crick
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    10 Drayson Lane
    NN6 7SR Crick
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72857310001
    MILWARD, Roy Edward
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish114078580001
    PARKER, Anthony Kenneth
    135 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    135 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British28823860001
    PAUL, Akash, The Honourable
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish49303360005
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PUNN, Gurinder
    84 Harborne Road
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    84 Harborne Road
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    British50699630002
    ROSS, John
    28 Longwood Rise
    WV12 4AX Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    28 Longwood Rise
    WV12 4AX Willenhall
    West Midlands
    English18966690001
    SHAW, Albert
    Robinshill Great Moor Road
    Pattingham
    WV6 7AU Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Robinshill Great Moor Road
    Pattingham
    WV6 7AU Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish58615920001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Geschäftsführer
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritish28831060001
    SHORE, Jack
    4 Westerham Close
    Knowle
    B93 9BU Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Westerham Close
    Knowle
    B93 9BU Solihull
    West Midlands
    British33670600001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    STABLEFORD, Kevin William
    106 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    106 Russell Bank Road
    Four Oaks
    B74 4RJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish43235360003
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10618480001
    WILLIAMS, Peter James
    26 New Walk
    HU17 7DJ Beverley
    North Humberside
    Geschäftsführer
    26 New Walk
    HU17 7DJ Beverley
    North Humberside
    British57964710001

    Hat AFL REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 09. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Caparo Group Limited
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 09. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the financing agreement
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge to a debenture dated 31ST january 1996
    Erstellt am 08. Sept. 1999
    Geliefert am 16. Sept. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them under or in connection with the finance documents and all sums and liabilities under or in connection with the hedging arrangements
    Kurze Angaben
    The l/h property interest in units 28 and 29 stoneferry park, foster street, kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 03. Sept. 1996
    Geliefert am 04. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents or (as the case may be) this charge
    Kurze Angaben
    The company charges the deposit being all sums from time to time standing to the credit of the designated account, and all entitlement to interest from time to time accruing to such sums, and the debt represented thereby.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1996
    Geliefert am 01. Feb. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the charge as agent and trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under the finance documents (as defined) and all sums and liabilities under or in connection with the hedging arrangments
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 1990
    Geliefert am 15. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 5.4.90 and a guarantee dated 5.4.90 and this charge
    Kurze Angaben
    1. l/h land & buildings north side of clough road kingston upon hull. 2. f/h land fronting great barr street, derby street lily crescent and ivy lane, t/n wm 77156 & f/h land forming part of the site of lily crescent t/n wk 125182.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 15. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 1990
    Geliefert am 20. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and in its capacity as agent and trustee for itself any successor agent and for the banks as defined under the terms of a guarantee of even d ate and or this debenture.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Apr. 1990
    Geliefert am 19. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and in its capacity as agent and trustee for the banks under the terms of a guarantee of even date and/or this debenture
    Kurze Angaben
    (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AFL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Nov. 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0