AFL REALISATIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AFL REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00246353 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AFL REALISATIONS LIMITED?
- (2874) /
Wo befindet sich AFL REALISATIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court B3 2DT 19 Cornwall Street Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AFL REALISATIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ARMSTRONG FASTENINGS LIMITED | 21. Juni 1990 | 21. Juni 1990 |
| ARMSTRONG PATENTS CO.LIMITED | 08. März 1930 | 08. März 1930 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AFL REALISATIONS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2005 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Okt. 2006 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2004 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für AFL REALISATIONS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 04. Juni 2017 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 18. Juni 2017 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AFL REALISATIONS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für AFL REALISATIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Geoffrey Bailey als Sekretär am 24. Feb. 2010 | 2 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von David Patrick Dancaster als Geschäftsführer am 05. Juni 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Geoffrey Bailey als Geschäftsführer am 24. Feb. 2010 | 2 Seiten | TM01 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 6 Seiten | AC92 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Juli 2009 | 4 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 405(2) | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009 | 4 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 5 Seiten | 3.6 | ||
Bericht des Verwaltungsverwalters | 46 Seiten | 3.10 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed armstrong fastenings LIMITED\certificate issued on 22/05/06 | 3 Seiten | CERTNM | ||
legacy | 1 Seiten | 405(1) | ||
Wer sind die Geschäftsführer von AFL REALISATIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Sekretär | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| GARDNER, Norman Arthur | Sekretär | 210a Stroud Road GL1 5LA Gloucester Gloucestershire | British | 61016230001 | ||||||
| GODWIN, Michael John | Sekretär | 8 Hartwell Grove ST16 1RW Stafford Staffordshire | British | 6083440001 | ||||||
| GOODSHIP, Karen Lesley | Sekretär | The Retreat 6 Church Farm Mews Dosthill B77 1LU Tamworth Staffordshire | British | 16697470002 | ||||||
| JONES, Kevin | Sekretär | 3 Quilter Close WV14 9AX Coseley West Midlands | British | 85295800001 | ||||||
| MILWARD, Roy Edward | Sekretär | 63 Doles Lane Findern DE65 6BA Derby Derbyshire | British | 114078580001 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Sekretär | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| STABLEFORD, Kevin William | Sekretär | 106 Russell Bank Road Four Oaks B74 4RJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 43235360003 | ||||||
| WARD, Elizabeth Katherine | Sekretär | Thistledown House Cheltenham Road WR11 6LF Evesham Worcestershire | British | 18385840002 | ||||||
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Geschäftsführer | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | 108203800001 | |||||
| BIRDS, Kenneth Paul | Geschäftsführer | 10 Maplewood ST17 4SG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 65859470001 | |||||
| BUTLER, Richard Gareth John | Geschäftsführer | The Field House Rashwood WR9 0BS Droitwich Spa Worcestershire | England | British | 117859680001 | |||||
| CLARKE, Ian Russell | Geschäftsführer | Kensington House Churchfields ST18 0HJ Stafford Staffordshire | British | 104937880001 | ||||||
| DANCASTER, David Patrick | Geschäftsführer | Kenilworth Avenue SW19 7LN London 1 | England | British | 55380530001 | |||||
| DICKINSON, John Alan | Geschäftsführer | Monks Barn Maugersbury Stow On The Wold GL54 1HB Cheltenham Gloucestershire | British | 28823880003 | ||||||
| GARDNER, Norman Arthur | Geschäftsführer | 210a Stroud Road GL1 5LA Gloucester Gloucestershire | British | 61016230001 | ||||||
| GODWIN, Michael John | Geschäftsführer | 8 Hartwell Grove ST16 1RW Stafford Staffordshire | British | 6083440001 | ||||||
| HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor | Geschäftsführer | The Tile House 26 Pound Lane Sonning On Thames RG4 6XE Reading Berkshire | British | 12310490001 | ||||||
| HARLAND, Andrew David | Geschäftsführer | 10 Clos Y Gwyddfid Morganstown CF15 8EX Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 103589300001 | |||||
| JONES, Kevin | Geschäftsführer | 3 Quilter Close WV14 9AX Coseley West Midlands | British | 85295800001 | ||||||
| LEEK, James Anthony | Geschäftsführer | 8 Atherton Drive Wimbledon SW19 5LB London | British | 11293430001 | ||||||
| LYONS, Paul Anthony | Geschäftsführer | 10 Drayson Lane NN6 7SR Crick Northamptonshire | United Kingdom | British | 72857310001 | |||||
| MILWARD, Roy Edward | Geschäftsführer | 63 Doles Lane Findern DE65 6BA Derby Derbyshire | United Kingdom | British | 114078580001 | |||||
| PARKER, Anthony Kenneth | Geschäftsführer | 135 Russell Bank Road Four Oaks B74 4RJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 28823860001 | ||||||
| PAUL, Akash, The Honourable | Geschäftsführer | Ambkia House 9a Portland Place W1B 1PR London Flat 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 49303360005 | |||||
| PAUL, Ambar, The Honourable | Geschäftsführer | Ambika House 9-11 Portland Place W1B 1PR London Flat 19 United Kingdom | United Kingdom | British | 92729600003 | |||||
| PUNN, Gurinder | Geschäftsführer | 84 Harborne Road B15 3HN Birmingham West Midlands | British | 50699630002 | ||||||
| ROSS, John | Geschäftsführer | 28 Longwood Rise WV12 4AX Willenhall West Midlands | English | 18966690001 | ||||||
| SHAW, Albert | Geschäftsführer | Robinshill Great Moor Road Pattingham WV6 7AU Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 58615920001 | |||||
| SHAW, Christopher Norman | Geschäftsführer | Castle Vale Castle Street, Raglan NP15 2DS Usk Gwent | United Kingdom | British | 28831060001 | |||||
| SHORE, Jack | Geschäftsführer | 4 Westerham Close Knowle B93 9BU Solihull West Midlands | British | 33670600001 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Geschäftsführer | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STABLEFORD, Kevin William | Geschäftsführer | 106 Russell Bank Road Four Oaks B74 4RJ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 43235360003 | |||||
| STEELE, Colin Grant | Geschäftsführer | Hindrum Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 10618480001 | |||||
| WILLIAMS, Peter James | Geschäftsführer | 26 New Walk HU17 7DJ Beverley North Humberside | British | 57964710001 |
Hat AFL REALISATIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Nov. 2002 Geliefert am 09. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 2000 Geliefert am 09. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the financing agreement | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge to a debenture dated 31ST january 1996 | Erstellt am 08. Sept. 1999 Geliefert am 16. Sept. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them under or in connection with the finance documents and all sums and liabilities under or in connection with the hedging arrangements | |
Kurze Angaben The l/h property interest in units 28 and 29 stoneferry park, foster street, kingston-upon-hull. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 03. Sept. 1996 Geliefert am 04. Sept. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents or (as the case may be) this charge | |
Kurze Angaben The company charges the deposit being all sums from time to time standing to the credit of the designated account, and all entitlement to interest from time to time accruing to such sums, and the debt represented thereby.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Jan. 1996 Geliefert am 01. Feb. 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the charge as agent and trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under the finance documents (as defined) and all sums and liabilities under or in connection with the hedging arrangments | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1990 Geliefert am 15. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 5.4.90 and a guarantee dated 5.4.90 and this charge | |
Kurze Angaben 1. l/h land & buildings north side of clough road kingston upon hull. 2. f/h land fronting great barr street, derby street lily crescent and ivy lane, t/n wm 77156 & f/h land forming part of the site of lily crescent t/n wk 125182. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 1990 Geliefert am 20. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and in its capacity as agent and trustee for itself any successor agent and for the banks as defined under the terms of a guarantee of even d ate and or this debenture. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Apr. 1990 Geliefert am 19. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and in its capacity as agent and trustee for the banks under the terms of a guarantee of even date and/or this debenture | |
Kurze Angaben (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AFL REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0