EIBL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EIBL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00258414 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EIBL LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich EIBL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Embankment West Tower 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EIBL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EQUITY INSURANCE BROKERS LIMITED | 02. Mai 2006 | 02. Mai 2006 |
| COX INSURANCE BROKERS LIMITED | 14. Jan. 2005 | 14. Jan. 2005 |
| BONCASTER LIMITED | 14. Aug. 1931 | 14. Aug. 1931 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EIBL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EIBL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Ian James Donaldson als Direktor am 31. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Janice Deakin als Geschäftsführer am 30. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Scott Stewart Kennedy als Geschäftsführer am 30. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Robert Harding als Geschäftsführer am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Annabel Felicity Wilson als Sekretär am 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Ms Janice Deakin als Direktor am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Dean Clarke als Sekretär am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Mr Craig David Ball als Direktor am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Scott Stewart Kennedy als Direktor am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Gilles Normand als Geschäftsführer am 03. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 9 | 2 Seiten | MR05 | ||
Change of details for Eibl Management Limited as a person with significant control on 19. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Änderung der Details des Direktors für David Robert Harding am 19. Juni 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EIBL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Sekretär | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | 255357800001 | |||||||
| BALL, Craig David | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 109298830003 | |||||
| DONALDSON, Ian James | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 253784440001 | |||||
| CUGGY, Victoria Louise | Sekretär | Ranulf Road CM6 3GR Little Dunmow 63 Essex | British | 105782010002 | ||||||
| DESRAY, Georges | Sekretär | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169856280001 | |||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Sekretär | Holliwell Chandlers CM0 8NY Burnham On Crouch Essex | British | 85213650001 | ||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Sekretär | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House Greater Manchester | English | 1778900007 | ||||||
| NICE, Richard Frederick | Sekretär | 70 Heritage Drive ME7 3EH Gillingham Kent | British | 2850930001 | ||||||
| PLUMER, Christian Charles | Sekretär | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189560390001 | |||||||
| RINGROSE, Christopher James | Sekretär | Lindum Lodge, Orchard Close Risby IP28 6QL Bury St Edmunds Suffolk | British | 46372950001 | ||||||
| WILSON, Annabel Felicity | Sekretär | RG1 8DA Reading Norman Place United Kingdom | 196024840001 | |||||||
| ABLETT, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Benover House Rectory Lane CT21 4QA Saltwood Kent | England | British | 65924000002 | |||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| BOWYER, Nicholas | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House Greater Manchester | United Kingdom | British | 112143600001 | |||||
| CASTAGNO, John | Geschäftsführer | 49 Prospect Road EN5 5AD New Barnet Hertfordshire | United Kingdom | Italian | 89272480001 | |||||
| CHARLES, Colin David | Geschäftsführer | The Holt 48 Woodcote Avenue SM6 0QY Wallington Surrey | England | British | 46667150002 | |||||
| CLARE, Anthony Peter | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House Greater Manchester | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| CONNELL, Peter | Geschäftsführer | 20 Compton Drive BN20 8BX Eastbourne East Sussex | England | British | 84112410002 | |||||
| DEAKIN, Janice | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House United Kingdom | England | British | 238355920001 | |||||
| DESRAY, Georges | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| FITZMAURICE, Edward Martin | Geschäftsführer | 22 Gayton Crescent Hampstead NW3 1UA London | United Kingdom | Irish | 51473830002 | |||||
| FRIEND, Gary | Geschäftsführer | 14 Pyefleet View Langenhoe CO5 7LD Colchester Essex | British | 98993810002 | ||||||
| HAPLIN, Peter Joseph | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House Greater Manchester | United Kingdom | British | 135757830001 | |||||
| HARDING, David Robert | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 196407900002 | |||||
| HAZELDINE, Adrian Mark | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House Greater Manchester | United Kingdom | British | 55020250002 | |||||
| HEATH, Duncan Rodney | Geschäftsführer | Larkins Farm Stondon Road CM4 0JY Blackmoor Essex | British | 13823360001 | ||||||
| HEATH, Roger Eric | Geschäftsführer | Titbeech House Terling Road Hatfield Peverell CM3 2AA Chelmsford Essex | British | 5653830001 | ||||||
| HUTTON, Michael | Geschäftsführer | 40 The Locks BD16 4BG Bingley West Yorkshire | England | British | 78423980002 | |||||
| KENNEDY, Scott Stewart | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 211745270001 | |||||
| MORLEY, James | Geschäftsführer | Virginia House St Marys Road SL5 9JE Ascot Berkshire | United Kingdom | United Kingdom | 13374700001 | |||||
| MOWL, Donald William | Geschäftsführer | 4 Ridgeway CM12 9NT Billericay Essex | British | 2850940001 | ||||||
| NEWMAN, John Victor | Geschäftsführer | Woodside Bonfire Lane Horsted Keynes RH17 7AG Haywards Heath West Sussex | British | 1535360001 | ||||||
| NORMAND, Gilles | Geschäftsführer | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | French | 175288680002 | |||||
| O'CONNOR, Jeremiah Patrick | Geschäftsführer | 12 Connaught Lodge Connaught Road N4 4NR London | British | 45630220001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EIBL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eibl Management Limited | 06. Apr. 2016 | 101 Cathedral Approach M3 4FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EIBL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 26 may 2006 | Erstellt am 08. Jan. 2009 Geliefert am 14. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 08. Jan. 2009 Geliefert am 14. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Manager investor debenture | Erstellt am 05. Jan. 2006 Geliefert am 21. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any bondholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge its rights under an agreement or other security asset all f/h or l/h property,all rights under licence or other agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Syndication investor debenture | Erstellt am 05. Jan. 2006 Geliefert am 21. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any bondholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge its rights under an agreement or any other security asset,all f/h or l/h property and all rights under any licence or other agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 22. Aug. 2005 Geliefert am 01. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All assets assigned or charged under the debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2005 Geliefert am 21. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land investments plant and machinery credit balances book debts insurances relevant contracts intellectual property goodwill floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Mai 2002 Geliefert am 31. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders"). | Erstellt am 25. Apr. 2002 Geliefert am 07. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0