AVON INFLATABLES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVON INFLATABLES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00259668
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVON INFLATABLES LIMITED?

    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich AVON INFLATABLES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o CORK GULLY LLP
    52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVON INFLATABLES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AVON INFLATABLES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVON INFLATABLES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Princeton Mews 167-169 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6PT United Kingdom zum C/O Cork Gully Llp 52 Brook Street London W1K 5DS am 09. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Sept. 2014

    LRESEX

    Änderung der Details des Direktors für Ms Karen Jayne Milliner am 03. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Quadrant 118 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6QJ zum 1 Princeton Mews 167-169 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6PT am 13. Aug. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    21 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2014

    • Kapital: GBP 1,187,269
    SH01

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 002596680012 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von François Mirallié als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Karen Jayne Milliner als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Dafen Llanelli Carmarthenshire South Wales SA14 8NA* am 30. Okt. 2013

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Marc Lavorata als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    6 SeitenMEM/ARTS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 002596680012

    6 SeitenMR01

    Ernennung von Mr François Mirallié als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michel Duplantier als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Keith Protheroe als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von AVON INFLATABLES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MILLINER, Karen Jayne
    Princeton Mews
    167-169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Princeton Mews
    167-169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    1
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary40044300003
    GRIFFITHS, Richard Huw
    56 Ridgewood Park
    SA15 1JS Llanelli
    Carmarthenshire
    Sekretär
    56 Ridgewood Park
    SA15 1JS Llanelli
    Carmarthenshire
    BritishCompany Secretary39645650001
    MARTIN, Christopher Leonard
    Springwood Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA3 6JR Bath
    Avon
    Sekretär
    Springwood Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA3 6JR Bath
    Avon
    British14685350001
    CADAVID VALLS, Narcisco
    Els Vessants 4
    Tiana
    Barcelona
    08391
    Spain
    Geschäftsführer
    Els Vessants 4
    Tiana
    Barcelona
    08391
    Spain
    SpanishManager70878960001
    DUPLANTIER, Michel Didier
    Dafen
    Llanelli
    SA14 8NA Carmarthenshire
    South Wales
    Geschäftsführer
    Dafen
    Llanelli
    SA14 8NA Carmarthenshire
    South Wales
    FranceFrenchDirector171475880001
    FLEMING, Timothy John
    8 Rue Montaign
    Chambourcy
    78240
    France
    Geschäftsführer
    8 Rue Montaign
    Chambourcy
    78240
    France
    BritishManager100010430001
    GRIFFITHS, Richard Huw
    56 Ridgewood Park
    SA15 1JS Llanelli
    Carmarthenshire
    Geschäftsführer
    56 Ridgewood Park
    SA15 1JS Llanelli
    Carmarthenshire
    United KingdomBritishAccountant39645650001
    HARDING, Richard John Arthur
    Rhiwlas Fach Mountain Road
    Trimsaran
    Llanelli
    Carmarthenshire
    Geschäftsführer
    Rhiwlas Fach Mountain Road
    Trimsaran
    Llanelli
    Carmarthenshire
    BritishDirector15496180001
    HARPER, John Sidney
    13 Raby Place
    Bathwick Hill
    BA2 4EW Bath
    Geschäftsführer
    13 Raby Place
    Bathwick Hill
    BA2 4EW Bath
    BritishAccountant44186430001
    LAVORATA, Marc Georges
    44 Rue De Labotte
    Aux Cailles
    FOREIGN Paris
    75013
    France
    Geschäftsführer
    44 Rue De Labotte
    Aux Cailles
    FOREIGN Paris
    75013
    France
    FranceFrenchManager115850990001
    MARTIN, Christopher Leonard
    Springwood Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA3 6JR Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Springwood Midford Lane
    Limpley Stoke
    BA3 6JR Bath
    Avon
    BritishLegal Adviser14685350001
    MIRALLIÉ, François
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston Upon Thames
    The Quadrant
    Surrey
    United Kingdom
    FranceFrenchDirector177325160001
    MORGAN, Alan
    17 Plas Y Fforest
    Pontardulais
    SA4 1TG Swansea
    West Glamorgan
    Geschäftsführer
    17 Plas Y Fforest
    Pontardulais
    SA4 1TG Swansea
    West Glamorgan
    WalesBritishAccountant15496190002
    NORREYS, Tom Timothy
    19 Dan Y Lan
    Felinfoel
    SA14 8BW Llanelli
    Dyfed
    Geschäftsführer
    19 Dan Y Lan
    Felinfoel
    SA14 8BW Llanelli
    Dyfed
    BritishDirector15247250001
    POTTER, Michael Trevor
    21 Pyms Close
    Great Barford
    MK44 3HY Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    21 Pyms Close
    Great Barford
    MK44 3HY Bedford
    Bedfordshire
    BritishManufacturing Director29852490001
    POWELL, David
    2 Cheval House
    30/32 Montpelier Walk Knightsbridge
    SW7 1JF London
    Geschäftsführer
    2 Cheval House
    30/32 Montpelier Walk Knightsbridge
    SW7 1JF London
    BritishChairman41083340003
    PROTHEROE, Keith
    Dafen
    Llanelli
    SA14 8NA Carmarthenshire
    South Wales
    Geschäftsführer
    Dafen
    Llanelli
    SA14 8NA Carmarthenshire
    South Wales
    United KingdomBritishManaging Director171475900001
    PUNAULT, Maurice
    6 Rue Benouville
    75116 Paris
    France
    Geschäftsführer
    6 Rue Benouville
    75116 Paris
    France
    FrenchGeneral Manager Marine Leisure60115980001
    SHEIL, Michael
    8 St Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    8 St Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director17036580001
    SOWDEN, Edward Samuel
    13 Oaklands
    SA14 8DE Llanelli
    Dyfed
    Geschäftsführer
    13 Oaklands
    SA14 8DE Llanelli
    Dyfed
    BritishTechnical Director15496200001
    STACEY, Brian
    Highclere Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7JN Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Highclere Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7JN Bath
    Avon
    BritishDirector42361440001
    STUART, Ross Scott
    The Stables
    Piodau Fach Llandybie
    SA14 3NL Ammanford
    Dyfed
    Geschäftsführer
    The Stables
    Piodau Fach Llandybie
    SA14 3NL Ammanford
    Dyfed
    BritishCompany Director74800170002

    Hat AVON INFLATABLES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 19. Juni 2013
    Geliefert am 03. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 28. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Nov. 1996
    Geliefert am 22. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys now due or to become due from the company and avon marine limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 1994
    Geliefert am 30. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from avon marine limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/as unit 3 dafen industrial park dafen llanelli t/no.WA220904. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 1994
    Geliefert am 30. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from avon marine limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as part of dafen industrial park dafen llanelli dyfed t/no.WA705716. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Juni 1994
    Geliefert am 28. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 10. Juni 1994
    Geliefert am 14. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and in connection with any security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Avon Rubber PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifith supplemental trust deed
    Erstellt am 08. März 1983
    Geliefert am 24. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Sterling 7923036 3/4% debenture stock 1983/88 & sterling pounds 113185972% debenture stock 1985/90, of avon rubber PLC and any other monies intencled to be secured pursuant to the trust deed dated 28/3/63 and deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all f/h & l/h property together with all fixtures fixed charge on all book & other debts (see doc m 144).
    Berechtigte Personen
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 24. März 1983Registrierung einer Belastung
    Facility letter
    Erstellt am 18. Jan. 1983
    Geliefert am 02. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from avon rubber PLC and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter
    Kurze Angaben
    Any nomines standing to the credit of any of the accounts (other than trust accounts) of avon inflatinges limited with midland bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Deedas variation
    Erstellt am 18. Jan. 1983
    Geliefert am 01. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all the other companies named therein to the charges
    Kurze Angaben
    Credit balance held at any time by the mortgagees.
    Berechtigte Personen
    • See Continuation Sheet of Doc M142
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 1983
    Geliefert am 26. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any if the other companies named therein to the charges on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way as fixed charge (and by way as legal morgage as regards those parts thereof the legal estates in which are now vested in avon inflatables limited) all the f/h and l/h property of avon inflotables together with all buildings and fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Floating charge
    Erstellt am 18. Jan. 1983
    Geliefert am 26. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Floating charge over the undertaking of the company and all its property both present and future including uncalled capital for the time being.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Fixed charge
    Erstellt am 18. Jan. 1983
    Geliefert am 26. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all book and other debts.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1983Registrierung einer Belastung

    Hat AVON INFLATABLES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    09. März 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joanne Elizabeth Milner
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Stephen Robert Leslie Cork
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London
    Praktiker
    Cork Gully Llp 52 Brook Street
    W1K 5DS London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0