AVON INFLATABLES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | AVON INFLATABLES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00259668 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVON INFLATABLES LIMITED?
- Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich AVON INFLATABLES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CORK GULLY LLP 52 Brook Street W1K 5DS London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVON INFLATABLES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AVON INFLATABLES LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für AVON INFLATABLES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 10 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Princeton Mews 167-169 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6PT United Kingdom zum C/O Cork Gully Llp 52 Brook Street London W1K 5DS am 09. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Karen Jayne Milliner am 03. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Quadrant 118 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6QJ zum 1 Princeton Mews 167-169 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6PT am 13. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 002596680012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von François Mirallié als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Karen Jayne Milliner als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Dafen Llanelli Carmarthenshire South Wales SA14 8NA* am 30. Okt. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marc Lavorata als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 6 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 002596680012 | 6 Seiten | MR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr François Mirallié als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michel Duplantier als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Protheroe als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVON INFLATABLES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILLINER, Karen Jayne | Geschäftsführer | Princeton Mews 167-169 London Road KT2 6PT Kingston Upon Thames 1 Surrey United Kingdom | England | British | Chartered Secretary | 40044300003 | ||||
GRIFFITHS, Richard Huw | Sekretär | 56 Ridgewood Park SA15 1JS Llanelli Carmarthenshire | British | Company Secretary | 39645650001 | |||||
MARTIN, Christopher Leonard | Sekretär | Springwood Midford Lane Limpley Stoke BA3 6JR Bath Avon | British | 14685350001 | ||||||
CADAVID VALLS, Narcisco | Geschäftsführer | Els Vessants 4 Tiana Barcelona 08391 Spain | Spanish | Manager | 70878960001 | |||||
DUPLANTIER, Michel Didier | Geschäftsführer | Dafen Llanelli SA14 8NA Carmarthenshire South Wales | France | French | Director | 171475880001 | ||||
FLEMING, Timothy John | Geschäftsführer | 8 Rue Montaign Chambourcy 78240 France | British | Manager | 100010430001 | |||||
GRIFFITHS, Richard Huw | Geschäftsführer | 56 Ridgewood Park SA15 1JS Llanelli Carmarthenshire | United Kingdom | British | Accountant | 39645650001 | ||||
HARDING, Richard John Arthur | Geschäftsführer | Rhiwlas Fach Mountain Road Trimsaran Llanelli Carmarthenshire | British | Director | 15496180001 | |||||
HARPER, John Sidney | Geschäftsführer | 13 Raby Place Bathwick Hill BA2 4EW Bath | British | Accountant | 44186430001 | |||||
LAVORATA, Marc Georges | Geschäftsführer | 44 Rue De Labotte Aux Cailles FOREIGN Paris 75013 France | France | French | Manager | 115850990001 | ||||
MARTIN, Christopher Leonard | Geschäftsführer | Springwood Midford Lane Limpley Stoke BA3 6JR Bath Avon | British | Legal Adviser | 14685350001 | |||||
MIRALLIÉ, François | Geschäftsführer | 118 London Road KT2 6QJ Kingston Upon Thames The Quadrant Surrey United Kingdom | France | French | Director | 177325160001 | ||||
MORGAN, Alan | Geschäftsführer | 17 Plas Y Fforest Pontardulais SA4 1TG Swansea West Glamorgan | Wales | British | Accountant | 15496190002 | ||||
NORREYS, Tom Timothy | Geschäftsführer | 19 Dan Y Lan Felinfoel SA14 8BW Llanelli Dyfed | British | Director | 15247250001 | |||||
POTTER, Michael Trevor | Geschäftsführer | 21 Pyms Close Great Barford MK44 3HY Bedford Bedfordshire | British | Manufacturing Director | 29852490001 | |||||
POWELL, David | Geschäftsführer | 2 Cheval House 30/32 Montpelier Walk Knightsbridge SW7 1JF London | British | Chairman | 41083340003 | |||||
PROTHEROE, Keith | Geschäftsführer | Dafen Llanelli SA14 8NA Carmarthenshire South Wales | United Kingdom | British | Managing Director | 171475900001 | ||||
PUNAULT, Maurice | Geschäftsführer | 6 Rue Benouville 75116 Paris France | French | General Manager Marine Leisure | 60115980001 | |||||
SHEIL, Michael | Geschäftsführer | 8 St Davids Close Leicester Forest East LE3 3LU Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 17036580001 | ||||
SOWDEN, Edward Samuel | Geschäftsführer | 13 Oaklands SA14 8DE Llanelli Dyfed | British | Technical Director | 15496200001 | |||||
STACEY, Brian | Geschäftsführer | Highclere Bannerdown Close Batheaston BA1 7JN Bath Avon | British | Director | 42361440001 | |||||
STUART, Ross Scott | Geschäftsführer | The Stables Piodau Fach Llandybie SA14 3NL Ammanford Dyfed | British | Company Director | 74800170002 |
Hat AVON INFLATABLES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 19. Juni 2013 Geliefert am 03. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 15. Nov. 1996 Geliefert am 22. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys now due or to become due from the company and avon marine limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Juni 1994 Geliefert am 30. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from avon marine limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/as unit 3 dafen industrial park dafen llanelli t/no.WA220904. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Juni 1994 Geliefert am 30. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from avon marine limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/as part of dafen industrial park dafen llanelli dyfed t/no.WA705716. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Juni 1994 Geliefert am 28. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Juni 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the guarantee and in connection with any security documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fifith supplemental trust deed | Erstellt am 08. März 1983 Geliefert am 24. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling 7923036 3/4% debenture stock 1983/88 & sterling pounds 113185972% debenture stock 1985/90, of avon rubber PLC and any other monies intencled to be secured pursuant to the trust deed dated 28/3/63 and deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Fixed charge over all f/h & l/h property together with all fixtures fixed charge on all book & other debts (see doc m 144). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Facility letter | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from avon rubber PLC and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter | |
Kurze Angaben Any nomines standing to the credit of any of the accounts (other than trust accounts) of avon inflatinges limited with midland bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deedas variation | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 01. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all the other companies named therein to the charges | |
Kurze Angaben Credit balance held at any time by the mortgagees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 26. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any if the other companies named therein to the charges on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way as fixed charge (and by way as legal morgage as regards those parts thereof the legal estates in which are now vested in avon inflatables limited) all the f/h and l/h property of avon inflotables together with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 26. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Floating charge over the undertaking of the company and all its property both present and future including uncalled capital for the time being. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 26. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book and other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat AVON INFLATABLES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0