HOME FARM PRODUCTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOME FARM PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00265078 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOME FARM PRODUCTS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich HOME FARM PRODUCTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Greencore Group Uk Ctr, Midland Way, Barlborough Links Bus Pk S43 4XA Barlborough Chesterfield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOME FARM PRODUCTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HOME FARM PRODUCTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Sept. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Barratt als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Diane Walker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Hynes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Ernennung von Conor O'leary als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Caroline Bergin als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Sept. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Michael Evans als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Sept. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Sept. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOME FARM PRODUCTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORDSWORTH, Gordon | Sekretär | 1 Home Farm Court Hickleton DN5 7AR Doncaster South Yorkshire | British | 34197470001 | ||||||
| EVANS, Michael | Geschäftsführer | Midland Way Barlborough Links Business Park S43 4XA Barlborough Uk Centre Chesterfield United Kingdom | United Kingdom | British | 148060720001 | |||||
| O'LEARY, Conor | Geschäftsführer | Carrigabruce Enniscorthy Ard Na Laoi Co Wexford Ireland | Ireland | Irish | 143778250002 | |||||
| WALKER, Diane Susan | Geschäftsführer | Manton Wood Enterprise Park Chief Executive S80 2RS Worksop Greencore Food To Go Nottinghamshire | United Kingdom | British | 156683540001 | |||||
| CHALK, Richard Neil | Sekretär | 48 Aldwark YO1 7BU York | British | 52277340002 | ||||||
| HAMILTON, Keith | Sekretär | 42 Lukes Lea Marsworth HP23 4NH Tring Hertfordshire | British | 34013210001 | ||||||
| ROBINSON, Harry | Sekretär | 21 Riverhead Sprotbrough DN5 7QT Doncaster South Yorkshire | British | 1442220001 | ||||||
| WILSON, Keith Edward | Sekretär | 15 Wheatfield Drive Ramsey PE17 1SH Huntingdon Cambridgeshire | British | 27487350001 | ||||||
| WINFIELD, Richard Sheridan | Sekretär | 12a Market Place Oundle PE8 4BQ Peterborough Northamptonshire | British | 14020430002 | ||||||
| BALL, Christopher John | Geschäftsführer | The Old Rectory East End, Walkington HU17 8RY Beverley | United Kingdom | British | 105078650001 | |||||
| BARRATT, William Harrison | Geschäftsführer | 3 Sycamore Close DN22 7JP Retford Nottinghamshire | England | British | 100531360001 | |||||
| BERGIN, Caroline Margaret | Geschäftsführer | 8 Holyrood Park Sandymount Dublin 4 Dublin 4 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 89332200002 | |||||
| BOOKBINDER, Norman Leonard | Geschäftsführer | 4 Portland Court 101 Hendon Lane Finchley N3 3SH London | England | British | 82072310001 | |||||
| CHALK, Richard Neil | Geschäftsführer | 48 Aldwark YO1 7BU York | British | 52277340002 | ||||||
| HAMILTON, Keith | Geschäftsführer | 42 Lukes Lea Marsworth HP23 4NH Tring Hertfordshire | British | 34013210001 | ||||||
| HIGGINSON, Kevin Mark | Geschäftsführer | The Beeches, Myrtle Lodge Farm Main Street LE65 2TY Smisby Leicestershire | United Kingdom | British | 116296480001 | |||||
| HODGSON, Ian | Geschäftsführer | "Oakdale" Landing Lane,Hemingbrough YO8 7RA Selby North Yorkshire | British | 34027210001 | ||||||
| HYNES, Anthony Martin | Geschäftsführer | The Piggeries Hassop DE45 1NW Bakewell Derbyshire | England | Irish | 100467690002 | |||||
| LIDDAMENT, Michael Gordon | Geschäftsführer | 10 Belvoir Walk MK41 8LE Bedford Bedfordshire | British | 32865050002 | ||||||
| PURDON, Richard Alan | Geschäftsführer | 2 Beaconsfield Road B74 2NX Sutton Coldfield West Midlands | British | 33433860001 | ||||||
| ROBINSON, Harry | Geschäftsführer | 21 Riverhead Sprotbrough DN5 7QT Doncaster South Yorkshire | British | 1442220001 | ||||||
| SIMONS, John Michael | Geschäftsführer | Riverdale Lodge Ferry Green DE65 6BL Willington Derbyshire | British | 37634780005 | ||||||
| SMITH, Gerard Arthur | Geschäftsführer | 158 Bawtry Road Bassacarr DN4 7BT Doncaster South Yorkshire | England | British | 111889550001 | |||||
| TRUELOVE, Amelia Anne | Geschäftsführer | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | 37845970003 | ||||||
| WILSON, Keith Edward | Geschäftsführer | 15 Wheatfield Drive Ramsey PE17 1SH Huntingdon Cambridgeshire | British | 27487350001 | ||||||
| WOODALL, Frederick Peter | Geschäftsführer | The Ridge Pine Walks Prenton CH42 8NF Wirral Merseyside | British | 74795530001 |
Hat HOME FARM PRODUCTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 1987 Geliefert am 12. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Nov. 1987 Geliefert am 11. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0