MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00266894 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MCCORMICK FOOD SERVICE LIMITED | 09. Jan. 1998 | 09. Jan. 1998 |
| L.NOEL & SONS LIMITED | 11. Juli 1932 | 11. Juli 1932 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Nov. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Haddenham Business Park Pegasus Way Haddenham Aylesbury Buckinghamshire HP17 8LB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 22. Dez. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification of Noel Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 09. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Stuart Swift als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Laird Everett Creighton als Direktor am 01. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Jinks als Direktor am 01. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Noble als Geschäftsführer am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Noble als Sekretär am 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresr ückblick erstellt bis 31. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Smith als Sekretär am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Charles Noble als Sekretär am 01. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Raymond Smith als Geschäftsführer am 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Charles Noble als Direktor am 01. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREIGHTON, Laird Everett | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | American | 222075660001 | |||||
| JINKS, Christopher | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | English | 161032050003 | |||||
| BURLEY, Nicholas James | Sekretär | 16 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DS Warrington Cheshire | British | 89448590001 | ||||||
| DEAN, Paul | Sekretär | 7 Herschel Avenue BB12 0LN Burnley Lancashire | English | 14447110001 | ||||||
| HANNA, Roisin | Sekretär | 180 Holywell Upper Kilmacud Road Dublin 14 Dublin Ireland | British | 44105690001 | ||||||
| MANN, Christopher John | Sekretär | 12 Fryth Mead AL3 4TN St Albans Hertfordshire | British | 59971900001 | ||||||
| MOORE, Stephen Jeffrey | Sekretär | 41 Bicester Road HP18 9BP Long Crendon Buckinghamshire | Canadian | 71665970001 | ||||||
| MORRISROE, James Martin, Dr | Sekretär | Tellicherry 15 Foxdell Way Chalfont St. Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 62702000002 | ||||||
| NOBLE, Charles | Sekretär | Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Haddenham Business Park Buckinghamshire | 192171720001 | |||||||
| SAVAGE, Cameron David Freere | Sekretär | Wayside Bledlow Road Saunderton HP27 9NG Princes Risborough Buckinghamshire | British | 45096570001 | ||||||
| SMITH, Michael | Sekretär | Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Haddenham Business Park Buckinghamshire | 168636460001 | |||||||
| STEELE, Darren Anthony | Sekretär | London Road HP4 2ND Berkhamsted 28 Hertfordshire United Kingdom | Australian | 125578160002 | ||||||
| STETZ, Gordon Mckenzie | Sekretär | 2 Belvedere Close HP6 6BA Amersham Buckinghamshire | American | 104851130001 | ||||||
| ALLEN, Eamon Joseph | Geschäftsführer | Grenagh Avoca Avenue Blackrock County Dublin Ireland | Irish | 33780080001 | ||||||
| BURLEY, Nicholas James | Geschäftsführer | 16 Stonyhurst Crescent Culcheth WA3 4DS Warrington Cheshire | England | British | 89448590001 | |||||
| DEAN, Paul | Geschäftsführer | 7 Herschel Avenue BB12 0LN Burnley Lancashire | English | 14447110001 | ||||||
| DISNEY, Colin | Geschäftsführer | 24 Highfield Grove Carlton In Lindrick S81 9ET Worksop Nottinghamshire | British | 17431590001 | ||||||
| GREENE, Eugene | Geschäftsführer | Maryvale 38a Church Road IRISH Killiney Co Dublin | Irish | 34070520001 | ||||||
| HANDLEY, Harold John | Geschäftsführer | 28 Rivermead Court Bisham Road SL7 1SJ Marlow Buckinghamshire | British | 39829900001 | ||||||
| KEEFE, Robert John Frederick | Geschäftsführer | Glendale House Manor Road Penn HP10 8JA High Wycombe Bucks | United Kingdom | British | 22579040002 | |||||
| KEENAN, John | Geschäftsführer | 1 Woodcrest Wilpshire BB1 9PR Blackburn Lancashire | British | 15667510001 | ||||||
| KURZIUS, Lawrence Erik | Geschäftsführer | 1312 First Street New Orleans Louisiana 70130 Usa | United States | American | 118683830001 | |||||
| MANIFOLD, Albert Jude | Geschäftsführer | Spynans House Kiltegan County Wicklow Ireland | Ireland | Irish | 264302310001 | |||||
| MCGUIRE, Vivian Francis | Geschäftsführer | 12 Knocknacree Park Dalkey County Dublin Ireland | Irish | 30974070001 | ||||||
| MOLAN, John Charles | Geschäftsführer | Little Birches Coronation Road SL5 9LQ Ascot Berkshire | British | 46924240002 | ||||||
| MOORE, Stephen Jeffrey | Geschäftsführer | 41 Bicester Road HP18 9BP Long Crendon Buckinghamshire | Canadian | 71665970001 | ||||||
| MORRISROE, James Martin, Dr | Geschäftsführer | Tellicherry 15 Foxdell Way Chalfont St. Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 62702000002 | ||||||
| MURPHY, James Thomas | Geschäftsführer | 15 Jevington Way Heysham LA3 2HQ Morecambe Lancashire | British | 15667520001 | ||||||
| NIEROP, Philip Godwin | Geschäftsführer | Keepers Cottage 1 Milton Street Westcott RH4 3PX Dorking Surrey | British | 60097480001 | ||||||
| NOBLE, Charles | Geschäftsführer | Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Haddenham Business Park Buckinghamshire | United Kingdom | British | 191978360001 | |||||
| PEPPERDINE, Roy | Geschäftsführer | 1 Bankcroft Close Padiham BB12 8SQ Burnley Lancashire | British | 15667530001 | ||||||
| SMITH, Michael Raymond | Geschäftsführer | Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Haddenham Business Park Buckinghamshire | England | American | 168609300002 | |||||
| STEELE, Darren Anthony | Geschäftsführer | London Road HP4 2ND Berkhamsted 28 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 125578160003 | |||||
| STETZ, Gordon Mckenzie | Geschäftsführer | 2 Belvedere Close HP6 6BA Amersham Buckinghamshire | American | 104851130001 | ||||||
| SWIFT, Malcolm Stuart | Geschäftsführer | Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Haddenham Business Park Buckinghamshire | England | British | 135538440002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Haddenham Business Park, Pegasus Way Haddenham HP17 8LB Aylesbury Mccormick (Uk) Plc Buckinghamshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 31. Mai 2017 | 31. Mai 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal charge | Erstellt am 14. Aug. 1992 Geliefert am 03. Sept. 1992 | Ausstehend | Gesicherter Betrag For securing all monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (as security trustee) the banks and the overdraft bank (all as defined) under the terms of the facilities agreement in respect of the term loan facility and/or the working capital facility letter in respect of the working capital facility and all monies due or to become due from the company to the mezzanine lender (as defined) under the terms of the mezzanine loan agreement and the mezzanine loan and all monies due or to become due from each group company to the secured parties under the terms of the secured documents or any of them | |
Kurze Angaben All that freehold and leasehold land k/a stanhill mill stanhill valley oxwaldtwistle accrington lancashire BB5 4PR together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery (please see form 395 and attached schedule tc ref M171C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 20. Mai 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of other companies named therein to the chargee under the terms of this charge and the various as defined therein | |
Kurze Angaben (See doc M701 c for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on credit balance of accounts. | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 20. Mai 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the companies (as defined in the deed) to the governor and company of the bank of scotland in its capacity as overdraft bank and the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 30.4.91. | |
Kurze Angaben By way of fixed and specific charge:- all moneys at 30-4-91. standing to the credit of the account of R. noel & sons limited with the bank of scotland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MCCORMICK FOODSERVICE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0