LMB REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLMB REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00270937
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LMB REALISATIONS LIMITED?

    • (5142) /
    • (5242) /

    Wo befindet sich LMB REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LMB REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BON MARCHE LIMITED29. Juni 199529. Juni 1995
    WILTEX BY WILSON LIMITED07. Dez. 193207. Dez. 1932

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LMB REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Apr. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LMB REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LMB REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Okt. 2014

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 02. Okt. 2014

    24 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Mai 2014

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Mai 2014

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    23 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Jan. 2014

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juli 2013

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juli 2013

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Jan. 2013

    34 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Jan. 2013

    34 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juli 2012

    39 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juli 2012

    38 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    73 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    72 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    72 Seiten2.17B

    legacy

    4 SeitenMG02

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    38 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 1 the Embankment Neville Street Leeds LS1 4DW am 06. Feb. 2012

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von LMB REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Sekretär
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    ALLDRIDGE, Stephen Alexander
    Sycamore House 2 Thorp Arch Park
    Thorp Arch
    LS23 7AN Wetherby
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Sycamore House 2 Thorp Arch Park
    Thorp Arch
    LS23 7AN Wetherby
    Yorkshire
    United KingdomBritish91887600001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Geschäftsführer
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritish62596180004
    ELLIS, Roy George
    c/o Kpmg Llp
    The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    1
    Geschäftsführer
    c/o Kpmg Llp
    The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    1
    WalesBritish161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritish54276260003
    AUSTIN, Howard Paul
    6 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    6 Hawthorne Way
    Shelley
    HD8 8JX Huddersfield
    West Yorkshire
    British63408700001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British118296490001
    KHELA, Surjeet Singh
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Indian3462380001
    KILLICK, Mike David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Newport
    Sekretär
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Newport
    British83828320001
    WALKER, David Anthony
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    British32549000002
    WARDEN, John Henderson
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    Sekretär
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    British59501490001
    BLACK, Kevin Barry Philip
    400 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    400 Birkby Road
    HD2 2DN Huddersfield
    West Yorkshire
    British82955520001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Geschäftsführer
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritish54831150003
    BULLAS, Steven Robert
    87
    Brockholes Lane, Brockholes
    HD9 7EB Holmfirth
    Rockleigh
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    87
    Brockholes Lane, Brockholes
    HD9 7EB Holmfirth
    Rockleigh
    Yorkshire
    EnglandBritish96918430003
    CHIMA, Gurchait Singh
    Norwood View 29 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Norwood View 29 Norwood Park
    HD2 2DU Huddersfield
    West Yorkshire
    British14031160001
    CHIMA, Gurnaik Singh
    Four Winds 61 Church Lane
    South Crosland
    HD4 7DD Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Four Winds 61 Church Lane
    South Crosland
    HD4 7DD Huddersfield
    West Yorkshire
    British7655680001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    KHELA, Surjeet Singh
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Indian3462380001
    KHELA, Surjeet Singh
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 The Dell
    Netheroyd Park Fixby
    HD2 2FD Huddersfield
    West Yorkshire
    Indian3462380001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritish75927820002
    LEE, Paul Anthony
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    United KingdomBritish4668760001
    MCDONALD, Andrew
    122 Birkby Hall Road
    Birkby
    HD2 2UZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    122 Birkby Hall Road
    Birkby
    HD2 2UZ Huddersfield
    West Yorkshire
    British83828720001
    PIDGEON, David
    93 Birchy Close
    Dickens Heath
    B90 1QL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    93 Birchy Close
    Dickens Heath
    B90 1QL Solihull
    West Midlands
    British88621520001
    RUBIN, Janet Catherine Mary
    11 Blakesley Avenue
    W5 2DN London
    Geschäftsführer
    11 Blakesley Avenue
    W5 2DN London
    United KingdomBritish50127880001
    SCOTT, Ronald David
    Huby Manor
    Crag Lane
    LS17 0BW Huby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Huby Manor
    Crag Lane
    LS17 0BW Huby
    West Yorkshire
    EnglandBritish114963930001
    TAYLOR-CLAGUE, Albert Clive
    Swindon Hall Swindon Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HR Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Swindon Hall Swindon Lane
    Kirkby Overblow
    HG3 1HR Harrogate
    North Yorkshire
    British36517460001
    TESSEYMAN, Mark Edward
    Pool Barn Farm
    Middleton
    LL20 7HW Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Pool Barn Farm
    Middleton
    LL20 7HW Oswestry
    Shropshire
    British90289000003
    WALKER, David Anthony
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Knowles Grimescar Road
    Fixby
    HD2 2EB Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish32549000002
    WILLIAMS, Ian Malcolm
    Victoria Springs
    HO9 2NB Holmfirth
    16
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Victoria Springs
    HO9 2NB Holmfirth
    16
    West Yorkshire
    United KingdomBritish129501260001

    Hat LMB REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2002
    Geliefert am 15. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 18. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the secured parties (or any of them) by the company and bon marche group limited, bon marche holdings limited, hilton fashions limited and inhoco 336 limited in whatsoever manner
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A compoisite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 11. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the company to the security trustee, the beneficiaries or any of them under or in connection with the loan note instrument and the guarantee and indemnity of each of the bon marche holdings limited, the company inhoco 336 limited and hilton fashions limitedas contained in the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Four Winds Trust Whose Trustee is Orbis Trustees (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 11. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Apr. 1999
    Geliefert am 05. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Apr. 1999
    Geliefert am 05. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold properties west side of ridings wood tandem industrial estate, kirklees west yorkshire title no WYK537007, north west of school lane kirkheaton huddersfield west yorkshire title no WYK10637, east side of crossley lane huddersfield west yorkshire title number YWE30893, 2A yonge park islington title NO285966 and leasehold property 14 and 16 market street earlestow st helens merseyside title no MS93790 and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Girobank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1999
    Geliefert am 17. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 01. Sept. 1997
    Geliefert am 02. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various shopfittings and other accessories at units 7-9 the cleveland centre middlesborough comprised in invoice no 485 dated 31ST may 1997 together with various shopfittings and other accessories of unit 10 ashton galleries shopping centre wigan comprsed in invoice 4957 dated 30TH april 1997 and various shopfittings and other accessories at 68-70 high street kettering comprised in invoice no s/3065 dated 15 may 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The north east of crossley lane kirkheaton huddersfield and k/a wiltex lane with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in any managenent company for the property any goodwill of any business from time to time at the property any rental and all other payments in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    257 hoylake road moreton merseyside with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and all other payments whatever in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 and 16 market street earlestown merseyside with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time at the property any rental and all other payments whatever in relation to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2A yonge park islington with the benefit of all rights licences guarantees deeds undertakings and warranties relating to the property any shares and membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The north west of school lane kirkheaton huddersfield with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. März 1997
    Geliefert am 18. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The west of ridings wood tandem industrial estate huddersfield with the benefit of all rights licences guarantees rent deposit contracts deeds undertakings and warranties relating to the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and all other payments whatever at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 18. Okt. 1996
    Geliefert am 01. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge on deposit
    Erstellt am 15. Sept. 1995
    Geliefert am 03. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £200,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of India
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1995
    Geliefert am 01. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Apr. 1994
    Geliefert am 22. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Tandem house, tandem industrial estate, wakefield road, waterloo, huddersfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/as 257 hoylake road, moreton and saughall massie, merseyside t/no ms 278356. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings k/as 14 and 16 market street, earlestown, st helens, merseyside t/no ms 93790. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/as 247 and 249 breck road, everton, liverpool, merseyside t/no ms 101782. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/as 2A yonge park, finsbury park, london borough of islington, greater london, t/no 285966. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Apr. 1994
    Geliefert am 20. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/as workshop premises, pontybodkin hill, pontybodkin, mold, delyn, clwyd t/no wa 693904. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 13. Juli 1990
    Geliefert am 17. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Inc: all heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juli 1986
    Geliefert am 19. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Newland works, crossley lane, kirkheaton, huddersfield west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 07. Nov. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LMB REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Jan. 2012Beginn der Verwaltung
    02. Okt. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Mark Granville Firmin
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0