N.B. REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameN.B. REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00271291
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von N.B. REALISATIONS LIMITED?

    • (2861) /

    Wo befindet sich N.B. REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von N.B. REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OSBORNE TABLEWARE LIMITED23. Sept. 200823. Sept. 2008
    NICKEL BLANKS COMPANY LIMITED(THE)17. Dez. 193217. Dez. 1932

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von N.B. REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2008
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2009
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für N.B. REALISATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis15. Sept. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung29. Sept. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für N.B. REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für N.B. REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Gläubigerinsolvenz

    3 SeitenREST-CVL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2011

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Dez. 2010

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 22. Jan. 2010

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    16 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Juli 2009

    1 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten288b

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    4 Seiten2.16B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed osborne tableware LIMITED\certificate issued on 05/03/09
    2 SeitenCERTNM

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 21. Jan. 2009

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    38 Seiten1.4

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed nickel blanks company LIMITED(the)\certificate issued on 23/09/08
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von N.B. REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLECLOUGH, Paul John
    12 Hewers Holt
    Barlborough
    S43 4WJ Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    12 Hewers Holt
    Barlborough
    S43 4WJ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglishDirector73369320001
    C & P COMPANY SECRETARIES LIMITED
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    Sekretär
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    6204810001
    COLECLOUGH, Paul John
    12 Hewers Holt
    Barlborough
    S43 4WJ Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    12 Hewers Holt
    Barlborough
    S43 4WJ Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandEnglishDirector73369320001
    KYNMAN, David
    15 Ivy House Court
    Auckley
    DN9 3PX Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Ivy House Court
    Auckley
    DN9 3PX Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector67579900001
    WHITEHEAD, Janet
    40 Elm Crescent
    Mosborough
    S19 5AT Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    40 Elm Crescent
    Mosborough
    S19 5AT Sheffield
    South Yorkshire
    British10761180001
    BROWNHILL, Percy Raymond
    10 Carsick Hill Crescent
    S10 3LT Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Carsick Hill Crescent
    S10 3LT Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director63871710001
    LEMONIATIS, Andreas
    11 Great North Road
    Brookmans Park
    AL9 6LB Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Great North Road
    Brookmans Park
    AL9 6LB Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomCypriotCutler20489040001
    SORSBY, Susan Jayne
    133 Thornbridge Drive
    Frecheville
    S12 4YJ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    133 Thornbridge Drive
    Frecheville
    S12 4YJ Sheffield
    South Yorkshire
    UkBritishPersonal Assistant122498100001

    Hat N.B. REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Aug. 2008
    Geliefert am 19. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £25,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies standing from time to time in the account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Grey the Santhouse Pensioneer Trustee Company Limited Margaret Gillian Grey and Mathew James Grey Being the Trustees of the Osl Pension Fund
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 2008
    Geliefert am 04. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge and legal mortgage all f/h and l/h property and fixed charge all estates or interests in any f/h or l/h property and all fixed plant and machinery and fixtures (including trade fixtures) in or attached to such property from time to time all stocks shares bonds and other securities all goodwill unpaid and/or uncalled capital all the intellectual property all the specified debts and all the other debts and floating charge the floating assets.
    Berechtigte Personen
    • Cattles Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 04. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 26. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings on the east side of smithfield sheffield.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 17. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings on the east side of smithfield, sheffield t/n SYK124527.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 17. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h land and buildings on the north east of smithfield t/no SYK269568.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 17. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings on the west side of snow lane, sheffield t/nos SYK285760 and SYK127073.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2004
    Geliefert am 17. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 32 trinity street, sheffield and the f/h land and buildings appurtenant thereto and otherwise registered as land and buildings on the west side of copper street t/nos SYK77019 and SYK75617.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h terrapin hut site at copper street (otherwise k/a and registered at hm land registry as 7 and 11 copper street) sheffield south yorkshire and wholly comprising t/no YWE51664.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property at and otherwise appurtenant to 26 trinity street (registered at hm land registry as land lying on the east side of trinity street) sheffield south yorkshire and wholly t/no SYK225413.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property comprising (a) st judes church, 99 and 100 copper street and (b) land appurtenant thereto (the latter otherwise k/a 22 copper street) sheffield south yorkshire t/no's SYK88387 and SYK185412.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Each of the l/h and f/h properties comprising and k/a 30 trinity street and emmanuel works sheffield t/no SYK74107 and SYK274620.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 34 trinity street sheffield t/no YWE30527.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 01. März 2004
    Geliefert am 06. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1982
    Geliefert am 30. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts and the benefit of licences a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    • 07. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1961
    Geliefert am 28. Apr. 1961
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc.
    Kurze Angaben
    Land with buildings between smithfield and snow lane sheffield. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1961Registrierung einer Belastung
    • 05. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat N.B. REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Jan. 2008Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    21. Jan. 2009Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Duncan
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    Praktiker
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    2
    DatumTyp
    29. Dez. 2009Ende der Verwaltung
    16. Jan. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles William Anthony Escott
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Ian Christopher Schofield
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    Praktiker
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    3
    DatumTyp
    22. Nov. 2011Aufgelöst am
    29. Dez. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles William Anthony Escott
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Ian Christopher Schofield
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    Praktiker
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0