BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)

BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00271595
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Estate Office
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Okt. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Juli 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Juni 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung21. Juni 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis07. Juni 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Change of details for Buccleuch Holdings Ltd as a person with significant control on 31. Jan. 2025

    2 SeitenPSC05

    Eintragung der Belastung 002715950038, erstellt am 10. Jan. 2025

    10 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 002715950037, erstellt am 11. Okt. 2024

    11 SeitenMR01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2023

    15 SeitenAA

    legacy

    66 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    4 SeitenAGREEMENT2

    Erfüllung der Belastung 002715950031 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 002715950032 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 002715950035, erstellt am 11. Juni 2024

    8 SeitenMR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    04. Juli 2024Other The certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which are in colour and/or larger than A4. At present, Companies House does not provide colour or larger images through our output services; therefore some elements may be illegible. If you would like to view a copy of the instrument, please call 0303 1234 500

    Eintragung der Belastung 002715950036, erstellt am 11. Juni 2024

    8 SeitenMR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    04. Juli 2024Other The certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which are in colour and/or larger than A4. At present, Companies House does not provide colour or larger images through our output services; therefore some elements may be illegible. If you would like to view a copy of the instrument, please call 0303 1234 500

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2022

    16 SeitenAA

    legacy

    69 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Marian Frances Scott als Geschäftsführer am 30. Apr. 2023

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 002715950030 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2021

    16 SeitenAA

    legacy

    72 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    4 SeitenAGREEMENT2

    Wer sind die Geschäftsführer von BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALEXANDER, Jonathan Scott
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Sekretär
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    281570550001
    HIGGINS, Bernard
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    ScotlandBritishCeo194661920001
    MONTAGU DOUGLAS SCOTT, Charles David Peter, Lord
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director232295990002
    MONTAGU DOUGLAS SCOTT, Damian Torquil Francis Charles, Lord
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector76681810014
    MONTAGU DOUGLAS SCOTT, Richard Walter John, Duke Of Buccleuch And Queensberry
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director76465960007
    MCGRATH, Michael James
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    England
    Sekretär
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    England
    British61790430001
    MILLAR, Alastair Sturrock
    4 Weatherhouse Cottages
    TD7 5HE Selkirk
    Selkirkshire
    Sekretär
    4 Weatherhouse Cottages
    TD7 5HE Selkirk
    Selkirkshire
    British276140002
    DUKE OF BUCCLEUCH & QUEENSBERRY, Walter Francis John
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    Geschäftsführer
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    BritishCompany Director533090003
    GALBRAITH, James Muir Galloway
    Rawflat
    Ancrum
    TD8 6UW Jedburgh
    Geschäftsführer
    Rawflat
    Ancrum
    TD8 6UW Jedburgh
    BritishCompany Director276160001
    GLEN, John Ronald Kerr
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    ScotlandBritishDirector134679420002
    MONTAGU-DOUGLAS SCOTT, George Francis, Lord
    Old Alms House Weekley
    Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Old Alms House Weekley
    Kettering
    Northamptonshire
    BritishRetired13144030001
    SCOTT, Elizabeth Marian Frances, Duches Of Buccleuch
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Estate Office
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director25377600002
    THE DUCHESS OF BUCCLEUCH, Her Grace
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    Selkirkshire
    Geschäftsführer
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    Selkirkshire
    BritishCompany Director42184170002
    THE DUCHESS OF BUCCLEUCH, Jane, Her Grace
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    Selkirkshire
    Geschäftsführer
    Bowhill
    TD7 5ET Selkirk
    Selkirkshire
    United KingdomBritishCompany Director42184170003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE)?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mds Group Investments Ltd
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Buccleuch Property Estate Office
    Northants
    England
    06. Apr. 2016
    Weekley
    NN16 9UP Kettering
    Buccleuch Property Estate Office
    Northants
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat BOUGHTON ESTATES LIMITED(THE) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 10. Jan. 2025
    Geliefert am 27. Jan. 2025
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    (First) all and whole (one) the property known as huntlaw and muirfield farm, forming part of the drinkstone estate, hawick, being part and portion of the land registered in the land register of scotland under title number ROX13771. (Two) all and any minerals beneath the said property being part and portion of the titles (I) all and whole the subjects described in the disposition by the buccleuch estates limited in favour of the boughton estates limited dated 10 june 2004 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 19 august 2004 and (ii) all and whole the subjects described in the disposition by the buccleuch estates limited in favour of the boughton estates limited dated 10 june 2004 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of roxburgh on 17 august 2004 the subjects (one) and (two) all as shown shaded pink on the plan 1, plan 2 and plan 3 annexed and executed as relative to the instrument accompanying the MR01 form. (Second) all and whole (one) the subjects known as and forming huntlaw farmhouse & steadings, denholm, hatwick, which subjects are part and portion of the subjects known as and forming the drinkstone estate, hatwick being the subjects registered in the land register of scotland under title number ROX13771. (Two) all and any minerals beneath the said subjects being part and portion of the titles (I) all and whole the subjects described in the disposition by the buccleuch estates limited in favour of the boughton estates limited dated 10 june 2024 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of midlothian on 19 august 2024; and (ii) all and whole the subjects described in the disposition by the buccleuch estates limited in favour of the boughton estates limited dated 10 june 2004 and recorded in the division of the general register of sasines for the county of roxburgh on 17 august 2004 the subjects (one) and (two) all as shown shaded pink on the plan 4 annexed and executed as relative to the instrument accompanying the MR01 form.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Center Parcs Scotland Limited
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2025Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Okt. 2024
    Geliefert am 15. Okt. 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the landowner’s interest in the area of land shown tinted pink on the plan annexed to the standard security which subjects form part and portion of the stone and material as described in and disponed by the disposition by the buccleuch estates limited in favour of the landowner dated 10 june 2004 and recorded in the general register of sasine in the counties of dumfries, lanark, stewartry of kirkcudbright, ayr and peebles on 2 august 2004, as more particularly described in the standard security.
    Berechtigte Personen
    • Cloud Hill Windfarm Limited
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Juni 2024
    Geliefert am 01. Juli 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the minerals beneath the surface of that area of ground at chanlockfoot sanquhar in the county of dumfries shown coloured pink on the plan land register of scotland t/no DMF32356.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sanquhar Ii Community Wind Co LTD
    Transaktionen
    • 01. Juli 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Juni 2024
    Geliefert am 01. Juli 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the minerals beneath the surface of that area of groud at glenmanna sanquhar in the county of dumfries shown coloured pink on the plan land register of scotland under t/no DMF32355.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sanquhar Ii Community Wind Co LTD
    Transaktionen
    • 01. Juli 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. Mai 2022
    Geliefert am 10. Mai 2022
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The metals, minerals and substances beneath the subjects undergoing registration in the land register of scotland under title number ROX17300 under exception of the subjects shaded green on the plan annexed to the security instrument.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Teviot Wf Limited
    Transaktionen
    • 10. Mai 2022Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Okt. 2021
    Geliefert am 15. Okt. 2021
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the metals, minerals and substances beneath subjects by hawick in the county of roxburgh.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Teviot Wf Limited
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. März 2021
    Geliefert am 02. Apr. 2021
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the minerals beneath the surface of that area of ground at chanlockfoot, sanquhar as more particularly described in the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Community Windpower Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Juli 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. März 2021
    Geliefert am 02. Apr. 2021
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All and whole the minerals beneath the surface of that area of ground at glenmanna, sanquhar in the county of dumfries as more particularly described in the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Community Windpower Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Juli 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. März 2019
    Geliefert am 19. März 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The freehold land known as 40 warkton registered at the land registry with title number NN131306 and others, for more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Buccleuch Estates Pension Trustee Company Limited as Trustee
    Transaktionen
    • 19. März 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Mai 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Feb. 2019
    Geliefert am 18. Feb. 2019
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land at hopsrig in the parish of westerkirk and county of dumfries partly shaded pink and partly shaded green on the plan annexed t/no: DMF30264.
    Berechtigte Personen
    • Hopsrig Wind Farm Limited
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Juni 2018
    Geliefert am 20. Juni 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the minerals beneath the surface of that area of ground at corse hill, sanquhar in the county of dumfries shown delineated and coloured in red on the plan annexed and executed as relative hereto and forming part and portion of the subjects more particularly described in described in and disponed by disposition by the buccleuch estates limited in favour of the boughton estates limited dated 10 june and recorded inter alia in the division of the general register of sasines for the county of dumfries on 2 august 2004.. (for further information please consult the instrument).
    Berechtigte Personen
    • Community Windpower Limited
    Transaktionen
    • 20. Juni 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Dez. 2016
    Geliefert am 30. Dez. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All and whole the subjects comprising the metals, minerals and substances capable of being worked commercially beneath and/or within (I) the land shown coloured pink on the plan marked "plan 1" annexed and signed as relative to the instrument and (ii) the land shown outlined in red on the plan marked "plan 2" annexed and signed as relative to the instrument. For more details please refer to the instrument.
    Berechtigte Personen
    • Nlei LTD
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Juli 2015
    Geliefert am 01. Aug. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Mineral interests at eckford and drinkstone estate in the county of roxburgh and part of eskdale and liddesdale estate in the county of dumfries for further details of the property charged please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Dez. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 16. Juli 2015
    Geliefert am 04. Aug. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1 weekly kettering t/no. NN288208, 2 weekly kettering t/no. NN288512, 3 weekly kettering t/no. NN288513 and 25 other properties listed in the schedule annexed to the instrument. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Dez. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 03 may 2012
    Erstellt am 24. Mai 2012
    Geliefert am 01. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the mines, minerals and substances beneath easter wooden, wester wooden and mosstower farms which mines minerals and substances form part of the subjects described in and disponed by disposition by the buccleuch estates limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security executed on 2 august 2011
    Erstellt am 09. Aug. 2011
    Geliefert am 25. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Mines minerals and substances beneath easter wooden, wester wooden and mosstower farms, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security dated 09/10/10
    Erstellt am 27. Okt. 2010
    Geliefert am 12. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole (one) all and whole the mines, minerals and substances beneath those parts of drinkstone estate, shown outlined in red on plan 2; (two) all and whole the mines, minerals and substances between those parts of eckford estate shown outlined in red on plan 1 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 2010
    Geliefert am 11. Juni 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that land and buildings;1 weekley, kettering t/no NN288208. 2 weekley, kettering t/no NN288512. 3 weekley, kettering t/no NN288513. For details of further property charged please refer to form MG01, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 18. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2008
    Geliefert am 04. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 weekley kettering northamptonshire t/no NN288208 2 weekley kettering northamptonshire t/no NN288512 3 weekley kettering northamptonshire t/no NN288513 for details of further properties charged please refer to form 395 by way of fixed charge any other interest in the property all rents receivable from any lease and the proceeds of any insurance affecting the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of variation
    Erstellt am 13. Feb. 2008
    Geliefert am 19. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each or any of the other companies named therein to the buccleuch estates limited 1974 retirement fund pension scheme under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The real property, all buildings, fixtures, plant and machinery, the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Buccleuch Estates Pension Trustees Company Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 27. März 2007
    Geliefert am 29. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each or any of the other companies named therein to the buccleuch estates limited 1974 retirement fund pension scheme under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 warkton NN16 9XJ, 10 warkton NN16 9X, 12 warkton NN16 9XH for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Buccleuch Estates Pension Trustee Company Limited as Trustee of the Scheme The
    Transaktionen
    • 29. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Mai 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage (own account)
    Erstellt am 23. Sept. 2003
    Geliefert am 01. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a 4B lakeside boulevard, doncaster. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land known as part plot s stratton business park biggleswade t/n BD230078. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Apr. 2003
    Geliefert am 28. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that f/h land known as units 4F, 4G, 4J, 4K & 4L barbot hall industrial estate, mangham road, greasborough, rotherham t/n SYK385947. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Apr. 2003
    Geliefert am 26. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that f/h land lying to the east of douglas close stockton on tees cleveland title absolute t/n CE137435. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0