TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED

TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00283092
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    • (7440) /

    Wo befindet sich TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MAIDEN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED25. Juni 199125. Juni 1991
    ARTHUR MAIDEN LIMITED29. Dez. 193329. Dez. 1933

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Dez. 2012

    9 Seiten4.68

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    13 SeitenF10.2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2012

    18 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Juni 2012

    10 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ am 26. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Jan. 2011

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Juli 2010

    13 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    33 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    9 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 186 City Road London EC1V 2NT am 26. Jan. 2010

    2 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG04

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Okt. 2009

    16 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Nov. 2009

    Kapitalaufstellung am 14. Nov. 2009

    • Kapital: GBP 1,460,225
    SH01

    legacy

    5 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    30 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    22 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    British122298900001
    ALLMAN, Donald Russell
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Geschäftsführer
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Usa113088010001
    APFELBAUM, William Michael
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Geschäftsführer
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    American113086280001
    ARNOLD, Stephen Ronald
    19 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    19 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    British85488020002
    GOLDSMITH, Scott
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Geschäftsführer
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American111559610001
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish122298900001
    MOUG, Andrew John
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    EnglandBritish85481770002
    SLATKIN, Jonathan Aaron
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Geschäftsführer
    Flat 36 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Usa117628600001
    HOLME, Michael Alan Holt
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    British45837310001
    SAVAGE, Timothy John
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    British8871460006
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Sekretär
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    British114617510001
    BLACKBURN, Richard James
    9 Sandes Close
    SN15 2NH Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    9 Sandes Close
    SN15 2NH Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish85487950001
    BLAKESLEY, Graham
    9 Salmons Mews
    West Cottages
    NW6 1RH London
    Geschäftsführer
    9 Salmons Mews
    West Cottages
    NW6 1RH London
    British41933580002
    BOUCHEZ, Helena Mary
    51 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    51 Grove Way
    KT10 8HQ Esher
    Surrey
    Irish85488050001
    CECILE-PRITCHARD, Joan Emily
    Penn Ridge
    Church Road Penn
    HP10 8NU High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Penn Ridge
    Church Road Penn
    HP10 8NU High Wycombe
    Buckinghamshire
    British1526040001
    DRON, David John Anthony
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British1730460002
    FERNLEY, Roger Laurence
    50 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    50 St Cross Road
    SO23 9PS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish44036150004
    GOODWIN, Francis Dominic
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom127055040001
    GOULD, Catherine Ann
    62a Aberdeen Road
    N2 2XB London
    Geschäftsführer
    62a Aberdeen Road
    N2 2XB London
    British85487800001
    HALDEN, Simon Mark
    Ground Floor Flat 60 Prebend Gardens
    W6 0XU London
    Geschäftsführer
    Ground Floor Flat 60 Prebend Gardens
    W6 0XU London
    British76543560001
    HARTLEY, Garry Robert
    8 De Pirenore
    Hazlemere
    HP15 7FQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    8 De Pirenore
    Hazlemere
    HP15 7FQ High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15306460004
    HOLME, Michael Alan Holt
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Firs 10 Old Farmhouse Drive
    Oxshott
    KT22 0EY Leatherhead
    Surrey
    British45837310001
    KEARNS, Martin Paul
    15 Cambrian Road
    E10 7JE London
    Geschäftsführer
    15 Cambrian Road
    E10 7JE London
    EnglandBritish142291100001
    MACEY, Julian Spencer
    50 Weston Park
    KT7 0HL Thames Ditton
    Surrey
    Geschäftsführer
    50 Weston Park
    KT7 0HL Thames Ditton
    Surrey
    British63444820001
    MAIDEN, Ian Arthur
    38 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 5BY London
    Geschäftsführer
    38 Old Church Street
    Chelsea
    SW3 5BY London
    British41370001
    MILES, Philip Howard
    32b Westwell Road
    SW16 5RT London
    Geschäftsführer
    32b Westwell Road
    SW16 5RT London
    British85487990001
    POWELL, Ian
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    EnglandBritish33706140001
    PUGH, David John
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Geschäftsführer
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    British70814670001
    REAY, Alison
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    EnglandBritish113085780001
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    British114617510001
    WARD, Hazel Patricia Alexandra
    Tudor Dean Homedean Road
    Chipstead
    TN13 2QN Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Tudor Dean Homedean Road
    Chipstead
    TN13 2QN Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish34911180002
    ZEGHIBE, Ronald William
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    Geschäftsführer
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    United KingdomAmerican51349440001

    Hat TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed
    Erstellt am 14. Aug. 2009
    Geliefert am 21. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed continuing mortgage rights title interest and benefit from time to time present and future under and in respect of each of the asset purchase agreement see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 07. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 12. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 15. Juni 2004
    Geliefert am 18. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £25,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transaktionen
    • 18. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 05. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from maiden group PLC to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 1995
    Geliefert am 29. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 14 half moon street london ngl 459043. l/h property k/a fifth floor, churchill house titheborn street liverpool (MS108483). L/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 granville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limitedthe "Security Agent"
    Transaktionen
    • 29. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1995
    Geliefert am 25. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) top the chargee under each or any of the finance documents or any other document
    Kurze Angaben
    See shedule attached to form M395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders (as Defined)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1993
    Geliefert am 22. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the financing documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    (For full details see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (In It's Capacity as Security Trustee) and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 1987
    Geliefert am 06. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stock-in-trade worrk-in-progress prepayments, investments and cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 06. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge on book debts.
    Erstellt am 29. Juni 1987
    Geliefert am 04. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts present and future.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of deposit
    Erstellt am 15. Juli 1985
    Geliefert am 17. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All moneys deposited by the chargee in the name of the company with investors in industry group PLC.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 12. Juli 1979
    Geliefert am 19. Juli 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 9.5.77.
    Kurze Angaben
    Fixed charge on f/h plot of land known as 37 osborne rd, bedminster, bristol, together with seven lock up garages and buildings erected thereon all of which are shown edged red on the plan filed under title no av 21311.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transaktionen
    • 19. Juli 1979Registrierung einer Belastung
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge registrered pursuant to an order of court dated 12.9.78 (M81)
    Erstellt am 03. Juli 1978
    Geliefert am 15. Sept. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 9.5.77
    Kurze Angaben
    Properties under title nos: ln 167384, 229306, sy 117493, ln 23968, 413203, 331602, 93569, 341725, 328947, 316167, 439386, 294908, sgl 152935, ln 167380, 357779, k 50662, mx 436927, sy 7040, ln 15153 with all building & fixtures (including, trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1978Registrierung einer Belastung
    • 07. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Mai 1977
    Geliefert am 20. Mai 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing the monies advanced under the terms of an agreement dated 9/5/77 all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All book and other debts see doc M79 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    Transaktionen
    • 20. Mai 1977Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 26. Apr. 1977
    Geliefert am 02. Mai 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge: (see doc m 78). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1977Registrierung einer Belastung
    • 07. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TITAN OUTDOOR ADVERTISING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Juni 2011Ende der Verwaltung
    18. Jan. 2010Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stuart Charles Edward Mackellar
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    06. Dez. 2013Aufgelöst am
    16. Juni 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0