JTB REALISATIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JTB REALISATIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00288766 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JTB REALISATIONS LIMITED?
- Einzelhandel mit Schuhen in spezialisierten Geschäften (47721) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich JTB REALISATIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JTB REALISATIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
A. JONES & SONS LIMITED | 04. Juni 1934 | 04. Juni 1934 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JTB REALISATIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JTB REALISATIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 32 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 32 Seiten | AM23 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 28 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 31 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 36 Seiten | AM10 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 12 Seiten | AM02 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed A. jones & sons LIMITED\certificate issued on 03/05/17 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 44 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England zum 15 Canada Square London E14 5GL am 09. Apr. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2016 bis 28. Feb. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Edward Cook als Geschäftsführer am 27. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David John Riddiford als Direktor am 19. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Robert Short als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 002887660014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 002887660018, erstellt am 22. Sept. 2016 | 70 Seiten | MR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom A Jones & Sons Limited Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon Coalville Leicestershire LE67 1LD England zum Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG am 08. Aug. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von JTB REALISATIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILLICK, Michael David | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | Wales | British | Cfo | 75927820002 | ||||
RIDDIFORD, David John | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | Executive Chairman | 220918310001 | ||||
JOHNSON, David Edward | Sekretär | 20 Great Footway Langton Green TN3 0DT Tunbridge Wells Kent | British | 10571470001 | ||||||
TODD, Jeremy | Sekretär | West Street TN20 6DS Mayfield Knowle Way East Sussex United Kingdom | British | Finance Director | 109143970003 | |||||
WHITE, Andrew Robert | Sekretär | 18 Maple Road Eastbourne BN23 6NZ East Sussex | British | 159789980001 | ||||||
BARTLE, Kenneth | Geschäftsführer | Mill Hill Rattlesden IP30 0SQ Bury St Edmunds The Smock Mill, Hitchcocks Mill Suffolk United Kingdom | England | British | Director | 73909180007 | ||||
BARTLE, Kenneth | Geschäftsführer | The Smock Mill Hitchcocks Mill Mill Hill Rattlesden IP30 0SQ Bury St Edmunds Suffolk | England | British | Retail Consultant | 73909180007 | ||||
BOOT, Terry Michael | Geschäftsführer | Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon LE67 1LD Coalville A Jones & Sons Limited Leicestershire England | England | British | Cfo | 67041160001 | ||||
CHURCH, John George | Geschäftsführer | The Old Rectory Farthingstone NN12 8EZ Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 12963560001 | ||||
CLARK, Lancelot Pease | Geschäftsführer | Apartment 142 Archie Street SE1 London | British | Manager | 28161570002 | |||||
COOK, Simon Edward | Geschäftsführer | 1 Wheatfield Way LE10 1YG Hinckley Outersole House Leicestershire England | England | British | Cpo | 104673410002 | ||||
COORENS, Eric Maria Hendrikus | Geschäftsführer | Interlink Way West, Interlink Business Park LE67 1LD Bardon, Coalville Macintosh Fashion Uk Leicestershire United Kingdom | Netherlands | Dutch | Chief Operating Officer | 157586370001 | ||||
CRAWSHAW, John | Geschäftsführer | 2 Hyde Tynings Close BN20 7TQ Eastbourne East Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 121560001 | ||||
DE MOOR, Frank Karel | Geschäftsführer | Interlink Way West, Interlink Business Park LE67 1LD Bardon, Coalville Macintosh Fashion Uk Leicestershire United Kingdom | Belgium | Belgian | Chief Executive Office | 159745220001 | ||||
DUNCAN SMITH, Alastair David | Geschäftsführer | 94 Wakehurst Road SW11 6BT London | British | Business Manager | 69076490001 | |||||
HUNEN, Peter Therese Antoon | Geschäftsführer | Interlink Way West, Interlink Business Park LE67 1LD Bardon, Coalville Macintosh Fashion Uk Leicestershire United Kingdom | Netherlands | Dutch | Company Secretary | 159744910001 | ||||
JELINEK, Vaclav | Geschäftsführer | 2 Avenue Place, Avenue Lane BN21 3RB Eastbourne East Sussex | British | Retail Executive | 109139210002 | |||||
JOHNSON, David Edward | Geschäftsführer | 20 Great Footway Langton Green TN3 0DT Tunbridge Wells Kent | British | Chartered Accountant | 10571470001 | |||||
KENNEDY, Iain Manning | Geschäftsführer | 3 Townsend Close NN6 9HP Hanging Houghton Northamptonshire | England | British | Company Director | 187882990001 | ||||
NOBLE, Alison Jane Bennett | Geschäftsführer | 82 Gayville Road SW11 6JP London | United Kingdom | British | Retail Buyer | 103289830002 | ||||
PHILLIPS, Peter John | Geschäftsführer | Gibraltar Lane Cookham Dean SL6 9TR Maidenhead Gibraltar House Berkshire United Kingdom | England | British | Director | 51075400001 | ||||
PHILLIPS, Peter John | Geschäftsführer | St. Peter Street SL7 1NQ Marlow The Minnows Buckinghamshire United Kingdom | British | Company Director | 51075400002 | |||||
SHORT, David Robert | Geschäftsführer | 1 Wheatfield Way LE10 1YG Hinckley Outersole House Leicestershire England | England | British | Ceo | 38957690003 | ||||
SHORTEN, Paul William | Geschäftsführer | Kinell Windmill Green Stone Cross BN24 5DY Pevensey East Sussex | British | Company Director | 33661480001 | |||||
STRIJBOS, Theodorus Leonardus | Geschäftsführer | Interlink Way West, Interlink Business Park LE67 1LD Bardon, Coalville Macintosh Fashion Uk Leicestershire United Kingdom | Netherlands | Dutch | Chief Financial Officer | 157586510001 | ||||
TODD, Jeremy | Geschäftsführer | West Street TN20 6DS Mayfield Knowle Way East Sussex United Kingdom | England | British | Company Director | 109143970003 | ||||
WALTON JONES, Howard | Geschäftsführer | Robin Hill Tilley Lane Boreham Street BN27 4UT Hailsham East Sussex | British | Company Director | 20804560001 | |||||
WATKINSON, John Dudley | Geschäftsführer | Glebe Farm Old Weston Road PE28 5AG Brington Cambs | England | British | Director | 66949520004 | ||||
WHITE, Andrew Robert | Geschäftsführer | Highgate Drive Knighton LE2 6HJ Leicester 31 Leicestershire United Kingdom | England | British | Director | 146324190001 |
Hat JTB REALISATIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 22. Sept. 2016 Geliefert am 28. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 15. Feb. 2016 Geliefert am 17. Feb. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 26. Okt. 2015 Geliefert am 02. Nov. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 26. Okt. 2015 Geliefert am 02. Nov. 2015 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2014 Geliefert am 25. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2014 Geliefert am 25. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2010 Geliefert am 18. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Nov. 2005 Geliefert am 16. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2002 Geliefert am 02. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. März 2002 Geliefert am 21. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Feb. 2002 Geliefert am 23. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental mortgage to a debenture dated 22 february 2001, | Erstellt am 16. Aug. 2001 Geliefert am 03. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever, of each obligor to the lender | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the property being all that l/h premises k/a 53 west street horsham west sussex, all that l/h premises k/a number 30-32 the promenade cheltenham gloucestershire, all that l/h premises k/a 40 high street reigate surrey RH2 9AT, all that l/h premises k/a 103-105 terminus road eastbourne east sussex, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture to a debenture dated 22 february 2001 made between (amongst others) the chargor and burdale financial limited | Erstellt am 10. Aug. 2001 Geliefert am 31. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee (all terms as defined) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all of its right title and interest in and to the additional collection account and all monies standing to the credit of the additional collection account and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 22. Feb. 2001 Geliefert am 07. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facility agreement (all terms as defined) | |
Kurze Angaben In order to provide continuing security for the payment or performance of the obligation in the agreement the obligor vested possession of the certificates of title to the collateral in the secured party (or its agent) to the intent that the secured party should have a security interest or interests in the collateral in accordance with article 2 (3) of the 1983 law but so that the secured party should not in any circumstances incur any liability or be under any obligation whatsoever in connection with the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of debenture made between, amongst others, the company and the chargee | Erstellt am 22. Feb. 2001 Geliefert am 07. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 22. Feb. 2001 Geliefert am 07. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and in accordance with the terms of an agreement of even date | |
Kurze Angaben Floating charge. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security | Erstellt am 20. Apr. 1995 Geliefert am 21. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First floor office premises at 56 hanover street edinburgh. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat JTB REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0