SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED

SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00294232
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. März 2015

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 06. März 2015

    14 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Sept. 2014

    43 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    2 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    130 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Hanbury Court Harris Business Park, Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove Worcestershire B60 4DJ* am 13. März 2014

    2 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Crawley als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 151,566.7
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Hanbury Court Harris Business Park, Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove Worcestershire B60 4JJ United Kingdom* am 10. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Glen Donald Hanbury Court Hariss Business Park Stoke Prior Bromsgrove B60 4JJ United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Beendigung der Bestellung von Alan Murray als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Glen Donald Room 114-115 Cornwall Buildings 45-51 Newhall Street Birmingham B3 3QR United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 02. Okt. 2012 bis 31. Dez. 2012

    1 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Richmond Gate Hotel Richmond Hill Richmond upon Thames Surrey TW10 6RP* am 27. Aug. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Okt. 2011

    11 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2012 bis 02. Okt. 2011

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Feb. 2011

    9 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRENT, James Stephen
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    Geschäftsführer
    Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    125
    EnglandBritishNone146907760002
    WELBOURN, Philip Matthew
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Geschäftsführer
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director135168350001
    BOOTE, Robert Edward
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    Sekretär
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    British5533200001
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Sekretär
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    BritishFinance Director5754090003
    COLLINS, Robin Evan
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    EnglandBritishHotelier5533210001
    CRAWLEY, Nicholas Davd Townsend
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Geschäftsführer
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director146568590001
    CRAWLEY, Nicholas David Townsend
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    England
    Geschäftsführer
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    England
    EnglandEnglishCompany Director96980780001
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director5754090003
    MURRAY, Alan John
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Geschäftsführer
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director104826920002

    Hat SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. Jan. 2011
    Geliefert am 15. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Juli 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 06. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the properties,second fixed charge all present and future interest of the company in or over f/h and l/h property,all present and future rights licences guarantees rents deposits contracts covenants and warranties see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robin Evan Collins
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Juli 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H moorland links hotel yelverton t/no:DN466858 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H southampton park hotel 13 and 13 cumberland place southampton hampshire t/no:HP618323 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of guarantee and legal mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 2008
    Geliefert am 24. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from forestdale hotels limited and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land being moorland links hotel yelverton t/no DN466858. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Flodrive UK V Property 1 Sarl
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as southampton park hotel,12 and 13 cumberland place southampton hants. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as moorland links hotel,yelverton devon. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    19,838 ordinary shares in the share capital of parade hotels (bath) limited and all stocks,shares and other securities thereon and all certificates and other documents of title deposited.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Okt. 1982
    Geliefert am 03. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts legal mortgage over:- southampton park hotel cumberland place southampton and moorland links hotel yelverton devonshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 1938
    Geliefert am 20. Jan. 1938
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £43000
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Branch Nominees LTD
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1938Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 12. Okt. 1937
    Geliefert am 29. Okt. 1937
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys etc
    Kurze Angaben
    Freehold court royal 10 northland rd southampton title P164346. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Bank
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1937Registrierung einer Belastung
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SOUTHERN COUNTIES HOTELS (SOUTHAMPTON) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. März 2015Ende der Verwaltung
    07. März 2014Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    James Joseph Bannon
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    Praktiker
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0