SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00301946 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
- (5242) /
Wo befindet sich SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Toronto Square Toronto Street LS1 2HJ Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SPECIALITY RETAIL GROUP PLC | 27. Nov. 1995 | 27. Nov. 1995 |
| SUITS YOU PLC | 20. Juni 1988 | 20. Juni 1988 |
| BRICKS MANS SHOPS LIMITED | 19. Juni 1935 | 19. Juni 1935 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Feb. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Okt. 2012 | 14 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 15 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. März 2012 | 12 Seiten | 4.68 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 1 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | F10.2 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPENTER, Scott Keith | Geschäftsführer | 124 High Street TW12 1NS Hampton Hill Central House Middlesex | United States | American | 145987830001 | |||||
| GEORGE, Gavin Michael | Geschäftsführer | 124 High Street TW12 1NS Hampton Hill Central House Middlesex | United Kingdom | British | 148227120001 | |||||
| BRICK, Alexander Paul | Sekretär | 12 The Bishops Avenue N2 0AN London | British | 122889900001 | ||||||
| COCKIN, Anna Margaret | Sekretär | 16 Manor House Estate HA7 4BH Stanmore Middlesex | British | 95030040001 | ||||||
| PAUL, Richard Neil | Sekretär | 21 Almsford Avenue HG2 8HD Harrogate North Yorkshire | British | 43099210003 | ||||||
| SPERRY, Ian Nicholas | Sekretär | 8 St. Thomas Place Wheathampstead AL4 8BG St. Albans Hertfordshire | British | 106924330002 | ||||||
| ARAFA, Alaa, Dr | Geschäftsführer | Aluaza St Helipolis Cairo 42 Egypt | Egypt | Egyptian | 131943020001 | |||||
| BENTLEY, Simon Anthony | Geschäftsführer | Glen Wood House 5 Cedars Close NW4 1TR London | United Kingdom | British | 3007630001 | |||||
| BERNARD, Henry | Geschäftsführer | 9 North Riding Bricket Wood AL2 3LH St Albans Hertfordshire | British | 45597530001 | ||||||
| BRICK, Alexander Paul | Geschäftsführer | 12 The Bishops Avenue N2 0AN London | England | British | 122889900001 | |||||
| BRICK, Anthony Allan | Geschäftsführer | 11 Pangbourne Drive HA7 4QS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 34122180001 | |||||
| BRICK, Brian Denis | Geschäftsführer | 28 Aylmer Drive HA7 3EG Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 9649690002 | |||||
| COTTER, Mark Michael Sean | Geschäftsführer | Little Garth Lords Moor Lane Strensall YO32 5XF York North Yorkshire | England | British | 73990340003 | |||||
| EL FAR, Saher | Geschäftsführer | Abou Dawoud Al Zahari St 50 Cairo Egypt | Egyptian | 131643360001 | ||||||
| FREEDMAN, Jonathan Sydney | Geschäftsführer | 9 Eastglade HA5 3AN Pinner Middlesex | British | 5232410001 | ||||||
| GIPSON, Stephen | Geschäftsführer | The Engine House 2 Leigh Court Barns WR6 5LB Leigh Worcestershire | Great Britain | British | 98785200001 | |||||
| GUZZETTI, Aristide | Geschäftsführer | Via Dei Baiardi 93/2 Trieste Italy | Italian | 97837570001 | ||||||
| HALLETT, Peter John | Geschäftsführer | Goldfields Glenhill Farm Glendon Road NN14 1QE Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HARTLEY, Stephen Russell | Geschäftsführer | 51 Greenway Close N20 8ES London | British | 72483640007 | ||||||
| HASHEM, Maha | Geschäftsführer | Gamel Dowal El Arabaa-Mohandeseen Giza 8 Egypt | Egyptian | 131942790001 | ||||||
| JOHNSON, Steven Leslie | Geschäftsführer | 4 The Knoll MK16 9NZ Sherington Buckinghamshire | England | British | 183186080001 | |||||
| KELLY, Deborah Jane | Geschäftsführer | 146 Gammons Lane WD24 5HY Watford Hertfordshire | British | 88831730003 | ||||||
| KEYTE, Nick | Geschäftsführer | 14 The Mead BR3 5PE Beckenham Kent | British | 115552050001 | ||||||
| LUCAS, Peter | Geschäftsführer | The Old Rectory Oswaldkirk YO62 5XT York | England | British | 5858840002 | |||||
| MARSHALL, Robert Gavin | Geschäftsführer | 1 Canal Wharf Holbeck LS11 5BB Leeds Granary Building West Yorkshire | United Kingdom | British | 139110060001 | |||||
| MIDDLETON, Alison | Geschäftsführer | 36 Drifters Drive Deepcut Camberley GU16 6GT Guildford Surrey | United Kingdom | British | 116051660001 | |||||
| NORCLIFFE, John Martyn | Geschäftsführer | 1 Canal Wharf LS11 5BB Leeds Granary Building West Yorkshire England | England | British | 155008850001 | |||||
| PAUL, Richard Neil | Geschäftsführer | 21 Almsford Avenue HG2 8HD Harrogate North Yorkshire | England | British | 43099210003 | |||||
| RICH, Michael John | Geschäftsführer | St Bees School Lane Bricket Wood AL2 3XS St Albans Hertfordshire | England | British | 189317060001 | |||||
| RIVERS, Paul Edward | Geschäftsführer | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | England | British | 62321110002 | |||||
| SCOTT, Charles Thomas | Geschäftsführer | Chase Manor Farm Lickfold Road, Fernhurst GU27 3JA Haslemere Surrey | England | British | 57006540003 | |||||
| SPERRY, Ian Nicholas | Geschäftsführer | 8 St. Thomas Place Wheathampstead AL4 8BG St. Albans Hertfordshire | British | 106924330002 | ||||||
| THOMSON, Andrew David | Geschäftsführer | 1 Canal Wharf LS11 5BB Leeds Granary Building West Yorkshire England | England | British | 155008430001 | |||||
| WOODHOUSE, Anthony John | Geschäftsführer | Groesfaen Road Peterston-Super-Ely CF5 6NE Cardiff Elm House | United Kingdom | British | 131678400001 | |||||
| WRIGHT, Adrian James | Geschäftsführer | The Copse 10a Copsem Lane KT10 9EU Esher Surrey | United Kingdom | British | 89162730002 |
Hat SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Erstellt am 15. Juni 2010 Geliefert am 30. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Mai 2008 Geliefert am 20. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2007 Geliefert am 27. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over accounts | Erstellt am 06. Juli 2007 Geliefert am 17. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The account named bbre speciality retail group numbered 60853216 sort code 20-80-57. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplement deed | Erstellt am 25. Mai 2006 Geliefert am 09. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Nov. 2005 Geliefert am 13. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee and or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Mai 2000 Geliefert am 24. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 69 kesington way borehamwood hertfordshire t/n HD379236. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1998 Geliefert am 23. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 175 high street hounslow l/b of hounslow t/n NGL562548. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 04. Aug. 1993 Geliefert am 14. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £61039.90 | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1992 Geliefert am 03. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 234 (formerly unit 119) lakeside shopping centre thurrock essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Feb. 1992 Geliefert am 24. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ground floor and basement shop 55,57, and 59 oxford street & 2 soho street l/b of city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Mai 1991 Geliefert am 10. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 175, high street, hounslow, london borough of hounslow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. März 1991 Geliefert am 26. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 031, whiteleys queensway, bayswater london borough of city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Juli 1990 Geliefert am 14. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Basement and ground floors of 372 oxford street, being part of the building and all and any part of such property and any additions thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Juli 1990 Geliefert am 24. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit no: su 119 thurrock lakeside shopping centre west thurrock essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Mai 1990 Geliefert am 21. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 (infill site) wood green shopping city high road, wood green l/b of haringey. Title no:- ngl 355496. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1990 Geliefert am 02. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 49 the parade high street watford hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1990 Geliefert am 02. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of basement and ground floor of 55/59 (odd nos only) oxford street l/b of the city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Jan. 1990 Geliefert am 02. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The ground floor and basement 77 high street and 1 mackenzie street slough buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Sept. 1989 Geliefert am 14. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 67, the friary, north street, guildford, surrey. Title no. Sy 594596. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juni 1988 Geliefert am 15. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of ground floor at 129/133 high street slough buckinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juni 1988 Geliefert am 06. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 175 high street hounslow l/b of hounslow. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juni 1988 Geliefert am 06. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ground floor and basement of 55, 57 and 59 oxford street and 2 solo street l/b of city of westminster. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. März 1988 Geliefert am 08. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 5 park industrial estate frogmore st. Albans title no hd 213420. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Feb. 1988 Geliefert am 15. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 5 park industrial estate, frogmore, 56 albans, hertfordshire. Title no. Hd 213240. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SPECIALITY RETAIL GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0