HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00308512 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 133 Houndsditch London EC3A 7AH |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
HEATH INSURANCE SERVICES LIMITED | 30. Okt. 1996 | 30. Okt. 1996 |
C E HEATH (INSURANCE SERVICES) LIMITED | 28. Nov. 1990 | 28. Nov. 1990 |
B & C INSURANCE BROKERS (UK) LIMITED | 02. Aug. 1989 | 02. Aug. 1989 |
B & C INSURANCE BROKERS LIMITED | 01. Juli 1988 | 01. Juli 1988 |
CAYZER STEEL BOWATER (LONDON) LIMITED | 13. Aug. 1985 | 13. Aug. 1985 |
TENNANT BUDD LIMITED | 21. Dez. 1935 | 21. Dez. 1935 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William David Bloomer als Geschäftsführer am 10. Okt. 2011 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2011 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2010 bis 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 29 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 1 Seiten | CC04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2010 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 2 Seiten | SH10 | ||||||||||
Ernennung von Mr Adrian Colosso als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bruce als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(288) | ||||||||||
legacy | Seiten | 363(353) | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 |
Wer sind die Geschäftsführer von HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | 133 Houndsditch EC3A 7AH London | 43700080007 | |||||||
COLOSSO, Adrian | Geschäftsführer | Burnham Road Woodham Mortimer CM9 6SP Maldon Hillside Farm Essex | England | British | Group Chief Executive | 4555310002 | ||||
THOMAS, Robert Nigel | Geschäftsführer | South West House Weston Road BA1 2XU Bath Avon | United Kindgom | British | Accountant | 40630840002 | ||||
SHARP, Pandora | Sekretär | Flat 9 Da Vinci Court 1 Rossetti Road SE16 3EA London | British | 64972020003 | ||||||
WILKINSON, Sidney James | Sekretär | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||
BAREHAM, Robert Edward | Geschäftsführer | Squirrels 33 Bidborough Ridge TN4 0UT Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 8522090001 | ||||
BARTLETT, Steven James | Geschäftsführer | 10 Ash Meadow Willesborough TN24 0LW Ashford Kent | England | British | Insurance Broker | 47527700001 | ||||
BLOOMER, William David | Geschäftsführer | Barry Road East Dulwich SE22 0JS London 214 | United Kingdom | British | Company Solicitor | 72374560002 | ||||
BRUCE, Michael Andrew | Geschäftsführer | Royston Manor St Peter's Lane Clayworth DN22 9AA Retford Nottinghamshire | United Kingdom | British | Group Managing Director | 61928170002 | ||||
CONSTABLE, Robert Mark | Geschäftsführer | 9 Mount Road GU6 7LT Cranleigh Surrey | British | Insurance Broker | 115305700001 | |||||
DRUMMOND, Peter David | Geschäftsführer | Angel House Angel Street GU28 0BJ Petworth West Sussex | British | Insurance Broker | 34676460002 | |||||
GARNHAM, Jasper Meredydd | Geschäftsführer | Harewood Lodge Bulstrode Way SL9 7QT Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Insurance Broker | 8522110001 | |||||
IRONMONGER, Richard Kenneth | Geschäftsführer | Briar Cottage Broadmore Lane IP25 6TE Carbrooke Norfolk | British | Insurance Broker | 8852330004 | |||||
JERVIS, Ian Michael Peter | Geschäftsführer | 1 Hove Park Way BN3 6PS Hove East Sussex | British | Insurance Broker | 77237610001 | |||||
KAUFMAN, John Banwell | Geschäftsführer | 6 Scotsdale Close BR5 1NU Petts Wood Kent | England | British | Insurance Broker | 147388510001 | ||||
KIER, Michael Hector | Geschäftsführer | 23 Belmont Road TW2 5DA Twickenham Middlesex | Danish | Lloyds Broker | 8719670001 | |||||
MANSFIELD, Diane Frances | Geschäftsführer | Barton Crossways Park, West Chiltington RH20 2QZ Pulborough West Sussex | British | Chartered Accountant | 64151360001 | |||||
MARGRETT, David Basil | Geschäftsführer | 60 Deansway Finchley N2 0JE London | British | Insurance Broker | 313150002 | |||||
ROWE, Nicholas | Geschäftsführer | Amberly House The Cleave OX11 0EL Harwell Oxfordshire | British | Company Secretary | 33862660001 | |||||
RUNCIMAN, Jeffrey Keith | Geschäftsführer | 7 Pinfold Close Hale Barns WA15 0SA Altrincham Cheshire | British | Insurance Broker | 10020520001 | |||||
SANSOM, Richard James | Geschäftsführer | 12 Birch Mead Locksbottom BR6 8LT Orpington Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 105966060001 | ||||
SIMPER, Anthony | Geschäftsführer | 21 Lambourn Way Lords Wood ME5 8PU Chatham Kent | British | Insurance Broker | 34987510001 | |||||
SMITH, Paul David | Geschäftsführer | Applegarth Faygate Lane, Rusper RH12 4RF Horsham West Sussex | England | British | Insurance Broker | 8522160002 | ||||
SPRINGBETT, David John | Geschäftsführer | Abbey House Huntercombe Lane South Taplow SL6 0PQ Maidenhead Berkshire | British | Insurance Broker | 12798880001 | |||||
SUMMERS, Paul John | Geschäftsführer | 14 Whorlton Road SE15 3PD London | British | Insurance Broker | 28330910003 | |||||
WAKELING, Julian David | Geschäftsführer | 18 Lightwater Meadow GU18 5XH Lightwater Surrey | England | British | Insurance Broker | 34987520001 | ||||
WARBURTON, Brian | Geschäftsführer | Great Mead Standon Green End High Cross SG11 1BP Ware Hertfordshire | British | Insurance Broker | 8514310001 | |||||
WILKINSON, Ian Michael Colin | Geschäftsführer | Fuggles Oast Amber Lane Chart Sutton ME17 3SF Maidstone Kent | British | Insurance Broker | 28330920001 |
Hat HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Feb. 2000 Geliefert am 09. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 18 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation") | Erstellt am 23. Sept. 1999 Geliefert am 01. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no.5 Of 1988) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second guarantee and debenture | Erstellt am 03. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation | Erstellt am 01. Nov. 1993 Geliefert am 10. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For varying the terms of the security trust deed dated 18 september 1989 | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 16. Mai 1990 Geliefert am 31. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of a sum of sterling pounds 75,000 placed on call deposit with barclays de zoete wedd on 16-5-90 under deal reference no 495002, in name of barclays bank PLC re b & c insurance brokers (UK) limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security and trust deed | Erstellt am 18. Sept. 1989 Geliefert am 23. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 23. Feb. 1983 Geliefert am 04. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (see doc M135 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0