EXCELSIOR HOTELS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEXCELSIOR HOTELS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00318898
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich EXCELSIOR HOTELS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ship Canal House 8th Flooor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für EXCELSIOR HOTELS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2021

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB zum Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street Manchester M2 4WU am 11. Nov. 2020

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2020

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB zum Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB am 16. März 2020

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2019

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2018

    5 Seiten4.68

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2017

    9 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ zum 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 01. Sept. 2016

    6 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2016

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2015

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2014

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2014

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2013

    9 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STARMAN SECRETARIES LIMITED
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    Sekretär
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    98359920004
    CAMPBELL, Blair Patrick
    2
    120 Goldburst Terrace
    NW6 3HR London
    Geschäftsführer
    2
    120 Goldburst Terrace
    NW6 3HR London
    United KingdomNew Zealander112856760002
    NIXON, Edward John
    Flat 2
    3 Copse Hill
    SW20 0NA Wimbledon
    London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    3 Copse Hill
    SW20 0NA Wimbledon
    London
    United KingdomBritish120665260001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British49678170001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Sekretär
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    British39862810001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Sekretär
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Sekretär
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    SIMS, Roy John Peter
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    Sekretär
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    British12396130001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Sekretär
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Sekretär
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Sekretär
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Sekretär
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish49678170001
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Geschäftsführer
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritish55689440001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    British39862810001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Geschäftsführer
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KANDERS, Alan J
    Suite 2a
    500 West End Avenue
    YO23 7DE New York
    North Yorkshire
    United States
    Geschäftsführer
    Suite 2a
    500 West End Avenue
    YO23 7DE New York
    North Yorkshire
    United States
    United States Citizen114506230001
    LAMBERT, Bernard Charles Hector
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    Geschäftsführer
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    AustriaFrench60956020002
    LOVETT, Norman
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    Geschäftsführer
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    British49941610001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Geschäftsführer
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MAHONEY, Richard Lee
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Geschäftsführer
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    American78240440004
    MALONEY, David Ossian
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69071800002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    RILEY, Robert Earl
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    Geschäftsführer
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    United States Citizen95184480002
    SIMS, Roy John Peter
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    British12396130001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritish67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Geschäftsführer
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish37564540001
    FORTE (UK) LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Geschäftsführer
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42204690001

    Hat EXCELSIOR HOTELS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Subordination agreement
    Erstellt am 22. Nov. 2005
    Geliefert am 05. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has undertaken to the chargee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities, in each case the junior creditors concerned shall hold the same upon trust for the security agent for aplication in or towards payment of all the senior liabilities,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank (Portugal) S.A.
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 15. Apr. 2003
    Geliefert am 01. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Portuguese public deed executed outside the UK and comprising of property situated there
    Erstellt am 05. Juli 2002
    Geliefert am 06. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the right to all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors
    Erstellt am 11. Juli 2001
    Geliefert am 26. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Juli 1931
    Erworben am 29. Sept. 1936
    Geliefert am 20. Okt. 1936
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £4,000 (owing)
    Kurze Angaben
    7, the esplanade, scarborough.
    Berechtigte Personen
    • B.E. Ross.
    • W.M. Walker
    • A.D. Walker
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1936Registrierung einer Belastung
    • 22. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Juni 1923
    Erworben am 29. Sept. 1936
    Geliefert am 20. Okt. 1936
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £15,000 (owing)
    Kurze Angaben
    The royal crescent hotel, filey and goodwill.
    Berechtigte Personen
    • A.D. Walker.
    • W.M. Walker
    • B.E. Ross.
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1936Registrierung einer Belastung
    • 22. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Juni 1923
    Erworben am 29. Sept. 1936
    Geliefert am 20. Okt. 1936
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £27000 (owing)
    Kurze Angaben
    The crown hotel, scarborough and goodwill.
    Berechtigte Personen
    • W.M. Walker
    • B.E. Ross.
    • A.D. Walker
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1936Registrierung einer Belastung
    • 22. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EXCELSIOR HOTELS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. März 2022Soll aufgelöst werden am
    14. Feb. 2008Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles Peter Holder
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praktiker
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praktiker
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Catherine Williamson
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    United Kingdom
    Praktiker
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    United Kingdom

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0