EXCELSIOR HOTELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EXCELSIOR HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00318898 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich EXCELSIOR HOTELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street M2 4WU Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EXCELSIOR HOTELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2021 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2021 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB zum Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street Manchester M2 4WU am 11. Nov. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2020 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB zum Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB am 16. März 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2020 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2019 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2019 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2018 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2018 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2017 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2017 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ zum 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 01. Sept. 2016 | 6 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2016 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2016 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2015 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2014 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Feb. 2014 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Aug. 2013 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von EXCELSIOR HOTELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARMAN SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Hesketh House 43-45 Portman Square W1H 6HN London | 98359920004 | |||||||
| CAMPBELL, Blair Patrick | Geschäftsführer | 2 120 Goldburst Terrace NW6 3HR London | United Kingdom | New Zealander | 112856760002 | |||||
| NIXON, Edward John | Geschäftsführer | Flat 2 3 Copse Hill SW20 0NA Wimbledon London | United Kingdom | British | 120665260001 | |||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Sekretär | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | British | 49678170001 | ||||||
| FRASER, Simon Scott | Sekretär | Foxtrot 1 Shey Copse GU22 8HS Woking Surrey | British | 39862810001 | ||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Sekretär | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Sekretär | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MILLS, John Michael | Sekretär | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| SIMS, Roy John Peter | Sekretär | 6 Star Hill Drive Churt GU10 2HP Farnham Surrey | British | 12396130001 | ||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Sekretär | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | British | 67168210001 | ||||||
| STEVENS, David John | Sekretär | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Sekretär | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
| FORTE NOMINEES LIMITED | Sekretär | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42198970001 | |||||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Geschäftsführer | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 49678170001 | |||||
| ELTON, James Robert | Geschäftsführer | 27 Elsie Road SE22 8DX London | United Kingdom | British | 55689440001 | |||||
| FERGUSON, Iain Donald | Geschäftsführer | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 10297860001 | |||||
| FRASER, Simon Scott | Geschäftsführer | Foxtrot 1 Shey Copse GU22 8HS Woking Surrey | British | 39862810001 | ||||||
| HILL, Nicholas Mark Lalor | Geschäftsführer | 36 Hazlewell Road SW15 6LR London | United Kingdom | British | 76547250001 | |||||
| KANDERS, Alan J | Geschäftsführer | Suite 2a 500 West End Avenue YO23 7DE New York North Yorkshire United States | United States Citizen | 114506230001 | ||||||
| LAMBERT, Bernard Charles Hector | Geschäftsführer | Flat 10 21-23 Palace Gate W8 5LS London | Austria | French | 60956020002 | |||||
| LOVETT, Norman | Geschäftsführer | 25 Balmoral Way Belmont Surrey | British | 49941610001 | ||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Geschäftsführer | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||
| MAHONEY, Richard Lee | Geschäftsführer | Flat 14,38 Queens Gate SW7 5JN London | American | 78240440004 | ||||||
| MALONEY, David Ossian | Geschäftsführer | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69071800002 | |||||
| MILLS, John Michael | Geschäftsführer | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| RILEY, Robert Earl | Geschäftsführer | 3 Montpelier Walk SW7 6TT London | United States Citizen | 95184480002 | ||||||
| SIMS, Roy John Peter | Geschäftsführer | 6 Star Hill Drive Churt GU10 2HP Farnham Surrey | British | 12396130001 | ||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Geschäftsführer | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | England | British | 67168210001 | |||||
| STEVENS, David John | Geschäftsführer | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Geschäftsführer | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 37564540001 | |||||
| FORTE (UK) LIMITED | Geschäftsführer | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42204690001 |
Hat EXCELSIOR HOTELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Subordination agreement | Erstellt am 22. Nov. 2005 Geliefert am 05. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company has undertaken to the chargee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities, in each case the junior creditors concerned shall hold the same upon trust for the security agent for aplication in or towards payment of all the senior liabilities,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 15. Apr. 2003 Geliefert am 01. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Portuguese public deed executed outside the UK and comprising of property situated there | Erstellt am 05. Juli 2002 Geliefert am 06. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and the right to all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors | Erstellt am 11. Juli 2001 Geliefert am 26. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Juli 1931 Erworben am 29. Sept. 1936 Geliefert am 20. Okt. 1936 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £4,000 (owing) | |
Kurze Angaben 7, the esplanade, scarborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 15. Juni 1923 Erworben am 29. Sept. 1936 Geliefert am 20. Okt. 1936 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000 (owing) | |
Kurze Angaben The royal crescent hotel, filey and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 15. Juni 1923 Erworben am 29. Sept. 1936 Geliefert am 20. Okt. 1936 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £27000 (owing) | |
Kurze Angaben The crown hotel, scarborough and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EXCELSIOR HOTELS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0