KELLER DORMANT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KELLER DORMANT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00323483 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KELLER DORMANT LIMITED?
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten n.a. (43999) / Bauwesen
Wo befindet sich KELLER DORMANT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Keller Limited Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KELLER DORMANT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KELLER COLCRETE LIMITED | 04. Mai 1990 | 04. Mai 1990 |
| GKN COLCRETE LIMITED | 02. Juni 1986 | 02. Juni 1986 |
| COLCRETE LIMITED | 25. Jan. 1937 | 25. Jan. 1937 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KELLER DORMANT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KELLER DORMANT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Robert Malcolm Thompson als Direktor am 13. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joseph Christopher Hubback als Geschäftsführer am 13. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AAMD | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr William Marston Reid als Direktor am 04. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Emile De Waele als Geschäftsführer am 04. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Joseph Christopher Hubback als Direktor am 04. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Marston Reid als Sekretär am 04. März 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Bryan Barratt als Sekretär am 04. März 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Bryan Barratt als Geschäftsführer am 04. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KELLER DORMANT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REID, William Marston | Sekretär | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | 256080810001 | |||||||
| REID, William Marston | Geschäftsführer | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | England | British | 236804500001 | |||||
| THOMPSON, Robert Malcolm | Geschäftsführer | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | United Kingdom | British | 267238290001 | |||||
| BARRATT, Roger Bryan | Sekretär | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | British | 79815620001 | ||||||
| WHITEHOUSE, Kevan | Sekretär | Ridgeacre 23 Pilkington Avenue B72 1LA Sutton Coldfield West Midlands | British | 50711120002 | ||||||
| BARRATT, Roger Bryan | Geschäftsführer | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 79815620001 | |||||
| BELL, Alan Lyness, Dr | Geschäftsführer | Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | England | British | 112730510001 | |||||
| DE WAELE, James Emile | Geschäftsführer | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 92495900001 | |||||
| HUBBACK, Joseph Christopher | Geschäftsführer | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | England | British | 253834200001 | |||||
| MARTIN, Michael William Colin | Geschäftsführer | Laudshill 12 Boat Horse Lane Crick NN6 7TH Northampton Northamptonshire | British | 20930730002 | ||||||
| WEST, John Michael, Dr | Geschäftsführer | 20 Woodland Gardens N10 3UA London | British | 9389810001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KELLER DORMANT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller Limited | 06. Apr. 2016 | Ryton-On-Dunsmore CV8 3EG Coventry Oxford Road West Midlands England & Wales | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat KELLER DORMANT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed relating to a guarantee and debenture | Erstellt am 14. Jan. 1994 Geliefert am 01. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed relating to a guarantee and debenture | Erstellt am 14. Jan. 1994 Geliefert am 01. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juli 1990 Geliefert am 17. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Mai 1990 Geliefert am 11. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 1/5/90 | |
Kurze Angaben (See doc M22 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Nov. 1980 Geliefert am 21. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land in gun lane, strood, kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Nov. 1980 Geliefert am 21. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property situate at strood, rochester, kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Nov. 1980 Geliefert am 21. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital & buildigns & fixtures & fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 22. Aug. 1980 Geliefert am 01. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0