LTWB LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLTWB LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00334172
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LTWB LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich LTWB LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gleadhill House Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LTWB LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LOUIS TUSSAUDS WAXWORKS (BLACKPOOL) LIMITED29. Nov. 193729. Nov. 1937

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTWB LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LTWB LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LTWB LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Kathryn Revitt als Geschäftsführer am 01. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Kathryn Revitt am 30. März 2015

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Nov. 2014

    Kapitalaufstellung am 28. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 93,834
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 93,834
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 97 Church Street Blackpool Lancashire FY1 1HL* am 05. Okt. 2010

    1 SeitenAD01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed louis tussauds waxworks (blackpool) LIMITED\certificate issued on 14/04/10
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name14. Apr. 2010

    Beschluss zur Änderung der Firma am 07. Apr. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 27. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von LTWB LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishCompany Director2272770002
    HEMMINGS, Craig John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector180952730001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director2272770002
    GRANGE, Pauline
    265 Layton Road
    FY3 8ER Blackpool
    Sekretär
    265 Layton Road
    FY3 8ER Blackpool
    British18836910002
    SPENCER, Kevin Paul
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Sekretär
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    BritishElectrician50661420002
    BISHOP, Hilary David Laurence
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    BritishLeasing Consultant16015610001
    BISHOP, Susan
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    BritishCompany Director12981410001
    CHAPMAN, David Thomas
    20 The Royals
    Linksgate
    FY8 3LJ Lytham St Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    20 The Royals
    Linksgate
    FY8 3LJ Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritishOperations Director43071850006
    ETCHES, Marc Warren
    East Dene
    Brettargh Drive Haverbreaks
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    Geschäftsführer
    East Dene
    Brettargh Drive Haverbreaks
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    BritishCompany Director61366690003
    GRANGE, Pauline
    265 Layton Road
    FY3 8ER Blackpool
    Geschäftsführer
    265 Layton Road
    FY3 8ER Blackpool
    BritishCompany Secretary18836910002
    REVITT, Kathryn
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United Kingdom
    Isle Of ManBritishSolicitor49315020002
    SPENCER, Darren Robert
    141 Newhouse Road
    FY4 4PB Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    141 Newhouse Road
    FY4 4PB Blackpool
    Lancashire
    BritishDepot Manager51906710001
    SPENCER, Harry
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Geschäftsführer
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    BritishCompany Director51906410002
    SPENCER, Kenneth
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Lancashire
    BritishElectrical Contractor18836920001
    SPENCER, Kevin Paul
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Geschäftsführer
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    BritishElectrician50661420002
    SPENCER, Norma Lilian
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Alwood Avenue
    FY3 8NG Blackpool
    Lancashire
    BritishCompany Director51906640001
    SULLIVAN, Christopher John
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishDirector101400140001
    WATT, Margaret
    218 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EW Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    218 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5EW Glasgow
    Lanarkshire
    British18836930001
    WEINER, Claire Laura
    The Dower House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Dower House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    British18836940001
    WEINER, Denis Patrick Canning
    The Dower House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Dower House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    BritishCompany Director18836950001

    Hat LTWB LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 04. Nov. 1999
    Geliefert am 17. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H louis tussauds waxworks 87/89 cantral promenade blackpool lancashire FY1 1HL. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 1999
    Geliefert am 17. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed
    Erstellt am 17. Dez. 1996
    Geliefert am 19. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    87/89 central promenade blackpool lancashire FY1 5AA together with all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery fixed charge all book and other debts all rental monies by way of assignment the goodwill of the business an d all present and future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture deed
    Erstellt am 17. Dez. 1996
    Geliefert am 19. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 08. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    87 and 89 central promenade blackpool lancs.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 1995
    Geliefert am 08. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 clifton street lytham lancashire t/no:la 515131.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1987
    Geliefert am 15. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over f/h land and premises at and k/a 87/89 central promenade blackpool. County of lancaster. And/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0