LTWB LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LTWB LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00334172 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LTWB LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LTWB LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gleadhill House Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Lancashire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LTWB LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LOUIS TUSSAUDS WAXWORKS (BLACKPOOL) LIMITED | 29. Nov. 1937 | 29. Nov. 1937 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LTWB LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LTWB LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LTWB LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kathryn Revitt als Geschäftsführer am 01. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Kathryn Revitt am 30. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 97 Church Street Blackpool Lancashire FY1 1HL* am 05. Okt. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed louis tussauds waxworks (blackpool) LIMITED\certificate issued on 14/04/10 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 27. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LTWB LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDDERS, Mark Lorimer | Sekretär | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire United Kingdom | British | Company Director | 2272770002 | |||||
HEMMINGS, Craig John | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 180952730001 | ||||
WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 2272770002 | ||||
GRANGE, Pauline | Sekretär | 265 Layton Road FY3 8ER Blackpool | British | 18836910002 | ||||||
SPENCER, Kevin Paul | Sekretär | 7 Alwood Avenue FY3 8NG Blackpool | British | Electrician | 50661420002 | |||||
BISHOP, Hilary David Laurence | Geschäftsführer | Hilliards House Amlets Lane GU6 7DH Cranleigh Surrey | British | Leasing Consultant | 16015610001 | |||||
BISHOP, Susan | Geschäftsführer | Hilliards House Amlets Lane GU6 7DH Cranleigh Surrey | British | Company Director | 12981410001 | |||||
CHAPMAN, David Thomas | Geschäftsführer | 20 The Royals Linksgate FY8 3LJ Lytham St Annes Lancashire | England | British | Operations Director | 43071850006 | ||||
ETCHES, Marc Warren | Geschäftsführer | East Dene Brettargh Drive Haverbreaks LA1 5BN Lancaster Lancashire | British | Company Director | 61366690003 | |||||
GRANGE, Pauline | Geschäftsführer | 265 Layton Road FY3 8ER Blackpool | British | Company Secretary | 18836910002 | |||||
REVITT, Kathryn | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire United Kingdom | Isle Of Man | British | Solicitor | 49315020002 | ||||
SPENCER, Darren Robert | Geschäftsführer | 141 Newhouse Road FY4 4PB Blackpool Lancashire | British | Depot Manager | 51906710001 | |||||
SPENCER, Harry | Geschäftsführer | 7 Alwood Avenue FY3 8NG Blackpool | British | Company Director | 51906410002 | |||||
SPENCER, Kenneth | Geschäftsführer | 7 Alwood Avenue FY3 8NG Blackpool Lancashire | British | Electrical Contractor | 18836920001 | |||||
SPENCER, Kevin Paul | Geschäftsführer | 7 Alwood Avenue FY3 8NG Blackpool | British | Electrician | 50661420002 | |||||
SPENCER, Norma Lilian | Geschäftsführer | 7 Alwood Avenue FY3 8NG Blackpool Lancashire | British | Company Director | 51906640001 | |||||
SULLIVAN, Christopher John | Geschäftsführer | 8 Spring Gardens Waddington BB7 3HH Blackburn Lancashire | England | British | Director | 101400140001 | ||||
WATT, Margaret | Geschäftsführer | 218 Mearns Road Newton Mearns G77 5EW Glasgow Lanarkshire | British | 18836930001 | ||||||
WEINER, Claire Laura | Geschäftsführer | The Dower House Amlets Lane GU6 7DH Cranleigh Surrey | British | 18836940001 | ||||||
WEINER, Denis Patrick Canning | Geschäftsführer | The Dower House Amlets Lane GU6 7DH Cranleigh Surrey | British | Company Director | 18836950001 |
Hat LTWB LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 04. Nov. 1999 Geliefert am 17. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H louis tussauds waxworks 87/89 cantral promenade blackpool lancashire FY1 1HL. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Nov. 1999 Geliefert am 17. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 19. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 87/89 central promenade blackpool lancashire FY1 5AA together with all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant and machinery fixed charge all book and other debts all rental monies by way of assignment the goodwill of the business an d all present and future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 19. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 87 and 89 central promenade blackpool lancs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Mai 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. März 1988 Geliefert am 31. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 9 clifton street lytham lancashire t/no:la 515131. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 01. Okt. 1987 Geliefert am 15. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over f/h land and premises at and k/a 87/89 central promenade blackpool. County of lancaster. And/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0