ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 00335888 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b & z - convert to i&ps | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Oldale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil James Walker am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Murray Tinning am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Buchan Hendry am 31. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Eldridge als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | 150262030001 | |||||||
| OLDALE, Andrew | Geschäftsführer | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | England | British | 167083200001 | |||||
| TINNING, George Murray | Geschäftsführer | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | United Kingdom | British | 126913730001 | |||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Sekretär | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | British | 10084840001 | ||||||
| BEWLEY, Bernard | Sekretär | 8 Ash Rise ST17 9HE Stafford Staffordshire | British | 2087640001 | ||||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Sekretär | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport Cheshire | British | 127361240001 | ||||||
| JONES, Philip Robert | Sekretär | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | 43686960001 | ||||||
| KEW, Philip Anthony | Sekretär | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | British | 84868550001 | ||||||
| SALMONS, Raymond | Sekretär | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| UCL SECRETARY LIMITED | Sekretär | United Co Operatives Limited Sandbrook Park Sandbrook Way OL11 1RY Rochdale Lancashire | 111685670001 | |||||||
| ASPRAY, Rodney George | Geschäftsführer | Kambara 4 Green Lane Poynton SK12 1TJ Stockport Cheshire | British | 2637360001 | ||||||
| BALL, Peter John | Geschäftsführer | Kimberley Links Drive Robin Lane High Bentham LA2 7BJ Lancaster Lancashire | British | 35323290001 | ||||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Geschäftsführer | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 10084840001 | |||||
| BROWN, Alan | Geschäftsführer | 81 Harewood Close Norden OL11 5TJ Rochdale Lancashire | England | British | 31749420001 | |||||
| DUGMORE, Peter Fawcett | Geschäftsführer | Woodview Boathouse Lane WF14 8HQ Mirfield Yorkshire | United Kingdom | British | 88084280001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| KEW, Philip Anthony | Geschäftsführer | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||
| SALMONS, Raymond | Geschäftsführer | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| THOMSON, John | Geschäftsführer | Five Oaks 56 Parkway Dairyfields Trentham ST4 8AG Stoke On Trent Staffordshire | British | 57103470001 | ||||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | England | British | 126913860001 | |||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | 87 Woodsmoor Lane Woodsmoor SK2 7BD Stockport Cheshire | British | 98761120001 | ||||||
| WATES, Martyn James | Geschäftsführer | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 60114700001 | |||||
| YORATH, Delma Rose | Geschäftsführer | 5 Holt Lane Mews Failsworth M35 9ND Greater Manchester | British | 41961000001 | ||||||
| UCL DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | United Co-Operatives Limited Sandbrook Park OL11 1RY Rochdale | 110868260001 |
Hat ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1985 Geliefert am 19. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 232-238, station road, pendlebury salford, greater manchester title no: gm 279745 and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juni 1984 Geliefert am 15. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1982 Geliefert am 29. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land adjoining errwood road, levenshulme subject to mortgages dated 4.9.73. and 20.7.82.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Nov. 1982 Geliefert am 24. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1022 stockport road, lavenshulme, greater manchester title no la 14665. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Nov. 1982 Geliefert am 23. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 22 errwood road, levenshulme greater manchester title no:- la 175671. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Nov. 1982 Geliefert am 23. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 230 market street hyde, greater manchester tameside. Title no:- gm 216073. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 1982 Geliefert am 29. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & premises k/a 1022 stockport road levenshulme manchester title no la 14665. tog with a right of way over the passageway at the back leading to york st and keireen street together with all fixtures attached to the said premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further charge | Erstellt am 20. Juli 1982 Geliefert am 05. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 4TH sept 1973 and this charge. | |
Kurze Angaben Property comprised in a legal charge dated 4-9-73 title no la 175671. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 16. Juli 1982 Geliefert am 19. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 114 mauldeth road, withington, manchester title no la 364087. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Sept. 1980 Geliefert am 19. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings known as 1022 stockport road, levenshulme, gtr. Manchester title no la 14665. together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 1980 Geliefert am 16. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that plot of l/h land, dwellinghouse & shop known as 230 market street, hyde greater manchester. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0