DAY & SON(BUILDERS)LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DAY & SON(BUILDERS)LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00341390 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , PO Box 101 1 Balloon Street, Manchester, M60 4EP, United Kingdom zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 19. Apr. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von David William John Bagley als Direktor am 28. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Isabel Mary Chadwick als Geschäftsführer am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr David Clive Whitehead am 02. Okt. 2017 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Isabel Mary Chadwick am 02. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Michael Miller am 02. Okt. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Secretariat Miller Street Tower, Miller Street, Manchester, England, M60 0AL, England zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 09. Okt. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2016 bis 30. Juni 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Mundy als Geschäftsführer am 10. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graeme Tosen als Gesch äftsführer am 02. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITEHEAD, David Clive | Sekretär | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | 196735800001 | |||||||
| BAGLEY, David William John | Geschäftsführer | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 243656970001 | |||||
| MILLER, David Michael | Geschäftsführer | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | England | British | 201054530001 | |||||
| ARNOLD, Katy Jane | Sekretär | Angel Square M60 0AG Manchester 1 United Kingdom | 185872830001 | |||||||
| BANCROFT, Kathrine Jane | Sekretär | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | 153011530001 | |||||||
| LEES, Moira Ann | Sekretär | 389 Bury Road Edgworth BL7 0BU Bolton Lancashire | British | 34646780001 | ||||||
| LEES, Moira Ann | Sekretär | 389 Bury Road Edgworth BL7 0BU Bolton Lancashire | British | 34646780001 | ||||||
| MCKEOWN, Brona Rose | Sekretär | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | 193827640001 | |||||||
| WADE, Patricia Anne | Sekretär | 28 Hazel Road WA14 1JL Altrincham Cheshire | British | 35222860001 | ||||||
| BLAKE, Kevin Michael | Geschäftsführer | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 297769890001 | |||||
| CHADWICK, Isabel Mary | Geschäftsführer | Balloon Street M60 4EP Manchester C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1 United Kingdom | England | British | 174564650002 | |||||
| COLYER, Henry George | Geschäftsführer | 19 Chester Road Poynton SK12 1EU Stockport Cheshire | British | 11923210001 | ||||||
| GILES, Peter | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 173027650001 | |||||
| GODDARD, Richard Thomas | Geschäftsführer | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 63087570001 | |||||
| GOSLING, Clare Louise | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||
| HARVEY, Joanne Susan | Geschäftsführer | 6 Linden Road Didsbury M20 2QJ Manchester Lancashire | British | 102010420001 | ||||||
| HUGHES, John Richard | Geschäftsführer | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | England | British | 146426540002 | |||||
| JONES, Brian Dolby | Geschäftsführer | 11 Mayfield Road Bramhall SK7 1JU Stockport Cheshire | British | 7045720001 | ||||||
| KENYON, Alan | Geschäftsführer | 2 Dunedin Road Greenmount BL8 4EX Bury Lancashire | British | 22552860001 | ||||||
| KERNS, Peter William | Geschäftsführer | 26 Swinhoe Place Hob Hey Lane WA3 4NE Culcheth Cheshire | United Kingdom | British | 67171290002 | |||||
| MACK, Christopher James | Geschäftsführer | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 159050870001 | |||||
| MACK, Christopher James | Geschäftsführer | 5th Floor, New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester C/O Governance Department United Kingdom | England | British | 159050870001 | |||||
| MARPER, William John | Geschäftsführer | Manderley 34 Prestbury Road SK9 2LL Wilmslow Cheshire | British | 7045730001 | ||||||
| MUNDY, Daniel | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 189420920001 | |||||
| NEWBY, William Edward | Geschäftsführer | c/o Governance Dept, 5th Floor Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | 140446620001 | |||||
| PENNYCOOK, Richard John | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | England | British | 112734470002 | |||||
| ROBERTS, Stuart Anthony | Geschäftsführer | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | United Kingdom | English | 168767590001 | |||||
| TAYLOR, Helen | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | United Kingdom | British | 159599170001 | |||||
| TOSEN, Graeme | Geschäftsführer | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat England England | England | British | 191276900001 | |||||
| TOWERS, Robert Leslie | Geschäftsführer | 15 Hamsterley Close Gorse Covert WA3 6UF Warrington Cheshire | British | 65275200001 | ||||||
| WARDLE, Leonard Adrian | Geschäftsführer | 9th Floor 1 Angel Square M60 0AG Manchester Corporate Governance United Kingdom | United Kingdom | British | 89385940004 | |||||
| WILSON, Paul | Geschäftsführer | 3 Bankside Road M20 5QE Didsbury Manchester | British | 83001190001 | ||||||
| WOODWARD, Michael John | Geschäftsführer | 10 Carrwood Road SK9 5DL Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | 32030920001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Finance Limited | 06. Apr. 2016 | Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester Secretariat England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DAY & SON(BUILDERS)LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Jan. 1985 Geliefert am 22. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over: f/h premises at church warf chiswick london borough of hounslow t/n mx 44003 f/h premises at balmoral court 41-43 grand ave., Worthing west sussex t/n wsx 41737 together with all fixtures, fixed plant & machinery. Fixed & floating charge over undertaking l/h & f/h properties all fixtures & fittings, proceeds of sale, uncalled & unpaid capital stocks, shares goodwill book & other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 1982 Geliefert am 06. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 & all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land premises at church street, chiswick hounslow, london t/n mx 44003 undertaking and all property and assets present and future including plant, stocks shares & uncalled capital. The assignment of rights relating to above, building plans, goodwill and licences relating to mortgaged property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Juli 1981 Geliefert am 30. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on north west side of river thames & being part of church wharf hounslow greater london together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Dez. 1980 Geliefert am 20. Jan. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the estate, right interest etc. of the company in two agreements & a deed all dated 30.12.80. in building works on l/h premises situate at oakley square, london NW1 or in such l/h premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 24. Nov. 1980 Geliefert am 03. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £557,700 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & premises at church wharf chiswick london borough of hounslow title nomx 44003 assignment of rights, plant & building plans etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 10. Apr. 1980 Geliefert am 11. Apr. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 1ST floor flat 41A grand avenue, worthing west sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 14. März 1980 Geliefert am 27. März 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land lying to the south east of ryders road, walton on thames surrey. Title no. Sy 478726. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memo of deposit | Erstellt am 21. Feb. 1980 Geliefert am 22. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 41 grand avenue worthing W. sussex title no sx 53532. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equitable charge | Erstellt am 01. Feb. 1980 Geliefert am 22. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 43 grand avenue, worthing, west sussex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Okt. 1979 Geliefert am 16. Okt. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H eastfield cottages brickfield lane harlington london borough of hillingdon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Juli 1979 Geliefert am 16. Juli 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £69,375 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H 39 barlington rd, chiswick, london W4. Ngl 348745. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 1978 Geliefert am 07. Dez. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £90,562.50 & all other monies due from the company to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Marlborough close hallington park, st leonards-on-sea, sussex, registered title number ht 17564 & ht 21973. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 1977 Geliefert am 07. Dez. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £9,260 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Two f/h properties at elms lane, west wittering. Title nos. Sx 150074 & sx 150388. together with all buildings structures and erections thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 19. Juli 1977 Geliefert am 22. Juli 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 21-6-77 | |
Kurze Angaben Fixed charge on f/h land and buildings lying to the south east of terrace road, walton-on-thames, surrey. Title no-SY186720 and sy 71731 together with all buildings and fixtures in the nature of landlord's fixtures from time to time on and in all the above mentioned premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 21. Juni 1977 Geliefert am 27. Juni 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land at terrace road, walton-on-thames, surrey together with all buildings and fixtures in the nature of landlords fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DAY & SON(BUILDERS)LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0