ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00349263 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Wigmore Street London W1U 1PB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROANDO HOLDINGS LIMITED | 06. Feb. 1939 | 06. Feb. 1939 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2012 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2011 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 28. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 09. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870006 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Sekretär | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Sekretär | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||||||
| GILBERT, Nicholas Jay | Sekretär | Woodville 14 Carlton Park Avenue WF8 3HQ Pontefract West Yorkshire | British | 81344240001 | ||||||||||
| JOBBINS, Stuart | Sekretär | 16 Riverside Avenue LS21 2RT Otley West Yorkshire | British | 108146440001 | ||||||||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Sekretär | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | British | 58693930003 | ||||||||||
| BELL, John Drummond | Geschäftsführer | Gates Garth 49 Rutland Drive HG1 2NX Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 63940900001 | |||||||||
| BEST, George Laidler | Geschäftsführer | Kiddall Hall Farm York Road Barwick In Elmet LS14 3AE Leeds West Yorkshire | British | 2748600001 | ||||||||||
| CURTIS, Ernest Leonard | Geschäftsführer | Cedar Lodge Greenfield Lane Hawksworth Guiseley LS20 8HF Leeds West Yorkshire | British | 19382660001 | ||||||||||
| EVANS, Andreas Frederick | Geschäftsführer | Leathley Grange LS21 2LA Leathley North Yorkshire | United Kingdom | British | 9485290003 | |||||||||
| EVANS, Dominic Redvers | Geschäftsführer | Pine Lodge 9 Sandmoor Avenue LS17 7DW Leeds West Yorkshire | British | 7095590001 | ||||||||||
| EVANS, Frederick Redvers | Geschäftsführer | 16 Sandmoor Drive LS17 7DG Leeds West Yorkshire | British | 4409160001 | ||||||||||
| EVANS, Roderick Michael | Geschäftsführer | Oakhill House Roundhay Park Lane LS17 8AR Leeds | British | 40175270002 | ||||||||||
| GIBSON, William Mcaulay | Geschäftsführer | Ivy Bank 1 Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 5387660001 | ||||||||||
| HORSBROUGH, Pauline Elizabeth | Geschäftsführer | 30 The Orchard Wrenthorpe WF2 0LL Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 4961270001 | |||||||||
| MCKENDRICK, Charles | Geschäftsführer | St Anns Main Street LS22 5EB Kirk Deighton North Yorkshire | United Kingdom | British | 173983190001 | |||||||||
| MILLINGTON, Paul Terence | Geschäftsführer | 2a Gilleyfield Avenue Dore S17 3NS Sheffield | United Kingdom | British | 58693930003 | |||||||||
| PARRISH, Trevor Lawton | Geschäftsführer | 46 Congreve Way Bardsey LS17 9BG Leeds West Yorkshire | British | 15527330001 | ||||||||||
| TURNER, Philip Arthur | Geschäftsführer | Red Roofs 2 Mulberry Garth Thorp Arch LS23 7AF Wetherby West Yorkshire | British | 66424440001 | ||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 1995 Geliefert am 10. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage land and buildings on the west side of millshaw, beeston, leeds, west yorkshire t/nos. WYK488274 and WYK193393 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 1995 Geliefert am 01. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage:-all that f/h land and buildings k/as 22-30 (even) new york street and 13 & 15 harper street leeds west yorkshire.t/no.wyk 541898 the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 1994 Geliefert am 14. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben Land on east of tramway road irlam t/n GM259157 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 1994 Geliefert am 14. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to the term loan facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related financial documents (as defined) | |
Kurze Angaben Property k/a 6 tyrawley road london t/n LN103163 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 1994 Geliefert am 14. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 44 to 60 (even) richarshaw lane pudsey t/n WYK420976 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1993 Geliefert am 21. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities which now are or at any time herafter may become due from the company to lloyds bank PLC ("the bank") under or in respect of such part of the company's guarantee liability to the bank as may arise from facilities granted to evans (holdings) limited pursuant to a loan agreement dated the 2ND april 1993 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 10 manor street leeds together with all buildings and fixtures thereon and goods, by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the property aforesaid, by way of assignment the benefit of all guarantees or covenants (as defined).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. März 1993 Geliefert am 29. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or evans universal limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that the f/h land and premises k/a land and buildings on the south side of manor street leeds t/no.WYK315874. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit of deeds | Erstellt am 20. Aug. 1992 Geliefert am 24. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 tyrawley road fulham london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit of deeds | Erstellt am 07. Feb. 1991 Geliefert am 15. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 44/160 (even numbers) richardshaw lane, pudsey title no wyk 420976. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit of deeds | Erstellt am 07. Feb. 1991 Geliefert am 15. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Thames trading centre, fairbells road, irlam manchester title no gm 259157. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 20. März 1989 Geliefert am 29. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Deeds & documents relating to the f/h property k/a land situate at millshaw beeston leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of charge | Erstellt am 16. März 1984 Geliefert am 17. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from evans universal limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property situate at rawdon with all fixtures fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Aug. 1979 Geliefert am 11. Sept. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn/harrogage limited and/or l hudson (yorks) limited | |
Kurze Angaben 17, 18, 19 & 20 york place harrogate west yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1975 Geliefert am 16. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The west side of bredford road, batley, yorkshire together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1975 Geliefert am 16. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Three parcels of land fronting john street & thomas street, barnsley, yorkshire together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1975 Geliefert am 16. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 17, 18, 19 & 20 york place, harrogate together with all fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1975 Geliefert am 16. Dez. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben New street & john street, barnsley yorkshire, together with all fixtutes. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1975 Geliefert am 06. Aug. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land situated in new street and john street, barusley, west riding, yorks. Together with all buildings erected thereon. (See doc 123 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1975 Geliefert am 06. Aug. 1975 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from rowland winn (batley) LTD and/or all or any of the other companies named therein. To the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Land on the west side of bradford road, batley, west riding, yorkshire. With buildings erected thereon. (See doc 122 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1972 Geliefert am 06. Juli 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on south side of santengley lane, crofton, yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memo of deposit | Erstellt am 13. Nov. 1967 Geliefert am 30. Nov. 1967 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at altofts, normanton. Title no. Yk 17464. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Instrument of charge | Erstellt am 28. Apr. 1967 Geliefert am 07. Mai 1967 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc | |
Kurze Angaben Land & buildings at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, park grove, & joiners workshop & garage in park terraces for headingley, leeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge by deposit of deeds | Erstellt am 01. Feb. 1967 Geliefert am 22. Feb. 1967 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben Land at south and south west side of durkar low lane, durker, wakefield, yorks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 11. Aug. 1966 Geliefert am 15. Aug. 1966 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. | |
Kurze Angaben F/H land near broadowler lane, ossett. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Instr of charge | Erstellt am 23. Mai 1966 Geliefert am 23. Mai 1966 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on west side of boston road, aforesaid. Title no. Yk 3815. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0