MATERIALS REALISATIONS LIMITED

MATERIALS REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMATERIALS REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00350748
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    • (2524) /

    Wo befindet sich MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ernst & Young Llp
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHAMBERLAIN PHIPPS MATERIALS LIMITED16. Okt. 199516. Okt. 1995
    CHAMBERLAIN VINYL PRODUCTS LIMITED08. Apr. 199308. Apr. 1993
    VINAFLEX LIMITED18. März 193918. März 1939

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 23. Feb. 2009

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 18. Aug. 2008

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    5 Seiten3.6

    legacy

    4 Seiten395

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed chamberlain phipps materials lim ited\certificate issued on 19/05/97
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten288

    Wer sind die Geschäftsführer von MATERIALS REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    IRVINE, William Albert
    21 Beech Avenue
    Cale Green
    SK3 8HA Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    21 Beech Avenue
    Cale Green
    SK3 8HA Stockport
    Cheshire
    British25127330001
    PAYNE, Bertram Roger
    36 Cross Lane
    Rothley
    LE7 Leicester
    Geschäftsführer
    36 Cross Lane
    Rothley
    LE7 Leicester
    British52992660001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Sekretär
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    British84675480001
    JONES, Philip Gregory
    Infield Lodge
    Infield Road Glatton
    PE28 5RY Huntingdon
    Cambridgeshire
    Sekretär
    Infield Lodge
    Infield Road Glatton
    PE28 5RY Huntingdon
    Cambridgeshire
    British26617820001
    KILBY, Robert Frank, Mr.
    Thatch Cottage
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Worcestershire
    Sekretär
    Thatch Cottage
    Sale Green
    WR9 7LW Droitwich
    Worcestershire
    British67643710001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish84675480001
    JONES, Philip Gregory
    Infield Lodge
    Infield Road Glatton
    PE28 5RY Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Infield Lodge
    Infield Road Glatton
    PE28 5RY Huntingdon
    Cambridgeshire
    British26617820001
    MUTO, Oscar
    South View 1 Main Street
    LE3 3AL Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    South View 1 Main Street
    LE3 3AL Leicester
    Leicestershire
    Italian53004550001
    PALFREYMAN, Gerald Anthony Henry
    Home Farm
    Great Oxendon
    LE16 8NE Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Home Farm
    Great Oxendon
    LE16 8NE Market Harborough
    Leicestershire
    British14073780001
    PRATT, Edward John
    31 Bullimore Grove
    CV8 2QF Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    31 Bullimore Grove
    CV8 2QF Kenilworth
    Warwickshire
    British7666520001
    SULLIVAN, Daniel Joseph
    4525 Laclede
    St Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Geschäftsführer
    4525 Laclede
    St Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Us Citizen34666110001
    TILLEY, Ivor John
    2 York Road
    Wollaston
    NN29 7SG Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    2 York Road
    Wollaston
    NN29 7SG Wellingborough
    Northamptonshire
    British6878340001
    WILLIAMS, William
    56 Syston Road
    Queniborough
    LE7 3FX Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    56 Syston Road
    Queniborough
    LE7 3FX Leicester
    Leicestershire
    British23718680001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    British6529580001

    Hat MATERIALS REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over deposit
    Erstellt am 14. Mai 1997
    Geliefert am 20. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company formerly known as chamberlain phipps materials limited to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the account with the company in the books of bank of scotland treasury services PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture in favour of the governor and company of the bank of scotland ("bos") as security trustee for the beneficiaries
    Erstellt am 27. März 1996
    Geliefert am 12. Apr. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies within the group comprising chamberlain phipps group PLC and its subsidiaries from time to time (the "group companies"):- (I) to bos (as agent and security trustee) and to bos and credit lyonnais (as banks) under the facilities agreement dated 2 august 1994 between chamberlain phipps group PLC, the group companies named therein and bos and under any other finance documents; (ii) to bos and/or credit lyonnais as hedging counterparties; (iii) to bos and credit lyonnais as providers of working capital facilities; and (iv) to bos for all monies, "capitalised terms used in this certificate bear the same meaning as they do in the debenture"
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandfined)as Security Trustee for the Beneficiaries (As De
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 1996Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 05. Mai 2004Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
      • Aktenzeichen 1
    Letter of charge
    Erstellt am 02. Aug. 1994
    Geliefert am 19. Aug. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of any account or accounts of the company with the bank by way of fixed and specific charge.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Erworben am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 23. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from chamberlain fibres limited and/or any of the companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    The undertaking and assets of the ferrabond and ferravel businesses ownedby chamberlain fibres limited including goodwill, the benefit of its subsisting contracts, stock in trade, moveable and fixed plant and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Legal and General Assurance Society Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1993Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 18. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Erworben am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 23. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from chamberlain fibres limited and/or any of the companies named therein to the chargee
    Kurze Angaben
    The undertaking and assets of the ferrabond and ferravel businesses owned by chamberlain fibres limited including goodwill,the benefit of its subsisting contracts,stock in trade,moveable and fixed plant and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1993Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 18. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 29. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 12 may 1992 and this charge
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M87. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 27. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the mezzanine loan agreement of even date and the prior chargesas defined
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M116. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Legal and General Assurance Society Limited
    Transaktionen
    • 27. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MATERIALS REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. März 1996Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Murdoch L Mckillop
    Po Box 55
    1 Surrey Street
    WC2R 2NT London
    Praktiker
    Po Box 55
    1 Surrey Street
    WC2R 2NT London
    Simon Allport
    1 Surrey Street
    London
    WC2R 2NT
    Praktiker
    1 Surrey Street
    London
    WC2R 2NT

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0