MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00356189 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
- (2852) /
Wo befindet sich MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pricewaterhousecoopers Llp 101 Barbirolli Square Lower Mosley Street M2 3PW Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MATRIX INTERNATIONAL LIMITED | 15. Sept. 1999 | 15. Sept. 1999 |
| MATRIX ENGINEERING LIMITED | 30. Jan. 1996 | 30. Jan. 1996 |
| TI MATRIX ENGINEERING LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| MATRIX ENGINEERING LIMITED | 23. Aug. 1939 | 23. Aug. 1939 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 3 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Nov. 2011 | 9 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Nov. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2009 | 12 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 12 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Mai 2009 | 9 Seiten | 2.24B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 87 Seiten | 2.23B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.15B | 8 Seiten | 2.16B | ||
Vorschlag des Verwalters | 86 Seiten | 2.17B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.15B | 2 Seiten | 2.16B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 55 Seiten | 2.16B | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 25 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 20 Seiten | AA | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDREY, Philip Nigel | Sekretär | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | British | 44039650003 | ||||||
| BALDREY, Philip Nigel | Geschäftsführer | 34 Saint Bernards Road B92 7BB Solihull West Midlands | England | British | 44039650003 | |||||
| BURDETT, Roger Leonard | Geschäftsführer | The Common Colley Moor CV78AR Coventry Fir Tree Farm Warwickshire | United Kingdom | British | 163337290001 | |||||
| CAMPBELL, Ian | Geschäftsführer | The Coachhouse Broughty Ferry DD5 3NW Dundee | British | 114187300001 | ||||||
| BUTTLE, Alan Craig | Sekretär | 12 The Logan Liff DD2 5PJ Dundee Angus | British | 27740990001 | ||||||
| BAKER, David Julian | Geschäftsführer | 3 Denley Court DD11 2EG Arbroath Angus | Scotland | British | 27741000002 | |||||
| BISHOP, Reginald William | Geschäftsführer | Parkside Park Road Stevington MK43 7QG Bedford | British | 41546740001 | ||||||
| BUTTLE, Alan Craig | Geschäftsführer | 12 The Logan Liff DD2 5PJ Dundee Angus | British | 27740990001 | ||||||
| FRASER, Jonathan Michael | Geschäftsführer | 1walker Place KY16 9NY St Andrews Fife Scotland | British | 52892860002 | ||||||
| MARSHALL, Robert Sidney | Geschäftsführer | 7 High Wheatley Ben Rhydding LS29 8RX Ilkley West Yorkshire | British | 27741010001 | ||||||
| RODGER, David Anthony Hugh | Geschäftsführer | Oaktrees Pinley Green CV35 8LU Claverdon Warwickshire | British | 89739630001 | ||||||
| THOMAS, Clive Ronald | Geschäftsführer | 15 Cecil Payton Close Abbots Bromley WS15 3EZ Rugeley Staffordshire | South African | 32892100001 | ||||||
| TOCHER, Robert Allan | Geschäftsführer | Eskview 1 School Lane DD9 7EX Brechin Angus | British | 27741030001 | ||||||
| TOCHER, William Ritchie | Geschäftsführer | 43 Westfield Loan DD8 1EJ Forfar Angus | British | 145510001 | ||||||
| WHYTE, Colin Graham | Geschäftsführer | 8 Bearehill Gardens DD9 6LW Brechin Angus | British | 27741040001 | ||||||
| WHYTE, Ian | Geschäftsführer | 950 E Baldwin 60067 Palatine Illinois Usa | British | 48098520001 |
Hat MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. März 2006 Geliefert am 28. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented in scotland on 30 march 2006 and | Erstellt am 06. März 2006 Geliefert am 18. Apr. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Property at east mill road, brechin, angus together with buildings and erections, machinery, fittings and fixtures. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 22 february 2006 and | Erstellt am 10. Feb. 2006 Geliefert am 09. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £500,000.00 due or to become due from the company formerly known as matrix international limited to the chargee | |
Kurze Angaben Subjects at east mill road brechin in the county of angus. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland | Erstellt am 07. Feb. 1996 Geliefert am 21. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the mezzanine documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben Property at east mill road brechin angus (as more fully described on form 395) and the whole right title interest in and to the said subjects. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland | Erstellt am 02. Feb. 1996 Geliefert am 10. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties in terms of the financing documents (as defined in the credit agreement dated 30TH january 1996) | |
Kurze Angaben All and whole the portion sometime k/a the north area of property of east mill in the burgh of brechin and county of angus. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 30. Jan. 1996 Geliefert am 13. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the mezzanine loan agreements dated the same date as the debenture, the guarantee and indemnity dated 30TH january 1996, the debenture, and any other other guarantee, indemnity or security documents or trust arrangement | |
Kurze Angaben Brand name-surestop, product-electormagnetically operated calliper dis brake. Brand name-suredrive, product-electromagnetic tooth clutch. Brand name-varistop, product-electrically variale permanent magent brake.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1996 Geliefert am 12. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined in the credit agreement) | |
Kurze Angaben Surestop - electromagnetically operated caliper disc brake. Suredrive - electromagnetic tooth clutch. Varistop - electrically variale permanent magnet brake.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0