MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED

MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00356189
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    • (2852) /

    Wo befindet sich MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp 101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MATRIX INTERNATIONAL LIMITED15. Sept. 199915. Sept. 1999
    MATRIX ENGINEERING LIMITED30. Jan. 199630. Jan. 1996
    TI MATRIX ENGINEERING LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    MATRIX ENGINEERING LIMITED23. Aug. 193923. Aug. 1939

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Nov. 2011

    9 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 10. Nov. 2009

    12 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    12 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 23. Mai 2009

    9 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    87 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B

    8 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    86 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B

    2 Seiten2.16B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    55 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    25 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    20 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    British44039650003
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish44039650003
    BURDETT, Roger Leonard
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    United KingdomBritish163337290001
    CAMPBELL, Ian
    The Coachhouse
    Broughty Ferry
    DD5 3NW Dundee
    Geschäftsführer
    The Coachhouse
    Broughty Ferry
    DD5 3NW Dundee
    British114187300001
    BUTTLE, Alan Craig
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    Sekretär
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    British27740990001
    BAKER, David Julian
    3 Denley Court
    DD11 2EG Arbroath
    Angus
    Geschäftsführer
    3 Denley Court
    DD11 2EG Arbroath
    Angus
    ScotlandBritish27741000002
    BISHOP, Reginald William
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    Geschäftsführer
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    British41546740001
    BUTTLE, Alan Craig
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    Geschäftsführer
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    British27740990001
    FRASER, Jonathan Michael
    1walker Place
    KY16 9NY St Andrews
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    1walker Place
    KY16 9NY St Andrews
    Fife
    Scotland
    British52892860002
    MARSHALL, Robert Sidney
    7 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    British27741010001
    RODGER, David Anthony Hugh
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    British89739630001
    THOMAS, Clive Ronald
    15 Cecil Payton Close
    Abbots Bromley
    WS15 3EZ Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    15 Cecil Payton Close
    Abbots Bromley
    WS15 3EZ Rugeley
    Staffordshire
    South African32892100001
    TOCHER, Robert Allan
    Eskview 1 School Lane
    DD9 7EX Brechin
    Angus
    Geschäftsführer
    Eskview 1 School Lane
    DD9 7EX Brechin
    Angus
    British27741030001
    TOCHER, William Ritchie
    43 Westfield Loan
    DD8 1EJ Forfar
    Angus
    Geschäftsführer
    43 Westfield Loan
    DD8 1EJ Forfar
    Angus
    British145510001
    WHYTE, Colin Graham
    8 Bearehill Gardens
    DD9 6LW Brechin
    Angus
    Geschäftsführer
    8 Bearehill Gardens
    DD9 6LW Brechin
    Angus
    British27741040001
    WHYTE, Ian
    950 E Baldwin
    60067 Palatine
    Illinois
    Usa
    Geschäftsführer
    950 E Baldwin
    60067 Palatine
    Illinois
    Usa
    British48098520001

    Hat MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2006
    Geliefert am 28. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented in scotland on 30 march 2006 and
    Erstellt am 06. März 2006
    Geliefert am 18. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property at east mill road, brechin, angus together with buildings and erections, machinery, fittings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 22 february 2006 and
    Erstellt am 10. Feb. 2006
    Geliefert am 09. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £500,000.00 due or to become due from the company formerly known as matrix international limited to the chargee
    Kurze Angaben
    Subjects at east mill road brechin in the county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Atkin Trustees Limited, David Anthony Hugh Rodger, Philip Nigel Baldray, Roger Leonard Burdettas Trustees of the Hay Hall Group Pension Scheme
    Transaktionen
    • 09. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland
    Erstellt am 07. Feb. 1996
    Geliefert am 21. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the mezzanine documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Property at east mill road brechin angus (as more fully described on form 395) and the whole right title interest in and to the said subjects. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mithras Investment Trust Plcas Agent for Itself and the Other Secured Parties (As Therein Defined) and Its Successors and Assignees Whomsoever
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Erstellt am 02. Feb. 1996
    Geliefert am 10. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties in terms of the financing documents (as defined in the credit agreement dated 30TH january 1996)
    Kurze Angaben
    All and whole the portion sometime k/a the north area of property of east mill in the burgh of brechin and county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1996
    Geliefert am 13. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the mezzanine loan agreements dated the same date as the debenture, the guarantee and indemnity dated 30TH january 1996, the debenture, and any other other guarantee, indemnity or security documents or trust arrangement
    Kurze Angaben
    Brand name-surestop, product-electormagnetically operated calliper dis brake. Brand name-suredrive, product-electromagnetic tooth clutch. Brand name-varistop, product-electrically variale permanent magent brake.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mithras Investment Trust PLC as Agent for Itself and the Other Secured Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1996
    Geliefert am 12. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined in the credit agreement)
    Kurze Angaben
    Surestop - electromagnetically operated caliper disc brake. Suredrive - electromagnetic tooth clutch. Varistop - electrically variale permanent magnet brake.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (As Defined)
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Nov. 2009Ende der Verwaltung
    24. Nov. 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Bruce Cartwright
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Praktiker
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Lorraine Katherine Currie Manson
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Praktiker
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    2
    DatumTyp
    07. März 2012Aufgelöst am
    17. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Bruce Cartwright
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praktiker
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Lorraine Katherine Currie Manson
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praktiker
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0