LENNON'S GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LENNON'S GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 00357454 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LENNON'S GROUP LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich LENNON'S GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LENNON'S GROUP LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 04. Jan. 2011 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 04. Okt. 2011 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Jan. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LENNON'S GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registrierungsbescheinigung eines Sozialvereins | Seiten | CERTIPS | ||||||||||
Verschiedenes Forms b and z to convert to I & ps | Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2010 | Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Hurrell am 01. Aug. 2010 | Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Humes am 01. Aug. 2010 | Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Somerfield House Whitchurch Lane Bristol BS14 0TJ am 23. Feb. 2010 | Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Mai 2009 | Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Apr. 2010 bis 04. Jan. 2010 | Seiten | AA01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | Seiten | AUD | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Robson als Geschäftsführer | Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Emily Martin als Sekretär | Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär | Seiten | AP03 | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Apr. 2008 | Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Apr. 2007 | Seiten | AA | ||||||||||
legacy | Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Apr. 2006 | Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LENNON'S GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | c/o Governance Dept Corporation Street M60 4ES Manchester New Century House United Kingdom | 146923400001 | |||||||
| HUMES, Stephen | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | 84087790001 | |||||
| HURRELL, Timothy | Geschäftsführer | c/o C/O Governance Department Corporation Street M60 4ES Manchester 5th Floor, New Century House United Kingdom | United Kingdom | British | 99724260001 | |||||
| BROWN, Michael Alfred | Sekretär | Windrush Great Billing Park NN3 9BL Northampton Northamptonshire | British | 50692920001 | ||||||
| EGITTO, Joleen | Sekretär | 3 Abbots Close Whitchurch BS14 0UD Bristol | British | 61599540001 | ||||||
| GRANT, Stephen Martin | Sekretär | 3 Trelawn Court Rodney Road GL50 1JJ Cheltenham Gloucestershire | British | 20888800002 | ||||||
| GRANT, Stephen Martin | Sekretär | 2 Beechwood Close Battledown GL52 6QQ Cheltenham Gloucestershire | British | 20888800001 | ||||||
| HENSHAW, Stephen Anthony | Sekretär | Eastleigh Stables Bishopstrow BA12 9HW Warminster Wiltshire | British | 91828160006 | ||||||
| MARTIN, Emily Louise | Sekretär | 49 Henley Park Yatton BS49 4JJ Bristol | British | 115285710001 | ||||||
| ASHTON, Yvonne Margaret | Geschäftsführer | 1 West Dene Stoke Bishop BS9 2BQ Bristol Avon | British | 45225070002 | ||||||
| BACK, Steven John | Geschäftsführer | Fennels 119 Bicester Road Lower End HP18 9EF Long Crendon | United Kingdom | British | 85825120001 | |||||
| CHEYNE, David George Thomson | Geschäftsführer | The Covert 98 Woodlands Road Ashurst SO40 7AH Southampton Hampshire | Britain | British | 74956170001 | |||||
| CLELAND, Jonathan Bradley | Geschäftsführer | 70 Andes Close Ocean Village SO14 3HS Southampton | British | 111624590001 | ||||||
| COATES, Philip Raymond | Geschäftsführer | 2 Berestede Road W6 9NP London | United Kingdom | British | 60114990002 | |||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Crossways House Old Coach Road Cross BS26 2EL Axbridge Somerset | British | 59071930001 | ||||||
| GATTO, Salvatore Martin | Geschäftsführer | 11 Cavendish Lodge Cavendish Road BA1 2UD Bath Avon | United Kingdom | British | 37327260002 | |||||
| GRANT, Stephen Martin | Geschäftsführer | 3 Trelawn Court Rodney Road GL50 1JJ Cheltenham Gloucestershire | British | 20888800002 | ||||||
| HARTE, Damien Bernard | Geschäftsführer | 13 Cambridge Park Redland BS6 6XW Bristol | British | 33922420001 | ||||||
| HENSHAW, Stephen Anthony | Geschäftsführer | 2 Ashton Coombe Lower Road Bratton BA13 4JQ Westbury Wiltshire | British | 91828160003 | ||||||
| MITCHELL INNES, Alistair Campbell | Geschäftsführer | Langton Lodge Station Road Sunningdale SL5 0QR Ascot Berkshire | British | 1386650001 | ||||||
| NELLIST, Robert Henry Harger | Geschäftsführer | Spooners 28 Park St Lane Park Street AL2 2JB St Albans Hertfordshire | British | 5435750001 | ||||||
| ROBSON, William Henry Mark | Geschäftsführer | 12 Kimble Close Knightcote CV47 2SJ Southam Warwickshire | England | British | 57803420002 | |||||
| SMITH, Alan Frank | Geschäftsführer | Brambledown Grove Farm Droitwich Road Feckenham B96 6JA Redditch Worcestershire | British | 46000100003 | ||||||
| SMITH, Neil Reynold | Geschäftsführer | 27 Broom Farm Close Nailsea BS48 4YJ Bristol | British | 61599510002 |
Hat LENNON'S GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 16. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company,each other group company (as defined) and any other present or future subsidiary of gateway group limited (as defined) to the chargee and/or the facility agent and/or the security agent (as defined) under the terms of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 15. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to samuel montagu & co. Limited as agent and trustee for the lenders (as defined therein) in respect of the guarantee and debunture dated 25TH october 1989 as amended by the supplemental deed dated 5TH july 1993 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Okt. 1990 Geliefert am 02. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from each obligor to s g warburg & co LTD (as agent and trustee for itself and for each lender (as defined) and the banks or any of them under the terms of each of the financing documents and all moneys due or to become due from each obligor to g e capital corporate finance group limited (the subordinated lenders agent) and to the subordinated lenders under the terms of the subordinated facilities agreement. | |
Kurze Angaben Various properties as detailed on form 395 including f/h 23 wrexham street, mold, clwyd (please see doc for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Okt. 1989 Geliefert am 31. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For details see certificate | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0