STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00358317 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?
- (7012) /
- (7020) /
Wo befindet sich STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Citygate Saint James Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Peter On als Geschäftsführer am 28. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Peter On am 17. Mai 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mark Greenwood als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nick On am 16. Sept. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rupert Dickinson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDLE, Michael Patrick | Sekretär | Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth High Priar Northumberland | British | 135308530001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Andrew Rolland | Geschäftsführer | Montagu Avenue NE3 4JH Newcastle Upon Tyne 35 Tyne And Wear | England | British | 74581390003 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Geschäftsführer | Slayley NE47 0AA Hexham Winter House Northumberland | United Kingdom | British | 154194730002 | |||||
| DENBY, Nigel Anthony | Sekretär | 2 Delph Wood Close BD16 3LQ Bingley West Yorkshire | British | 33799980001 | ||||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Sekretär | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | English | 86483290001 | ||||||
| HALLIWELL, Christine | Sekretär | 113 Drub Lane BD19 4BZ Cleckheaton West Yorkshire | British | 66463330001 | ||||||
| TETLEY, Brian | Sekretär | 123 Huddersfield Road WF15 7DA Liversedge West Yorkshire | British | 669890001 | ||||||
| WOOD, Timothy Barry | Sekretär | Littlebeck House 18 Nursery Lane Addingham LS29 0TN Ilkley West Yorkshire | British | 7212090002 | ||||||
| BAKER, David Graham | Geschäftsführer | St Michaels Bull Lane SL9 8RH Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 55556410001 | ||||||
| BURGESS, Harold Reginald John | Geschäftsführer | High Croft Whydown TN39 4RB Bexhill-On-Sea East Sussex | British | 669900001 | ||||||
| BUTTERWORTH, Gary Ronald | Geschäftsführer | 129 Chingford Avenue E4 6RG London | British | 63723110001 | ||||||
| CRUMBLEY, Brian Aidan | Geschäftsführer | 10 Westfield Grove Gosforth NE3 4YA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 8495220002 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Geschäftsführer | 17 Lintzford Road Hamsterley Mill Rowlands Gill NE39 1HA Newcastle Upon Tyne | England | British | 65421150003 | |||||
| DENBY, Nigel Anthony | Geschäftsführer | 2 Delph Wood Close BD16 3LQ Bingley West Yorkshire | British | 33799980001 | ||||||
| DICKINSON, Rupert Jerome | Geschäftsführer | 59 Albert Bridge Road SW11 4AQ London | United Kingdom | British | 60267600001 | |||||
| DIXON, Alistair William | Geschäftsführer | 245 Kennington Road SE11 6BY London | United Kingdom | British | 49174270004 | |||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Geschäftsführer | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | England | English | 86483290001 | |||||
| ON, Nicholas Peter | Geschäftsführer | The Links NE26 1RS Whitley Bay 31 Tyne & Wear | United Kingdom | British | 135860930002 | |||||
| ROBINSON, Nicholas Ambrose Eldred | Geschäftsführer | 4 Chapman Square HG1 2SL Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 669920002 | |||||
| ROBSON, Mark Jeremy | Geschäftsführer | 9 Southlands NE30 2QS Tynemouth Tyne & Wear | United Kingdom | British | 97977930001 | |||||
| SCHWERDT, Peter Christopher George | Geschäftsführer | The Court House 3 Church Street SN9 5DL Pewsey Wiltshire | British | 44923060002 | ||||||
| SLADE, Sean Anthony | Geschäftsführer | Idlewood Maidenhead Road SL6 9DF Cookham Berkshire | British | 94640230001 | ||||||
| STORY, James Dennis | Geschäftsführer | Kowhai Cottage Quarry Bank Utkinton CW6 0LA Tarporlex Cheshire | British | 98660380001 | ||||||
| TETLEY, Brian | Geschäftsführer | 123 Huddersfield Road WF15 7DA Liversedge West Yorkshire | British | 669890001 | ||||||
| WALL, John Robert | Geschäftsführer | 9 Fairlawn Park St Leonards Hill SL4 4HL Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 72368120001 | |||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Geschäftsführer | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840001 | |||||
| WATTS, Timothy Neil | Geschäftsführer | Silverwood The Warren KT20 6PQ Kingswood Surrey | British | 55556330002 | ||||||
| WINDLE, Michael Patrick | Geschäftsführer | High Priar Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | 43646700001 | |||||
| YUDOLPH, Debra Rachel | Geschäftsführer | 43 Netheravon Road W4 2AN London | England | British | 105582680001 |
Hat STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 22. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of accession and variation to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 22. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Mai 1960 Geliefert am 30. Mai 1960 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000 further advances | |
Kurze Angaben Various properties in stoke-on-trent, staffs see doc 51 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0