HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00363615 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall B47 6LW Birmingham United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF zum Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6LW am 15. Mai 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2018
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathon Paul Sowton am 10. Okt. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Po Box 1224 Pelham House Canwick Road Lincoln LN5 5NH zum Po Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF am 13. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Colm O'nuallain als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | c/o C/O Grafton Group Plc Corrig Road Sandyford Industrial Estate IRELAND Dublin 18 Heron House Ireland |
| 97259990001 | ||||||||||
| O'HARA, Brian | Geschäftsführer | c/o Grafton Group Plc Corrig Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Heron House Ireland | Ireland | Irish | 181212990001 | |||||||||
| SOWTON, Jonathon Paul | Geschäftsführer | RH4 1QT Dorking Oak Green House, 250-256 High Street Surrey United Kingdom | England | British | 151407670001 | |||||||||
| CLARKSON, Stuart Michael | Sekretär | Flat 3 Woodbank Croft 51 Botanical Road S11 8RP Sheffield South Yorkshire | British | 10425780002 | ||||||||||
| BLOOMER, Elizabeth | Geschäftsführer | Old Quarry Sitwell Grove S60 3AY Rotherham South Yorkshire | British | 10425790001 | ||||||||||
| BLOOMER, Robert John Giles, Dr | Geschäftsführer | Lindrick House Lindrick Common, Woodsetts S81 8BA Worksop Nottinghamshire | Uk | British | 110338040001 | |||||||||
| BRISTOWE, Neville Henry | Geschäftsführer | 21 Rotherstoke Close S60 2JU Rotherham South Yorkshire | British | 10425800001 | ||||||||||
| CHADWICK, Michael | Geschäftsführer | 39 Serpentine Avenue Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | 16417710002 | |||||||||
| CLARKSON, Stuart Michael | Geschäftsführer | Flat 3 Woodbank Croft 51 Botanical Road S11 8RP Sheffield South Yorkshire | British | 10425780002 | ||||||||||
| COPLEY, Robert | Geschäftsführer | 83 The Rookery Deepcar S36 2NE Sheffield South Yorkshire | England | British | 50088500002 | |||||||||
| MARTIN, Leo James | Geschäftsführer | c/o Grafton Group Plc Corrig Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Heron House Ireland | Ireland | Irish | 144555840001 | |||||||||
| MCCABE, Michael Francis | Geschäftsführer | 31 East Field Close Headington OX3 7SH Oxford | England | Irish | 87622560002 | |||||||||
| MIDDLETON, Kevin Paul | Geschäftsführer | Pelham House LN5 5NH Canwick Road PO BOX 1224 Lincoln | England | British | 61374610002 | |||||||||
| O'HARA, Brian | Geschäftsführer | Seacrest Skerries 29 Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | 181212990001 | |||||||||
| O'NUALLAIN, Colm | Geschäftsführer | c/o Grafton Group Plc Corrig Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Heron House Ireland | Ireland | Irish | 79602480001 | |||||||||
| PARES, Michael | Geschäftsführer | 1 Ashcroft HA5 4DB Pinner Middlesex | England | British | 21670040001 | |||||||||
| RINN, Charles Anthony | Geschäftsführer | Holly Tree Littlenewtown Enniskerry Co Wicklow Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 71734430002 | |||||||||
| SOWTON, Jonathon Paul | Geschäftsführer | Wellbottom Cottage The Downs KT22 8JZ Leatherhead Surrey | England | British | 151407670001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafton Group (Uk) Plc | 06. Apr. 2016 | 250-256 High Street RH4 1QT Dorking Oak Green House Surrey England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 02. Okt. 1989 Geliefert am 06. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts and other debts owing to the company floating charge over the undertkaing and all property and assets present and future including book debts & excluding those mentioned above. Uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Feb. 1985 Geliefert am 01. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & premises situate in rawmarsh road rotherham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 01. Feb. 1985 Geliefert am 01. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Feb. 1985 Geliefert am 01. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land & premises situate in rawmarsh road, rotherham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1981 Geliefert am 08. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildigns situate in rowmarsh rd, rotherham south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1981 Geliefert am 08. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property & buildings situate adjacent to the british waterways boards sheffield & south yorkshire navigation fronting on to rawmarsh road rotherham south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 1981 Geliefert am 11. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all proprty and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 16. Feb. 1981 Geliefert am 25. Feb. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all the book debts and other debts o{f the company both present and future (see doc M10 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0