T.H.BRICKELL & SON,LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | T.H.BRICKELL & SON,LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00366134 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1580 Parkway Solent Business Park PO15 7AG Whiteley, Fareham Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. März 2021 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Longmead Industrial Estate Shaftesbury Dorset SP7 8PX zum 1580 Parkway Solent Business Park Whiteley, Fareham Hampshire PO15 7AG am 09. Apr. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 36 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRIS, Stuart Ambrose | Sekretär | 17 Wesley Road BH21 2PG Wimborne Dorset | English | 2416320003 | ||||||
| MORRIS, Stuart Ambrose | Geschäftsführer | 17 Wesley Road BH21 2PG Wimborne Dorset | England | English | 2416320003 | |||||
| SMITH, Peter Ronald | Geschäftsführer | Cowlgaze Semley SP7 9AP Shaftesbury Dorset | England | English | 52533260001 | |||||
| PROSSER, Susan Anne | Sekretär | Glamaig Bittles Green Motcombe SP7 9NX Shaftesbury Dorset | British | 6976780001 | ||||||
| BRICKELL, Christopher Norman | Geschäftsführer | Northmoor House Purns Mill Lane Colesbrook SP8 4HH Gillingham Dorset | United Kingdom | British | 8993560002 | |||||
| BRICKELL, Julian | Geschäftsführer | Applehay Church Street Shaftesbury SP7 9AU Dorset | British | 50272290001 | ||||||
| DAVIS, Donald Conway | Geschäftsführer | Austen Wood Austenwood Common SL9 8NL Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 4588730001 | |||||
| PRYDE, George Hogg Selkirk | Geschäftsführer | 51a Queen Street EH2 3NS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 68287430001 | |||||
| WARD, Garry | Geschäftsführer | Brickwall House Queen Street Sible CO9 3RH Hedingham Essex | England | British | 59460020002 | |||||
| WILLIAMS, Robin Charles | Geschäftsführer | The Orchard Gloucester Road Andoversford GL54 4HR Cheltenham Gloucestershire | British | 7069670001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei T.H.BRICKELL & SON,LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Stuart Ambrose Morris | 24. Aug. 2016 | Solent Business Park PO15 7AG Whiteley, Fareham 1580 Parkway Hampshire | Nein |
Nationalität: English Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Peter Ronald Smith | 24. Aug. 2016 | Solent Business Park PO15 7AG Whiteley, Fareham 1580 Parkway Hampshire | Nein |
Nationalität: English Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat T.H.BRICKELL & SON,LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 18. März 2010 Geliefert am 24. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and blckmore limited and lamport gilbert limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the south side of wincombe lane longmead industrial estate shaftesbury dorset t/n DT264367. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 21. Sept. 2001 Geliefert am 25. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (1) heidelberg speedmaster printing press s/no. 535024. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. Mai 2000 Geliefert am 20. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a 3 darwin close reading berkshire t/n BK49542. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Nov. 1998 Geliefert am 14. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben F/H property registered with title absolute at hm land registry DT226246 and f/h property at the longmead industrial estate comprised in a conveyance dated 21/01/74. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 25. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1XTYPE 102ZP heidelberg speedmaster 72CM x 102CM two-colour/perfector offset lithographic printing machine s/NO523348 1XTYPE sormz heidelberg 52CM x 74CM two colour offset lithographic printing machine s/no 525121 1XTYPE 72V heidelberg four-colour offset lithographic printing machine s/no 528025 and all the other assets as listed in the schedule attached to the form 395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Apr. 1995 Geliefert am 19. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part plot 2 longmead industrial estate shaftesbury dorset with all buildings and fixtures theron and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 15. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing £22,476.03 | |
Kurze Angaben All sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 21. Sept. 1992 Geliefert am 28. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement | Erstellt am 14. Aug. 1992 Geliefert am 25. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £17,841.60 | |
Kurze Angaben All sums due under the insurance see 395262C 26/8 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 15. Okt. 1990 Geliefert am 17. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben One solna webb offset press D25D printing unit no. 372/908-909 and folder no. 978/382. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Okt. 1982 Geliefert am 17. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings trade & other fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1979 Geliefert am 21. Aug. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. With all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery & premises at longmead industrial estate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat T.H.BRICKELL & SON,LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0