DORSMAN ESTATES CO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDORSMAN ESTATES CO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00368352
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Apr. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    4 SeitenCOCOMP

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:re removal of liq
    7 SeitenLIQ MISC OC

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 18/07/2014
    33 SeitenLIQ MISC

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    6 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juli 2013

    49 Seiten2.24B

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    4 SeitenCOCOMP

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Wer sind die Geschäftsführer von DORSMAN ESTATES CO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Sekretär
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Geschäftsführer
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritishIt Director62596180004
    ELLIS, Roy George
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    WalesBritishDirector161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director54276260003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Sekretär
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    MORGAN, David John
    Flat 2 258 Hagley Road
    DY9 0RW Stourbridge
    Worcestershire
    Sekretär
    Flat 2 258 Hagley Road
    DY9 0RW Stourbridge
    Worcestershire
    British35923980005
    SHEPPARD, Jonathan Lance
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Sekretär
    Borrowdale Close
    Penylan
    CF23 5LQ Cardiff
    7
    Wales
    Welsh98026690002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Sekretär
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British49912180001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Geschäftsführer
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritishFinance Director54831150003
    BULLAS, Michael Stuart
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director86392570001
    CHILD, Hugh
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Village House
    Colwinston
    CF7 7NL Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    BritishChartered Accountant16578300001
    GIPSON, Stephen
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    BritishRetail Director90147660001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector75927820002
    PEACOCK, Robert Frank
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Geschäftsführer
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    BritishCompany Director13070020001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Geschäftsführer
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritishCompany Director131678400001

    Hat DORSMAN ESTATES CO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 25. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all its right, title and interest in and to the property k/a 17 & 18 taff street, pontypridd t/no. WA545538 and unit e, cae mawr industrial estate t/no. WA957651 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery thereon and all related rights (the real property) and the intellectual property. First floating charge the whole of its undertaking and assets, present and future, other than any assets validly and effectively charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee
    Transaktionen
    • 25. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A debenture made by the company,the peacock group PLC,peacocks (nantgarw) limited and peacock's stores limited (together with the company,the "chargors")
    Erstellt am 12. Sept. 2001
    Geliefert am 18. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations due or to become due from the chargor to the chargee,as trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined), including the debenture, and including any liability in respect of any further advances made under the secured documents
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all rights,title and interest from time to time in and to the real property known as (I) 17 and 18 taff street,pontypridd,rhondda cyon taff (wa 545538) and (ii) unit e,cae mawr industrial estate,treorchy,rhondda cyon taff (wa 957651) with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant or machinery thereon; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Erstellt am 02. Dez. 1999
    Geliefert am 17. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Group debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 08. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the chargee in it's capacity as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties or any of them under any of the financing documents (as defined) and under the debenture in whatsoever manner
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. März 1995
    Geliefert am 25. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from peacock's stores limited and from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land at sanatorium road, cardiff. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 1994
    Geliefert am 20. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at sanatorium road, cardiff. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Sept. 1991
    Geliefert am 20. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or peacock's stores limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property fronting sanatorium road canton cardiff south glamorgan and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Sept. 1991
    Geliefert am 20. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or peacock's stores to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Buildings north side sanatorium road canton cardiff south glamorgan title no. WA133241 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1980
    Geliefert am 31. Jan. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or peacoks stores limited t o any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at sanatorium road canton cardiff S. glamorgan title no: WA133241.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat DORSMAN ESTATES CO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Jan. 2012Beginn der Verwaltung
    19. Juli 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jonathan Scott Pope
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff
    Praktiker
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff
    2
    DatumTyp
    25. Nov. 2015Abschluss der Liquidation
    28. Juni 2013Antragsdatum
    19. Juli 2013Beginn der Liquidation
    03. März 2016Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Reading
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading
    Praktiker
    3d Apex Plaza
    Forbury Road
    RG1 1AX Reading
    Jonathan Scott Pope
    3 Britannia Quay
    CF10 4AX Cardiff
    South Glamorgan
    Praktiker
    3 Britannia Quay
    CF10 4AX Cardiff
    South Glamorgan
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0