B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00378035 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Company Secretariat Faraday Road SN3 5HH Dorcan Swindon |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Sept. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark David Sawyer am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Terry Wilkinson am 18. März 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Terry Wilkinson am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ashley Raymond Fulford am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Harold Gregory Barksdale am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILKINSON, Terry | Sekretär | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics United Kingdom | British | 80634780001 | ||||||
| BARKSDALE, Harold Gregory | Geschäftsführer | 1050 Westlakes Drive 19312 Berwyn Tyco Electronics Pennsylvania Usa | United States | American | 137883380001 | |||||
| FULFORD, Ashley Raymond | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics Devon United Kingdom | United Kingdom | British | 125426610001 | |||||
| SAWYER, Mark David | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics Wilts United Kingdom | England | British | 123023180001 | |||||
| WILKINSON, Terry | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics United Kingdom | United Kingdom | British | 80634780001 | |||||
| ALLDRITT, Nigel Christopher | Sekretär | Beaumaris 215 Tamworth Road Kettlebrook B77 1BT Tamworth Staffordshire | British | 4564310001 | ||||||
| BERRY, Linda June | Sekretär | Pear Tree Farm Wymeswold Road Wysall NG12 5QU Nottingham Nottinghamshire | British | 11568580001 | ||||||
| GODDING, David Edward | Sekretär | Glebe Farmhouse Daglingworth GL7 7AE Cirencester Gloucestershire | British | 86621750001 | ||||||
| GODFRAY, Terence William | Sekretär | 39 Robin Lane GU47 9AU Sandhurst Berkshire | British | 63510007 | ||||||
| ALLAN, Stuart | Geschäftsführer | 16 Fernham Gate SN7 7LR Faringdon Oxon | British | 78209550003 | ||||||
| ALLDRITT, Nigel Christopher | Geschäftsführer | Beaumaris 215 Tamworth Road Kettlebrook B77 1BT Tamworth Staffordshire | British | 4564310001 | ||||||
| BERRY, John Malcolm | Geschäftsführer | The Old Vicarage 39 Main Street Kinoulton NG12 3EA Nottingham | British | 53987460001 | ||||||
| BERRY, John Malcolm | Geschäftsführer | The Old Vicarage 39 Main Street Kinoulton NG12 3EA Nottingham | British | 53987460001 | ||||||
| BERRY, Linda June | Geschäftsführer | Pear Tree Farm Wymeswold Road Wysall NG12 5QU Nottingham Nottinghamshire | British | 11568580001 | ||||||
| CLARKE, Graham James | Geschäftsführer | Winslow Coombe Ashbury SN6 8LN Swindon Wiltshire | British | 45998730001 | ||||||
| COBLEY, Steven John | Geschäftsführer | 66 Rookery Road Knowle BS4 2DT Bristol | British | 80634650001 | ||||||
| COOKE, Timothy Hugh | Geschäftsführer | The Coppice Bowden Hill SN15 2PP Lacock Chippenham Wiltshire | British | 80681960001 | ||||||
| GATT, Tony Martin | Geschäftsführer | Hobbingfoot 48 High Street SG4 7LA Graveley Hertfordshire | United Kingdom | British | 73889200001 | |||||
| GILLESPIE, Alistair Neil | Geschäftsführer | 62 Swithland Lane Rothley LE7 7SE Leicester Leicestershire | British | 5589350005 | ||||||
| HUNT, Thomas William | Geschäftsführer | 5 The Green NE39 2LL Rowlands Gill Tyne & Wear | British | 64248650001 | ||||||
| LLOYD, Simon John | Geschäftsführer | 31 Cambrian Way LE65 1DX Ashby De La Zouch Leicestershire | British | 36790860002 | ||||||
| MARTIN, David Neil | Geschäftsführer | Holly House Guilsborough Road NN6 8EW Ravensthorpe Northampton | England | British | 93985370001 | |||||
| NEALE, Leslie | Geschäftsführer | Hemp Leys Field Lane NG12 5QF Widmerpool Notts | British | 18518260002 | ||||||
| STUCKEY, Michael | Geschäftsführer | 34 Glen Brook Priorslee TF2 9QY Telford Shropshire | British | 15174680002 |
Hat B.& H.(NOTTINGHAM)LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Aug. 1998 Geliefert am 12. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 05. Mai 1998 Geliefert am 20. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or kurtbrook limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge (all assets) | Erstellt am 28. Apr. 1998 Geliefert am 08. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Apr. 1997 Geliefert am 01. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Apr. 1997 Geliefert am 24. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on book debts | Erstellt am 20. Juni 1994 Geliefert am 08. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book debts including invoice debts accounts notes bill acceptance and or other forms of obligation or indebtedness incurred by any of the companys debtors pursuant to any contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 18. Nov. 1993 Geliefert am 09. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the debenture dated 14 august 1987 | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 10 march 1993 (for full details of charge see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Aug. 1987 Geliefert am 25. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. März 1987 Geliefert am 07. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Grove works, lanthwaite road, clifton, nottinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. Dez. 1964 Geliefert am 30. Dez. 1964 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold factory: grove works, lanthwaite road, clifton, nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0