AMEC SPARECO (12) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAMEC SPARECO (12) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00381547
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AMEC BIRWELCO LIMITED24. Okt. 200024. Okt. 2000
    AGRA BIRWELCO LIMITED01. März 199901. März 1999
    BIRWELCO LIMITED18. Feb. 198718. Feb. 1987
    GKN BIRWELCO LIMITED06. Juli 194306. Juli 1943

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Jennifer Ann Warburton als Sekretär am 22. Feb. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Helen Morrell als Sekretär am 22. Feb. 2017

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Helen Morrell als Sekretär am 22. Juli 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Christopher Laskey Fidler als Sekretär am 22. Juli 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2016

    • Kapital: GBP 750,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Juni 2015

    • Kapital: GBP 750,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2014

    • Kapital: GBP 750,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Allen als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Amec Nominees Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    4 SeitenAUD

    Verschiedenes

    Section 519
    3 SeitenMISC

    Wer sind die Geschäftsführer von AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WARBURTON, Jennifer Ann
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Sekretär
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    225597720001
    LING, Grant Richmond
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    Geschäftsführer
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    EnglandBritish68935320003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer374498
    32732300002
    ELLIOTT, David John
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    Sekretär
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    British99771830001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Sekretär
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MORRELL, Helen
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Sekretär
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    210981190001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001
    ALLEN, Mark Edward Hugh
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    EnglandBritish148511740001
    AVENAS, Michel
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    Geschäftsführer
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    French36238710002
    BERARD, Jean-Paul
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    Geschäftsführer
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    French14302260001
    BIDDLE, Norman Michael, Dr
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Geschäftsführer
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    United KingdomBritish35032440001
    CARTWRIGHT, Brian Harry
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    British14302270001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    British107105790003
    CLARKE, John James
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    Geschäftsführer
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    United KingdomBritish150891000001
    COADY, Arthur Bernard
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Geschäftsführer
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Canadian14302210001
    COWPER, Jonathan
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    British124817460001
    DELIGNY, Jean Louis
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    Geschäftsführer
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    French45894430001
    DITTMER, Robert
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Geschäftsführer
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Canadian61292360003
    ELIA, Claudio
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Geschäftsführer
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Italian36238720001
    EMMANUEL, Derousseaux
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    Geschäftsführer
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    French60092120001
    GOURVENNEC, Michel Jean Jacques
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    Geschäftsführer
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    French41434270003
    HAEGEL, Didier Gerard Patrick
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    Geschäftsführer
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    French42856880001
    HIGGINS, Nigel Alan
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish119181620001
    KENNEDY, Michael George
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    Geschäftsführer
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    British46681650001
    LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    Geschäftsführer
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    French47515880001
    LEBRUN, Andre, Msr
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    Geschäftsführer
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    French34945510001
    LEE, Stephen Warwick
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    British84186060002
    PATTERSON, Martin
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Geschäftsführer
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Canadian14302220001
    PEARSON, Harold William
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Canadian63588330001
    PFLEGER, Didier Maurice Christian
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    Geschäftsführer
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    French128722240001
    PRICE, John Leslie
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Geschäftsführer
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Canadian14302230001
    REALE, Robert J
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Geschäftsführer
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Us47515760001
    REDDEN, Charles Frederick David
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Geschäftsführer
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Canadian61291470001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    06. Apr. 2016
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4612748
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat AMEC SPARECO (12) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment of insurance (the "assignment")
    Erstellt am 12. Mai 1999
    Geliefert am 26. Mai 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Kurze Angaben
    The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transaktionen
    • 26. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating security document (the "security document")
    Erstellt am 12. Mai 1999
    Geliefert am 26. Mai 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transaktionen
    • 26. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 01. Dez. 1998
    Geliefert am 09. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 10. Apr. 1992
    Geliefert am 28. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Aug. 1990
    Geliefert am 24. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A credit agreement
    Erstellt am 15. März 1990
    Geliefert am 27. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 27. März 1990Registrierung einer Belastung
    Charge on book debts
    Erstellt am 06. Sept. 1989
    Geliefert am 14. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Feb. 1989
    Geliefert am 27. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banque Arake Et International I'investisement
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    Supplemental trust deed
    Erstellt am 16. Mai 1980
    Geliefert am 25. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Assurance
    Transaktionen
    • 25. Mai 1980Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0