AMEC SPARECO (12) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AMEC SPARECO (12) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00381547 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AMEC SPARECO (12) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AMEC BIRWELCO LIMITED | 24. Okt. 2000 | 24. Okt. 2000 |
| AGRA BIRWELCO LIMITED | 01. März 1999 | 01. März 1999 |
| BIRWELCO LIMITED | 18. Feb. 1987 | 18. Feb. 1987 |
| GKN BIRWELCO LIMITED | 06. Juli 1943 | 06. Juli 1943 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jennifer Ann Warburton als Sekretär am 22. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Morrell als Sekretär am 22. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Helen Morrell als Sekretär am 22. Juli 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Laskey Fidler als Sekretär am 22. Juli 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Allen als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Amec Nominees Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 4 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARBURTON, Jennifer Ann | Sekretär | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | 225597720001 | |||||||||||
| LING, Grant Richmond | Geschäftsführer | The Academy 16 Highgate Hill N19 5NS London Flat 24 | England | British | 68935320003 | |||||||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England |
| 32732300002 | ||||||||||
| ELLIOTT, David John | Sekretär | Temple View Banner Lane, Barston B92 0JY Solihull | British | 99771830001 | ||||||||||
| FELLOWES, Colin | Sekretär | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Sekretär | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||||||
| MORRELL, Helen | Sekretär | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | 210981190001 | |||||||||||
| RENSHAW, Geoffrey Mark | Sekretär | 9 Morgrove Avenue Knowle B93 9QL Solihull West Midlands | British | 61351870001 | ||||||||||
| ALLEN, Mark Edward Hugh | Geschäftsführer | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | England | British | 148511740001 | |||||||||
| AVENAS, Michel | Geschäftsführer | 16 Rue Du Colonel Candelot 92340 Bourg La Reine France | French | 36238710002 | ||||||||||
| BERARD, Jean-Paul | Geschäftsführer | 1 Westmount Square Suite 650 FOREIGN Montreal Quebec H32 2sr Canada | French | 14302260001 | ||||||||||
| BIDDLE, Norman Michael, Dr | Geschäftsführer | The Chantry 25 Church Road, Abbots Leigh BS8 3QP Bristol | United Kingdom | British | 35032440001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Brian Harry | Geschäftsführer | Tannery Cottage Manchester Road Lostock Gralam CW9 7PJ Northwich Cheshire | British | 14302270001 | ||||||||||
| CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd | Geschäftsführer | 58 Bracken Road HX6 2HR Brighouse West Yorkshire | British | 107105790003 | ||||||||||
| CLARKE, John James | Geschäftsführer | Manor Close East Horsley KT24 6SB Leatherhead Dalehurst Surrey | United Kingdom | British | 150891000001 | |||||||||
| COADY, Arthur Bernard | Geschäftsführer | 79 Bel Air Place Sw FOREIGN Calgary Alberta T2z 2c3 Canada | Canadian | 14302210001 | ||||||||||
| COWPER, Jonathan | Geschäftsführer | 2 Bluebell Close Etherley Dene DL14 0TL Bishop Auckland County Durham | British | 124817460001 | ||||||||||
| DELIGNY, Jean Louis | Geschäftsführer | 106 Avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billancourt France | French | 45894430001 | ||||||||||
| DITTMER, Robert | Geschäftsführer | 78 Sunset Way S E Calgary Alberta T2x 3c1 Canada | Canadian | 61292360003 | ||||||||||
| ELIA, Claudio | Geschäftsführer | 40 Ridgeview Avenue Greenwich Ct06830 Usa | Italian | 36238720001 | ||||||||||
| EMMANUEL, Derousseaux | Geschäftsführer | 25 Rue St J B De La Salle Lille FOREIGN France 59000 | French | 60092120001 | ||||||||||
| GOURVENNEC, Michel Jean Jacques | Geschäftsführer | 3151 Freeman Street Coconut Grove Florida 33133 Usa | French | 41434270003 | ||||||||||
| HAEGEL, Didier Gerard Patrick | Geschäftsführer | 13-15 Rue De 8 Mai 1945 Villiers Sur Marne FOREIGN 94350 France | French | 42856880001 | ||||||||||
| HIGGINS, Nigel Alan | Geschäftsführer | Conifers Cecil Avenue HX3 8SN Halifax West Yorkshire | England | British | 119181620001 | |||||||||
| KENNEDY, Michael George | Geschäftsführer | 34 Rue Numa Gillet 77690 Montigny Sur Loing France | British | 46681650001 | ||||||||||
| LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre | Geschäftsführer | 51 Rue D Archeres Maisons Laffitte 78600 France | French | 47515880001 | ||||||||||
| LEBRUN, Andre, Msr | Geschäftsführer | 3 Avenue Stephane Mallarme Paris 75017 FOREIGN France | French | 34945510001 | ||||||||||
| LEE, Stephen Warwick | Geschäftsführer | The Barn Hildenley YO17 6QU Malton North Yorkshire | British | 84186060002 | ||||||||||
| PATTERSON, Martin | Geschäftsführer | 985 Clement FOREIGN Saint - Laurent Quebec H2v 3zx Canada | Canadian | 14302220001 | ||||||||||
| PEARSON, Harold William | Geschäftsführer | 136 Avondale Court L7L2M8 Burlington Ontario Canada | Canadian | 63588330001 | ||||||||||
| PFLEGER, Didier Maurice Christian | Geschäftsführer | Faubourg De Brisach 90000 Belfort 34 France | French | 128722240001 | ||||||||||
| PRICE, John Leslie | Geschäftsführer | 536 Coach Grove Road Sw FOREIGN Calgary Alberta T3h 1j4 Canada | Canadian | 14302230001 | ||||||||||
| REALE, Robert J | Geschäftsführer | 444 E86th St Apt 36f New York NY 10028 Usa | Us | 47515760001 | ||||||||||
| REDDEN, Charles Frederick David | Geschäftsführer | 161 Woodpark Cx S W Calgary Alberta T2w 6es FOREIGN Canada | Canadian | 61291470001 | ||||||||||
| RENSHAW, Geoffrey Mark | Geschäftsführer | 9 Morgrove Avenue Knowle B93 9QL Solihull West Midlands | British | 61351870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AMEC SPARECO (12) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amec Foster Wheeler Group Limited | 06. Apr. 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AMEC SPARECO (12) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of insurance (the "assignment") | Erstellt am 12. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Kurze Angaben The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating security document (the "security document") | Erstellt am 12. Mai 1999 Geliefert am 26. Mai 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 01. Dez. 1998 Geliefert am 09. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 10. Apr. 1992 Geliefert am 28. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Aug. 1990 Geliefert am 24. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A credit agreement | Erstellt am 15. März 1990 Geliefert am 27. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on book debts | Erstellt am 06. Sept. 1989 Geliefert am 14. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 22. Feb. 1989 Geliefert am 27. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 16. Mai 1980 Geliefert am 25. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0