ROHAWK PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameROHAWK PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00381930
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 27. Juli 2023

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 31 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer8992198
    187856670001
    HAYMAN, Josephine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant266797860001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    CHIA, Swee Ming
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    Sekretär
    10 Mount Ephraim Road
    Streatham
    SW16 1NG London
    BritishCertified Accountant57837290001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Sekretär
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    British3470530003
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Sekretär
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Geschäftsführer
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    CAFFARATE, Chrales Ernest John
    62 Cornwall Road
    Cheam
    SM2 6DS Sutton
    Surrey
    Geschäftsführer
    62 Cornwall Road
    Cheam
    SM2 6DS Sutton
    Surrey
    BritishChareterd Surveyor73954170001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DAVIDSON, Emanuel Wolfe
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    Geschäftsführer
    6 Beechworth Close
    NW3 7UT London
    United KingdomBritishCompany Director3470540001
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Geschäftsführer
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishSurveyor35563210002
    DAVIDSON, Gerald Abraham
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    Geschäftsführer
    Gardnor House
    Flask Walk
    NW3 1HT London
    United KingdomBritishCompany Director35563210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Geschäftsführer
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HUBERMAN, Paul Laurence
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    Geschäftsführer
    80 Kingsley Way
    N2 0EN London
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishHead Of Secretariat226746900001
    JONES, Amanda Jane
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant73507000004
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Geschäftsführer
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    RANGER, Patrick
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    Geschäftsführer
    2 Park Hill
    Ealing
    W5 2JR London
    EnglandBritishChartered Surveyor80021100001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Geschäftsführer
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    ROBSON, Tom
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Accountant266793650001
    ROSCOE, Antony David
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    Geschäftsführer
    54 Fowlers Walk
    W5 1BG London
    BritishChartered Surveyor12774060001
    SCOTT, James Andrew
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    13 Fairfield Lane
    SL2 3BX Farnham Royal
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor79599370001
    STEWART, David Purcell
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    Geschäftsführer
    The Oast House Best Beech
    TN5 6JH Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritishChartered Accountant56336720001
    WARD, Christopher Peter Alan
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Bacons Drive
    EN6 4DU Cuffley
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant80990890001
    WEBB, Nigel Mark
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROHAWK PROPERTIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer823907
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Bld Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RechtsgrundlageCompanies House 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat ROHAWK PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 29. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 55A lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18260 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 29. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 55C lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18247 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 29. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 9 adelaide court hill road st john's wood london borough of city of westminster t/n NGL742631 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 30 yew tree court london NW11 all present and future book debts rents and licence fees the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 11 yew tree court london NW11 present and future book and other debts by way of assignment the goodwill of the businessthe benefit of all guarantees rent and licence fees. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 14 yew tree court london NW11 all present and future book debts,rents and licence fees,the benefit of all guarantees and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 22 yew tree court london NW11 all book and other debts rents and licence fees by way of assignment the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 23. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 26 yew tree court london NW11 present and future book debts,goodwillthe benefit of all guarantees,shares. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 04. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    48 tavistock avenue st albans hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 04. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18C vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 04. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 3 courtleigh bridge lane golders green london NW11 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 04. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 5 barham house 39/40 molyneux street london N1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Dez. 1992
    Geliefert am 04. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18E vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1992
    Geliefert am 21. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    99 silvermere road london borough of lewisham title no. Ln 108526.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1992
    Geliefert am 21. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 wychwood avenue thornton heath london borough of croydon title no. Sgl 536736.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Dez. 1992
    Geliefert am 21. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    42 azof street london borough of greenwich title no. Sgl 320098.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 1992
    Geliefert am 02. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    52 moorland road st austell cornwall.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 1992
    Geliefert am 02. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4,4A 6,6A 8,8A 10,10A 12,12A 14,14A 16,16A 18,18A 20,20A 22, and 22A castle view road weybridge and garages 1 to 8 (all) surrey title no: SY385694.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 92 tynemouth road l/b of merton and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 92 howard road woodside l/b of croydon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    12 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555265 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 18 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 4 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 1993Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    28 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555251 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Sept. 1992
    Geliefert am 18. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    35 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555244 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0