ROHAWK PROPERTIES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROHAWK PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00381930 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Juli 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 19 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 22 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 23 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 24 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 30 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 31 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 16 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
HAYMAN, Josephine | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 266797860001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
CHIA, Swee Ming | Sekretär | 10 Mount Ephraim Road Streatham SW16 1NG London | British | Certified Accountant | 57837290001 | |||||||||
EKPO, Ndiana | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
HUBERMAN, Paul Laurence | Sekretär | 80 Kingsley Way N2 0EN London | British | 3470530003 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Sekretär | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BERGIN, Gavin | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Geschäftsführer | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
CAFFARATE, Chrales Ernest John | Geschäftsführer | 62 Cornwall Road Cheam SM2 6DS Sutton Surrey | British | Chareterd Surveyor | 73954170001 | |||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Geschäftsführer | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
DAVIDSON, Emanuel Wolfe | Geschäftsführer | 6 Beechworth Close NW3 7UT London | United Kingdom | British | Company Director | 3470540001 | ||||||||
DAVIDSON, Gerald Abraham | Geschäftsführer | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | Surveyor | 35563210002 | ||||||||
DAVIDSON, Gerald Abraham | Geschäftsführer | Gardnor House Flask Walk NW3 1HT London | United Kingdom | British | Company Director | 35563210002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Geschäftsführer | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
HUBERMAN, Paul Laurence | Geschäftsführer | 80 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | Chartered Accountant | 3470530003 | ||||||||
JAMES, Bruce Michael | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Head Of Secretariat | 226746900001 | ||||||||
JONES, Amanda Jane | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 73507000004 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Geschäftsführer | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
MIDDLETON, Charles John | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
RANGER, Patrick | Geschäftsführer | 2 Park Hill Ealing W5 2JR London | England | British | Chartered Surveyor | 80021100001 | ||||||||
ROBERTS, Graham Charles | Geschäftsführer | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
ROBSON, Tom | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Financial Accountant | 266793650001 | ||||||||
ROSCOE, Antony David | Geschäftsführer | 54 Fowlers Walk W5 1BG London | British | Chartered Surveyor | 12774060001 | |||||||||
SCOTT, James Andrew | Geschäftsführer | 13 Fairfield Lane SL2 3BX Farnham Royal Buckinghamshire | British | Chartered Surveyor | 79599370001 | |||||||||
STEWART, David Purcell | Geschäftsführer | The Oast House Best Beech TN5 6JH Wadhurst East Sussex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 56336720001 | ||||||||
WARD, Christopher Peter Alan | Geschäftsführer | 36 Bacons Drive EN6 4DU Cuffley Hertfordshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 80990890001 | ||||||||
WEBB, Nigel Mark | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROHAWK PROPERTIES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bld Property Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Bld Property Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ROHAWK PROPERTIES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 29. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 55A lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18260 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 29. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 55C lamont road london borough of kensington & chelsea t/n BGL18247 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 29. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a 9 adelaide court hill road st john's wood london borough of city of westminster t/n NGL742631 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 28. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 30 yew tree court london NW11 all present and future book debts rents and licence fees the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 28. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 11 yew tree court london NW11 present and future book and other debts by way of assignment the goodwill of the businessthe benefit of all guarantees rent and licence fees. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 28. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 14 yew tree court london NW11 all present and future book debts,rents and licence fees,the benefit of all guarantees and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 28. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 22 yew tree court london NW11 all book and other debts rents and licence fees by way of assignment the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 23. Jan. 1997 Geliefert am 28. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 26 yew tree court london NW11 present and future book debts,goodwillthe benefit of all guarantees,shares. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 04. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 48 tavistock avenue st albans hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 04. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18C vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 04. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 3 courtleigh bridge lane golders green london NW11 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 04. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 5 barham house 39/40 molyneux street london N1 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Dez. 1992 Geliefert am 04. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 18E vera road fulham london and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 99 silvermere road london borough of lewisham title no. Ln 108526. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 wychwood avenue thornton heath london borough of croydon title no. Sgl 536736. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 42 azof street london borough of greenwich title no. Sgl 320098. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Sept. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 52 moorland road st austell cornwall. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Sept. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4,4A 6,6A 8,8A 10,10A 12,12A 14,14A 16,16A 18,18A 20,20A 22, and 22A castle view road weybridge and garages 1 to 8 (all) surrey title no: SY385694. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 92 tynemouth road l/b of merton and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 92 howard road woodside l/b of croydon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 12 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555265 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 18 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 4 belvedere court kings avenue clapham l/b of lambeth and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 28 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555251 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. Sept. 1992 Geliefert am 18. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 35 cavendish buildings gilbert street city of westminster title no: NGL555244 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0