HASLEMERE ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHASLEMERE ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00382593
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HASLEMERE ESTATES PUBLIC LIMITED COMPANY07. Sept. 194307. Sept. 1943

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von Zahra Peermohamed als Sekretär am 19. Juli 2018

    1 SeitenTM02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 16. Juli 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Juni 2018

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Miss Zahra Peermohamed als Sekretär am 01. März 2018

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Paul Stewart Girling als Direktor am 26. Feb. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Sekretär am 28. Feb. 2018

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Geschäftsführer am 28. Feb. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    15 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Damien Ivo Karlov als Geschäftsführer am 28. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Derek Carter als Direktor am 24. Feb. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Anupam Manchanda als Geschäftsführer am 02. März 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Erfüllung der Belastung 173 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 169 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 170 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Panayot Kostadinov Vasilev als Geschäftsführer am 18. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    Sekretär
    105 Shepperton Road
    N1 3DF London
    British117898690002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Sekretär
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Sekretär
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    Sekretär
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910002
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Sekretär
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243694100001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Sekretär
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    British55097590003
    WEBSTER, Peter David
    34 West Common
    RH16 2AH Haywards Heath
    West Sussex
    Sekretär
    34 West Common
    RH16 2AH Haywards Heath
    West Sussex
    British33107380001
    WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Sekretär
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    British85529340001
    ABRAMSON, Christoffer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Geschäftsführer
    37-39 Abingdon Road
    Flat 2
    W8 6AH London
    Swedish98463110005
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Geschäftsführer
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Geschäftsführer
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURGER, Alec
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Adelade Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British And American83634080006
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Geschäftsführer
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    CLUTTON, Rafe Henry
    45 Berkeley Square
    W1X 5DB London
    Geschäftsführer
    45 Berkeley Square
    W1X 5DB London
    British71022260001
    CONNELLAN, Paul Francis
    7 Spencer Road
    TW7 4BQ Isleworth
    Middlesex
    Geschäftsführer
    7 Spencer Road
    TW7 4BQ Isleworth
    Middlesex
    British67336830001
    CREASEY, Maxwell Rogers
    47 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    47 St Botolphs Road
    TN13 3AG Sevenoaks
    Kent
    British3428010002
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Geschäftsführer
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Geschäftsführer
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    DELANEY, Martin Peter
    4 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish6499050001
    EDWARDS, Jeremy Colin Gamul
    Dray House Broomrigg Road
    GU13 8LR Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Dray House Broomrigg Road
    GU13 8LR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish225698250001
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JEVNE, Anne
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Geschäftsführer
    Flat 8
    70 Ironmonger Row
    EC1V 3QR London
    Norwegian106807190001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    KREMERS, Johan
    Rubenslaan 15
    FOREIGN 3723 Bn Bilthoven
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Rubenslaan 15
    FOREIGN 3723 Bn Bilthoven
    Netherlands
    Dutch8296290001
    LEE, David Robert
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910002
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Geschäftsführer
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MANCHANDA, Anupam
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish139855250001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HASLEMERE ESTATES LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    12. Apr. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat HASLEMERE ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Ninth supplemental trust deed dated 17TH and 21ST december 2004 and
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Erworben am 17. Nov. 2005
    Geliefert am 07. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000,000 and all other moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All l/h property demised pusuant to a supplemental lease and deed of variation dated 17 december 2004 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Irg Trustees Limited 'Trustee'
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2006Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 3 january 2002 and
    Erstellt am 16. Dez. 2002
    Geliefert am 11. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subjects known as 15-19 devon place,edinburgh; MID32235; all buildings fixtures thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed security document
    Erstellt am 16. Dez. 2002
    Geliefert am 23. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Present real property, other assets and assignments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental trust deed dated 6TH november 2002 and
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Erworben am 17. Nov. 2005
    Geliefert am 07. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects k/a whittaker house, 2 whittaker avenue, richmond upon thames t/no SGL520880, all and whole the area k/a richmond riverside site, richmond upon thames including (1) lower ground and ground floors, 13 hill street, richmond upon thames, surrey t/no SGL520879, for details of further property charged please refer to form 395, together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Axa Insurance PLC (Formerly K/a Guardian Royal Exchange Assurance PLC) 'Axa Trustee'
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2006Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 13. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 19. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from haslemere jersey finance limited and/or haslemere B.V. to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a the manor and manor court crawley t/nos WSX88129, WSX252913 and WSX94335.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fifth supplemental trust deed
    Erstellt am 06. Nov. 2002
    Geliefert am 15. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Payment to the chargee of the principal of and the interest on the existing stock (as defined in the trust deed) and all other money intended to be secured by the trust deed
    Kurze Angaben
    The property being l/h land k/a 46 berkley square and 46 hays mews london W1 in the county of greater london t/n NGL186778 and the l/h land k/a 105 piccadilly london SW1 in the county of greater london t/n 368978 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery (but excludingall tenants and trade fixtures and fitting).
    Berechtigte Personen
    • Axa Insurance PLC (Formerly K/a Guardian Royal Exchange Assurance PLC)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8 november 2002 and
    Erstellt am 01. Nov. 2002
    Geliefert am 18. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and/or the guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The dominium directum and the dominium utile of all and whole that angular area or piece of ground consisting of one acre, one rood and one pole imperial measure lying on the south side of devon place edinburgh in the county of midlothian. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limited (Acting as Trustee for the Bondholders and Thecouponholders (the Trustee))
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 11. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal sum of £20,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £45,832,312.67.
    Berechtigte Personen
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 24. Juni 1999
    Erworben am 17. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the issuer and/or the guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property known as 43-45 portman square london t/n LN96191, all buildings and fixtures, plant and machinery, the benefit of all leases,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limited (The Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2005Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 18. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust deed made between rodamco jersey finance limited (the "issuer"), rodamco united kingdom B.V. (the "guarantor"), the company, schildvink bv (together with the company the "original charging companies") and the trustee relating to and securing £150,000,000
    Erstellt am 24. Juni 1999
    Geliefert am 06. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the "trustee") on behalf of itself and for the benefit of the bondholders and the couponholders (as defined) in respect of the principal of and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all other monies covenanted to be paid by the issuer and/or the guarantor (or any successor in business of the issuer and/or the guarantor or any holding company of the guarantor who is or becomes a substituted obligor in accordance with clause 33.3 of the principal trust deed) to the trustee under or pursuant to the trust presents (as defined)
    Kurze Angaben
    L/H land k/a cable house (formerly called capel house) 54 to 62 new broad street london EC2 t/no: NGL529794. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 06. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Aug. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 03. Aug. 2001Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further deed of charge
    Erstellt am 29. Mai 1998
    Geliefert am 10. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement of 29 september 1980 and a legal charge of 1 july 1985
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings at 54/62 new broad street london EC2 t/n NGL529794 and all that l/h land under t/n DT144960 k/a land and buildings lying to the north of king street weymouth.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed
    Erstellt am 10. Feb. 1998
    Geliefert am 27. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 29TH september 1980 or the legal charges
    Kurze Angaben
    All amounts from time to time standing to the credit of account number 36137499 maintained with national westminster bank PLC of 1 princes street, london EC2R 8PH (the "deposit account") or to the credit of any replacement account;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge relating to a deposit
    Erstellt am 20. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £3,760,00 due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of 29 october 1980
    Kurze Angaben
    A deposit of £3,760,000.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 08. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £9,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge dated 1ST july 1985
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 46 st mary axe city of london t/no 436397.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 06. Feb. 1996
    Geliefert am 08. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 29TH september 1980 and a legal charge dat ed 1ST july 1985, a deed of release and substitution dated 31ST march 1988 and a deed of further charge dated 6TH september 1994 as amended or varied from time to time
    Kurze Angaben
    All amounts from time to time standing to the credit of an interest bearing capital reserve account in the name of the company with national westminster bank PLC on an account numbered 95854754. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 26. Jan. 1996
    Geliefert am 02. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £80,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 30 march 1973
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 2 bridge street tower house, 10 and 11 bridge street palm court. 4 heron square and heron house, 5 heron square richmond upon thames t/n SGL520881, f/h property the pinnacles estate coldharbour road harlow essex t/n's EX297012 and EX299961.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 26. Jan. 1996
    Geliefert am 02. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 1 november 1985
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 65 to 69 (odd) new cavendish street and 44/48 (inc) weymouth mews london W1 t/n LN35522.
    Berechtigte Personen
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further deed of charge
    Erstellt am 06. Sept. 1994
    Geliefert am 07. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee upon the terms and mortgage conditions of the principal charge (as defined in the further deed of charge dated 6 september 1994)
    Kurze Angaben
    4 college hill london.serborne HOUSE119/121 cannon street london EC4. 14 trinity square london EC3 and various properties. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 20. Juni 1994
    Geliefert am 23. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,000,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 1ST of november 1985
    Kurze Angaben
    22 bevis marks and 11/12 bury street and units 1 and 3 southampton road, salisbury, wiltshire.
    Berechtigte Personen
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and subsitution
    Erstellt am 20. Juni 1994
    Geliefert am 23. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £8,000,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 30TH of march 1973
    Kurze Angaben
    49,50 and bow lane and 51 bow lane london EC4.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transaktionen
    • 23. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 23. Sept. 1991
    Geliefert am 23. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £8,000,000 10 1/4% first mortgage debenture stock and all other monies due or to become due under the terms of a trust deed dated 30/3/73.
    Kurze Angaben
    F/H property comprised in a land registry transfer dated 28/3/91 relating to part of the property k/a the harrow public house, 22 whitefriars st. City of london.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 25. Jan. 1991
    Geliefert am 28. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,000,000 10 1/2% first mortgage debenture stock 2016 of the co. To the chargee constituted by a trust deed dated 1/11/90.
    Kurze Angaben
    All that f/h property on the west side of the parkway, cranford, hounslow. T/n ngl 296431, together with buildings,fixtures, fixed plant and machinery (other than tenants or trade fixtures).
    Berechtigte Personen
    • L.D.C. Trustees LTD.
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution
    Erstellt am 13. Apr. 1988
    Geliefert am 15. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee supplemental to alegal charge dated 29/3/78.
    Kurze Angaben
    (1)Brownlow house, london WC1. (2)16 devonshire row, london EC2. (3)5/7 new st. London EC2.
    Berechtigte Personen
    • Gisborne Life Assurance Co. LTD.
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 27. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 06. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £9,000,000 and all other monies due or to become due from the chargee under the terms of a legal charge dated 1/7/85.
    Kurze Angaben
    (1) f/h land and building k/a dewar house central rd. Harlow, essex. T/n ex 279765 (2) l/h land and buildings k/a 125 pall mall and 16 warwick st. In the city of westminster. T/n ngl 458917 (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Refuge Assurance Public LTD. Co.
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of release and substitution
    Erstellt am 08. März 1988
    Geliefert am 09. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the co. To the chargee under the terms of a trust deed dated 1/11/85.
    Kurze Angaben
    L/H property k/a royal trust house, 56 jermyn st. London SW1 (previously 54, 55AND 56 jermyn st.) t/no. Ngl 394293 l/h property k/a basement and ground floor premises 54, 55 and 56 jermyn st. London SW1. T/no. Ln 153906.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Trust Co. LTD.
    Transaktionen
    • 09. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 27. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HASLEMERE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Juni 2018Beginn der Liquidation
    21. Sept. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0