HASLEMERE ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HASLEMERE ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00382593 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HASLEMERE ESTATES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HASLEMERE ESTATES PUBLIC LIMITED COMPANY | 07. Sept. 1943 | 07. Sept. 1943 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Zahra Peermohamed als Sekretär am 19. Juli 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 16. Juli 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Zahra Peermohamed als Sekretär am 01. März 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Stewart Girling als Direktor am 26. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Sekretär am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Roy Slocombe als Geschäftsführer am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damien Ivo Karlov als Geschäftsführer am 28. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Derek Carter als Direktor am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anupam Manchanda als Geschäftsführer am 02. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 173 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 169 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 170 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Panayot Kostadinov Vasilev als Geschäftsführer am 18. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER, Derek | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 225848070001 | |||||
| GIRLING, Paul Stewart | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 225432580001 | |||||
| BAMBER, Janine Margaret | Sekretär | 105 Shepperton Road N1 3DF London | British | 117898690002 | ||||||
| BROWN, Grace | Sekretär | 35 Corringham Road Wembley Park HA9 9PX Wembley Middlesex | British | 102074060001 | ||||||
| KEARLEY, Andrew Paul | Sekretär | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | 26039210001 | ||||||
| LEE, David Robert | Sekretär | 2 Thurlow Close SG1 4SD Stevenage Hertfordshire | British | 76032910002 | ||||||
| PEERMOHAMED, Zahra | Sekretär | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | 243694100001 | |||||||
| SLOCOMBE, Stephen Roy | Sekretär | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | British | 55097590003 | ||||||
| WEBSTER, Peter David | Sekretär | 34 West Common RH16 2AH Haywards Heath West Sussex | British | 33107380001 | ||||||
| WEISS, Beatrix Anna Margarita Parsons | Sekretär | Meadow Cottage Hawksfold Lane GU27 3JW Fernhurst Surrey | British | 85529340001 | ||||||
| ABRAMSON, Christoffer | Geschäftsführer | 37-39 Abingdon Road Flat 2 W8 6AH London | Swedish | 98463110005 | ||||||
| BARTRAM, Christopher John | Geschäftsführer | 15 Trumpington Road CB2 2AJ Cambridge | England | British | 38758710002 | |||||
| BOTHA, Stephanie | Geschäftsführer | 5 Highbridge Wharf Highbridge SE10 9PS London | American | 116663740001 | ||||||
| BOWDEN, Matthew Neville | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183344960001 | |||||
| BURGER, Alec | Geschäftsführer | 3 Adelade Road KT12 1NB Walton On Thames Surrey | British And American | 83634080006 | ||||||
| CASEY, Shay Andrew | Geschäftsführer | Flat 3 St Mary Hall 106 Felsham Road SW15 1DQ London | United Kingdom | Irish | 90824990003 | |||||
| CLUTTON, Rafe Henry | Geschäftsführer | 45 Berkeley Square W1X 5DB London | British | 71022260001 | ||||||
| CONNELLAN, Paul Francis | Geschäftsführer | 7 Spencer Road TW7 4BQ Isleworth Middlesex | British | 67336830001 | ||||||
| CREASEY, Maxwell Rogers | Geschäftsführer | 47 St Botolphs Road TN13 3AG Sevenoaks Kent | British | 3428010002 | ||||||
| DEBNEY, Richard Johnathon | Geschäftsführer | 81 Manor Way Blackheath SE3 9XG London | England | British | 59232720003 | |||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| DEL BEATO, Ilaria Jane | Geschäftsführer | 33 Gorst Road Battersea SW11 6JB London | United Kingdom | British | 93124450002 | |||||
| DELANEY, Martin Peter | Geschäftsführer | 4 Hillside Road WD7 7BH Radlett Hertfordshire | England | British | 6499050001 | |||||
| EDWARDS, Jeremy Colin Gamul | Geschäftsführer | Dray House Broomrigg Road GU13 8LR Fleet Hampshire | England | British | 225698250001 | |||||
| FELCE, Gary John | Geschäftsführer | 25 Ickwell Road Northill SG18 9AB Biggleswade Bedfordshire | England | British | 107819460001 | |||||
| GATISS, Ian William | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | 95094220003 | |||||
| HARRIS, Neil Jason | Geschäftsführer | Pattison Lane Woolstone MK15 0AU Milton Keynes 11 Buckinghamshire | England | British | 94095660004 | |||||
| JEVNE, Anne | Geschäftsführer | Flat 8 70 Ironmonger Row EC1V 3QR London | Norwegian | 106807190001 | ||||||
| KARLOV, Damien Ivo | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | 202318870001 | |||||
| KEARLEY, Andrew Paul | Geschäftsführer | 12 Fiddicroft Avenue SM7 3AD Banstead Surrey | British | 26039210001 | ||||||
| KREMERS, Johan | Geschäftsführer | Rubenslaan 15 FOREIGN 3723 Bn Bilthoven Netherlands | Dutch | 8296290001 | ||||||
| LEE, David Robert | Geschäftsführer | 2 Thurlow Close SG1 4SD Stevenage Hertfordshire | British | 76032910002 | ||||||
| LEWIS, Martyn Phillips | Geschäftsführer | Wyncroft Ringmore TQ7 4HL Kingsbridge Devon | England | British | 96177720001 | |||||
| MANCHANDA, Anupam | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark | United Kingdom | Indian | 196338510001 | |||||
| MARFLEET, Thomas | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 139855250001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HASLEMERE ESTATES LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 12. Apr. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat HASLEMERE ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Ninth supplemental trust deed dated 17TH and 21ST december 2004 and | Erstellt am 22. Dez. 2004 Erworben am 17. Nov. 2005 Geliefert am 07. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 and all other moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All l/h property demised pusuant to a supplemental lease and deed of variation dated 17 december 2004 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 3 january 2002 and | Erstellt am 16. Dez. 2002 Geliefert am 11. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects known as 15-19 devon place,edinburgh; MID32235; all buildings fixtures thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed security document | Erstellt am 16. Dez. 2002 Geliefert am 23. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by a chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Present real property, other assets and assignments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fifth supplemental trust deed dated 6TH november 2002 and | Erstellt am 11. Nov. 2002 Erworben am 17. Nov. 2005 Geliefert am 07. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £60,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a whittaker house, 2 whittaker avenue, richmond upon thames t/no SGL520880, all and whole the area k/a richmond riverside site, richmond upon thames including (1) lower ground and ground floors, 13 hill street, richmond upon thames, surrey t/no SGL520879, for details of further property charged please refer to form 395, together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fourth supplemental trust deed | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 19. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from haslemere jersey finance limited and/or haslemere B.V. to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a the manor and manor court crawley t/nos WSX88129, WSX252913 and WSX94335. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fifth supplemental trust deed | Erstellt am 06. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Payment to the chargee of the principal of and the interest on the existing stock (as defined in the trust deed) and all other money intended to be secured by the trust deed | |
Kurze Angaben The property being l/h land k/a 46 berkley square and 46 hays mews london W1 in the county of greater london t/n NGL186778 and the l/h land k/a 105 piccadilly london SW1 in the county of greater london t/n 368978 together with all buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery (but excludingall tenants and trade fixtures and fitting). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 8 november 2002 and | Erstellt am 01. Nov. 2002 Geliefert am 18. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and/or the guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The dominium directum and the dominium utile of all and whole that angular area or piece of ground consisting of one acre, one rood and one pole imperial measure lying on the south side of devon place edinburgh in the county of midlothian. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 22. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal sum of £20,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £45,832,312.67. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 24. Juni 1999 Erworben am 17. Nov. 2005 Geliefert am 08. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and/or the guarantor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property known as 43-45 portman square london t/n LN96191, all buildings and fixtures, plant and machinery, the benefit of all leases,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed made between rodamco jersey finance limited (the "issuer"), rodamco united kingdom B.V. (the "guarantor"), the company, schildvink bv (together with the company the "original charging companies") and the trustee relating to and securing £150,000,000 | Erstellt am 24. Juni 1999 Geliefert am 06. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (the "trustee") on behalf of itself and for the benefit of the bondholders and the couponholders (as defined) in respect of the principal of and interest on the original bonds (as defined) and all further bonds (as defined) and all other monies covenanted to be paid by the issuer and/or the guarantor (or any successor in business of the issuer and/or the guarantor or any holding company of the guarantor who is or becomes a substituted obligor in accordance with clause 33.3 of the principal trust deed) to the trustee under or pursuant to the trust presents (as defined) | |
Kurze Angaben L/H land k/a cable house (formerly called capel house) 54 to 62 new broad street london EC2 t/no: NGL529794. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further deed of charge | Erstellt am 29. Mai 1998 Geliefert am 10. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement of 29 september 1980 and a legal charge of 1 july 1985 | |
Kurze Angaben L/H land and buildings at 54/62 new broad street london EC2 t/n NGL529794 and all that l/h land under t/n DT144960 k/a land and buildings lying to the north of king street weymouth. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 10. Feb. 1998 Geliefert am 27. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 29TH september 1980 or the legal charges | |
Kurze Angaben All amounts from time to time standing to the credit of account number 36137499 maintained with national westminster bank PLC of 1 princes street, london EC2R 8PH (the "deposit account") or to the credit of any replacement account;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge relating to a deposit | Erstellt am 20. Nov. 1997 Geliefert am 26. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3,760,00 due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of 29 october 1980 | |
Kurze Angaben A deposit of £3,760,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 08. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £9,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge dated 1ST july 1985 | |
Kurze Angaben F/H land k/a 46 st mary axe city of london t/no 436397. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 06. Feb. 1996 Geliefert am 08. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 29TH september 1980 and a legal charge dat ed 1ST july 1985, a deed of release and substitution dated 31ST march 1988 and a deed of further charge dated 6TH september 1994 as amended or varied from time to time | |
Kurze Angaben All amounts from time to time standing to the credit of an interest bearing capital reserve account in the name of the company with national westminster bank PLC on an account numbered 95854754. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 26. Jan. 1996 Geliefert am 02. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £80,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 30 march 1973 | |
Kurze Angaben L/H property k/a 2 bridge street tower house, 10 and 11 bridge street palm court. 4 heron square and heron house, 5 heron square richmond upon thames t/n SGL520881, f/h property the pinnacles estate coldharbour road harlow essex t/n's EX297012 and EX299961. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 26. Jan. 1996 Geliefert am 02. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 1 november 1985 | |
Kurze Angaben L/H property k/a 65 to 69 (odd) new cavendish street and 44/48 (inc) weymouth mews london W1 t/n LN35522. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further deed of charge | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 07. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee upon the terms and mortgage conditions of the principal charge (as defined in the further deed of charge dated 6 september 1994) | |
Kurze Angaben 4 college hill london.serborne HOUSE119/121 cannon street london EC4. 14 trinity square london EC3 and various properties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 20. Juni 1994 Geliefert am 23. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 1ST of november 1985 | |
Kurze Angaben 22 bevis marks and 11/12 bury street and units 1 and 3 southampton road, salisbury, wiltshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and subsitution | Erstellt am 20. Juni 1994 Geliefert am 23. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,000,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 30TH of march 1973 | |
Kurze Angaben 49,50 and bow lane and 51 bow lane london EC4. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 23. Sept. 1991 Geliefert am 23. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,000,000 10 1/4% first mortgage debenture stock and all other monies due or to become due under the terms of a trust deed dated 30/3/73. | |
Kurze Angaben F/H property comprised in a land registry transfer dated 28/3/91 relating to part of the property k/a the harrow public house, 22 whitefriars st. City of london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 25. Jan. 1991 Geliefert am 28. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £20,000,000 10 1/2% first mortgage debenture stock 2016 of the co. To the chargee constituted by a trust deed dated 1/11/90. | |
Kurze Angaben All that f/h property on the west side of the parkway, cranford, hounslow. T/n ngl 296431, together with buildings,fixtures, fixed plant and machinery (other than tenants or trade fixtures). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of substitution | Erstellt am 13. Apr. 1988 Geliefert am 15. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany to the chargee supplemental to alegal charge dated 29/3/78. | |
Kurze Angaben (1)Brownlow house, london WC1. (2)16 devonshire row, london EC2. (3)5/7 new st. London EC2. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 31. März 1988 Geliefert am 06. Apr. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £9,000,000 and all other monies due or to become due from the chargee under the terms of a legal charge dated 1/7/85. | |
Kurze Angaben (1) f/h land and building k/a dewar house central rd. Harlow, essex. T/n ex 279765 (2) l/h land and buildings k/a 125 pall mall and 16 warwick st. In the city of westminster. T/n ngl 458917 (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 08. März 1988 Geliefert am 09. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the co. To the chargee under the terms of a trust deed dated 1/11/85. | |
Kurze Angaben L/H property k/a royal trust house, 56 jermyn st. London SW1 (previously 54, 55AND 56 jermyn st.) t/no. Ngl 394293 l/h property k/a basement and ground floor premises 54, 55 and 56 jermyn st. London SW1. T/no. Ln 153906. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HASLEMERE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0