IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00385037 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 161 Marsh Wall E14 9AP London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOOKS FOR PLEASURE LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| CHEMINDEX LIMITED | 18. Jan. 1944 | 18. Jan. 1944 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcus Alvin Rich als Geschäftsführer am 26. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Mai 2020
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 003850370005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Rachel Addison als Direktor am 27. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John May als Geschäftsführer am 31. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Time Inc. (Uk) Ltd as a person with significant control on 14. Juni 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Cessation of Time Inc. as a person with significant control on 15. März 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Sapphire Topco Limited as a person with significant control on 15. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 003850370005, erstellt am 05. Apr. 2018 | 65 Seiten | MR01 | ||||||||||
Change of details for Time Inc. (Uk) Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Susana D'emic als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lauren Ezrol Klein als Sekretär am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Notification of Time Inc. as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Change of details for Time Inc. (Uk) Ltd as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDISON, Rachel Bernadette | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 250816460001 | |||||
| GORE, John Francis | Sekretär | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Sekretär | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Sekretär | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Sekretär | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Sekretär | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| ALEY, William Robert | Geschäftsführer | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Geschäftsführer | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Geschäftsführer | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Geschäftsführer | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Geschäftsführer | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Geschäftsführer | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| EVANS, Richard John | Geschäftsführer | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Geschäftsführer | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| MAIR, Denise Margaret | Geschäftsführer | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Geschäftsführer | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MELLON, John Benedict | Geschäftsführer | Westward House 7 Hayes Lane CR8 5LE Kenley Surrey | British | 35523050001 | ||||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Geschäftsführer | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| PHILBIN, John Nicholas | Geschäftsführer | 30 Airedale Avenue Chiswick W4 2NW London | British | 3098280001 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Geschäftsführer | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Geschäftsführer | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Geschäftsführer | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire Topco Limited | 15. März 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06. Apr. 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ti Media Limited | 06. Apr. 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Apr. 2018 Geliefert am 11. Apr. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Please see instrument for further details. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Aug. 1999 Geliefert am 02. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture to a debenture dated 19TH JANUARY1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998 | Erstellt am 23. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Erstellt am 12. Okt. 1998 Geliefert am 15. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Jan. 1998 Geliefert am 06. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0