AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED

AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAEROGISTICS TREATMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00385755
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    • (2851) /

    Wo befindet sich AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    D T E House
    Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KING AND FOWLER LIMITED23. Feb. 194423. Feb. 1944

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Mai 2013

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Feb. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Aug. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Feb. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Aug. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Feb. 2011

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    24 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Feb. 2010

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 29. Jan. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Unit 1 Brunswick Business Park, Harrison Way, Liverpool, L3 4BG am 22. Feb. 2010

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Michael Brown als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Brown als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Thomas Dawes als Sekretär

    2 SeitenAP03

    legacy

    5 SeitenMG01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAWES, Thomas
    Albert Dock
    L3 4AG Liverpool
    418 The Colonnades
    Sekretär
    Albert Dock
    L3 4AG Liverpool
    418 The Colonnades
    British148626840001
    BOLD, Alan David
    145 Blackmoor Drive
    West Derby
    L12 9EE Liverpool
    Geschäftsführer
    145 Blackmoor Drive
    West Derby
    L12 9EE Liverpool
    British73732950002
    DAWES, Thomas Benjamin
    418 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AG Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    418 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AG Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish85223040002
    ARTHUR, Ann
    Weaver Cottage Ball Lane
    Kingsley
    WA6 8HP Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    Weaver Cottage Ball Lane
    Kingsley
    WA6 8HP Warrington
    Cheshire
    British14900550001
    BELL, Nicholas John
    29 Daniell Way
    CH3 5XH Chester
    Cheshire
    Sekretär
    29 Daniell Way
    CH3 5XH Chester
    Cheshire
    British41321480003
    BROWN, Michael Stewart
    Watergate
    Audenshaw
    M34 5QP Tameside
    17
    Sekretär
    Watergate
    Audenshaw
    M34 5QP Tameside
    17
    British133987360001
    GRIME, John Roland
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    British39112420001
    MCCAUL, Brian Aidan
    Flat 504 3 Burton Place
    Castlefield
    M15 4LR Manchester
    Sekretär
    Flat 504 3 Burton Place
    Castlefield
    M15 4LR Manchester
    British & Irish114616250001
    ARTHUR, Robert Allan Reid
    Weaver Cottage Ball Lane
    Kingsley
    WA6 8HP Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Weaver Cottage Ball Lane
    Kingsley
    WA6 8HP Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish14900560001
    BELL, Nicholas John
    29 Daniell Way
    CH3 5XH Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    29 Daniell Way
    CH3 5XH Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish41321480003
    BOLD, Alan David
    145 Blackmoor Drive
    West Derby
    L12 9EE Liverpool
    Geschäftsführer
    145 Blackmoor Drive
    West Derby
    L12 9EE Liverpool
    British73732950002
    BROWN, Michael Stewart
    Watergate
    Audenshaw
    M34 5QP Tameside
    17
    Geschäftsführer
    Watergate
    Audenshaw
    M34 5QP Tameside
    17
    EnglandBritish133987360001
    CHESWORTH, John
    Oulton Farm
    Rushton Spencer
    SK11 0RS Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Oulton Farm
    Rushton Spencer
    SK11 0RS Macclesfield
    Cheshire
    British2884660001
    KEHOE, Dennis Frederick, Dr
    26 Hornby Lane
    L18 3HH Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    26 Hornby Lane
    L18 3HH Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish85821230001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritish221394890001
    MCCAUL, Brian Aidan
    Flat 504 3 Burton Place
    Castlefield
    M15 4LR Manchester
    Geschäftsführer
    Flat 504 3 Burton Place
    Castlefield
    M15 4LR Manchester
    United KingdomBritish & Irish114616250001
    SAVAGE, Carl Thomas
    139 Pilkington Avenue
    B72 1LH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    139 Pilkington Avenue
    B72 1LH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50815600001
    SHUTE, Michael Derek John
    Dune House Bosworth Drive
    PR8 2SR Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Dune House Bosworth Drive
    PR8 2SR Southport
    Merseyside
    British56687430001
    STARBUCK, David Harold
    19 Bradgate Road
    WA14 4QU Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Bradgate Road
    WA14 4QU Altrincham
    Cheshire
    English3412570001
    WILDBUR, Philip Alan
    Bryn Bedw
    Llangynhafal
    LL15 1RU Ruthin
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Bryn Bedw
    Llangynhafal
    LL15 1RU Ruthin
    Clwyd
    WalesBritish98422710001
    BODYCOTE NOMINEES NO 1 LIMITED
    Hulley Road
    Hurdsfield
    SK10 2SG Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hulley Road
    Hurdsfield
    SK10 2SG Macclesfield
    Cheshire
    67662690003
    BODYCOTE NOMINEES NO 2 LIMITED
    Hulley Road
    Hurdsfield
    SK10 2SG Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hulley Road
    Hurdsfield
    SK10 2SG Macclesfield
    Cheshire
    67662500003

    Hat AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 02. Nov. 2009
    Geliefert am 04. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • North West Transitional Loan Investment Fund
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juli 2008
    Geliefert am 01. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 23. Juni 2008
    Geliefert am 25. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Plastic fan co fully automated market value £35,000 anodising line comprising 22 various tanks market value £22,500 cadium line composing 33 various tanks market value £18,500 for further details of the equipment charged please refer to form 395.
    Berechtigte Personen
    • Afm Samll Firms Fund Limited as General Partner of Merseyside Special Investments (Small Films) Fund No.3
    Transaktionen
    • 25. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 2007
    Geliefert am 04. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £310,969.60 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    Fast track production line for cad chrome & pfd comprising of fast track 20.06.07 wolseley pfd seperation system fast track 01.12.06 wjc pin aft spigot pvc D575 56088/56167/56122/51028/51029 fast track 01.12.06 wjc r/pin jigs A57242412/D57551039/F321 5006 pvc cost only for details of further goods charged please refer to form 395 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging to the items listed. The mortgagecontains a covenant by the company not to create or allow to arise in respect of the above items any mortgage charge pledge lien or other encumbrance.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC C/O Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2007
    Geliefert am 09. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Special Investment Venture Fund No. 3, and Alliance Fund Managers Nominees Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 16. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Feb. 2005
    Geliefert am 04. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 2005
    Geliefert am 01. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £163,680.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hunziker model/type SG1002DFM10 automatic shot blast machine with rotary table s/no 2001 06109, vacublast ventus vacublast machine with cyclone system dust extraction s/no 99010900 11432-77, flott model/type MA600 double ended polishing machine s/no 120 799011. for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 1998
    Geliefert am 02. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 24. Nov. 1986
    Geliefert am 01. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time hereafter owing or incurred to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. März 1980
    Geliefert am 31. März 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H units 6A7 & 6A8 ashcroft road, kirby industrial estate kirby merseyside together with all fixtures. Title no ms 94432.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1980Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Apr. 1970
    Geliefert am 24. Apr. 1970
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10/12, jamaica street, liverpool. With all fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1970Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage and charge.
    Erstellt am 19. Juli 1958
    Geliefert am 24. Juli 1958
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due etc
    Kurze Angaben
    Land and premises being site of buildings formerly erected thereon no. 30/44 bridgewater st and 14 jamaica st with the buildings to be erected thereon together with plant machinery fixtures implements and utensils present and future floating charges and undertaking all property present and future including uncalled capital (see doc 27 for details).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1958Registrierung einer Belastung
    • 15. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AEROGISTICS TREATMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Feb. 2010Beginn der Liquidation
    06. Sept. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Maloney
    D T E House Hollins Mount
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Mount
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    John Malcolm Titley
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0