WATERSTONE GLASSWARE LIMITED

WATERSTONE GLASSWARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWATERSTONE GLASSWARE LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00388023
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    • (2613) /
    • (2615) /

    Wo befindet sich WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Charnwood House
    Gregory Boulevard
    NG7 6NX Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GLASTICS LIMITED05. Juni 194405. Juni 1944

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2002
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2003
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 1998

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis13. Okt. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung27. Okt. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Angus George Patrick Forrest als Geschäftsführer am 21. Dez. 2017

    2 SeitenTM01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Richard Gill als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Chapman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    legacy

    7 Seiten363s

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    4 Seiten3.6

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    8 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 1998

    24 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RICHARDSON, Mary Elizabeth
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    British30830090001
    BRADLEY, Michael
    Bilton Brow
    Bilton In Ainsty
    YO26 7NN York
    Geschäftsführer
    Bilton Brow
    Bilton In Ainsty
    YO26 7NN York
    United KingdomBritish8181080002
    RICHARDSON, Mary Elizabeth
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    7 Deer Park Drive
    Arnold
    NG5 8SA Nottingham
    Nottinghamshire
    British30830090001
    GRIFFITHS, Michael John
    245 Springwood Lane
    High Green
    S35 4JP Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    245 Springwood Lane
    High Green
    S35 4JP Sheffield
    South Yorkshire
    British6407490001
    MINCHIN, Peter Humphrey
    171 Watt Lane
    Crosspool
    S10 5RD Sheffield
    Yorkshire
    Sekretär
    171 Watt Lane
    Crosspool
    S10 5RD Sheffield
    Yorkshire
    British73108170001
    BREESE, Charles Jonathon
    Steane Grounds Farm
    Steane
    NN13 5NP Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Steane Grounds Farm
    Steane
    NN13 5NP Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritish33215780004
    BRICE, John Roger Simpson
    4/ 262
    King Street
    W6 0SP London
    England
    Geschäftsführer
    4/ 262
    King Street
    W6 0SP London
    England
    British7886450002
    BUNDY, Christopher
    Elvington
    YO4 5AA York
    Bridge House
    Geschäftsführer
    Elvington
    YO4 5AA York
    Bridge House
    British264270005
    CHAPMAN, Paul Anthony
    28 Pavillion Close
    Aldridge
    WS9 8LS Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    28 Pavillion Close
    Aldridge
    WS9 8LS Walsall
    West Midlands
    United KingdomBritish36543980002
    FORREST, Angus George Patrick
    73 Taybridge Road
    SW11 5PX London
    Geschäftsführer
    73 Taybridge Road
    SW11 5PX London
    EnglandBritish9527930001
    GILL, Richard
    163 Holymoor Road Holymoorside
    S42 7DR Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    163 Holymoor Road Holymoorside
    S42 7DR Chesterfield
    Derbyshire
    UkBritish56494000002
    GRIFFITHS, Michael John
    245 Springwood Lane
    High Green
    S35 4JP Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    245 Springwood Lane
    High Green
    S35 4JP Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish6407490001
    LAWSON, John
    The Old Cottage Park Barn Farm
    Beacon Road Ditchling
    BN6 8XB Hassocks
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Old Cottage Park Barn Farm
    Beacon Road Ditchling
    BN6 8XB Hassocks
    West Sussex
    British25637820001
    MCCAUL, John
    Shanagarry
    South Park Drive
    SL9 8JJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Shanagarry
    South Park Drive
    SL9 8JJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British67993900001
    MINCHIN, Peter Humphrey
    171 Watt Lane
    Crosspool
    S10 5RD Sheffield
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    171 Watt Lane
    Crosspool
    S10 5RD Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish73108170001
    PADDOCK, Wilfred
    62 Wheatfield Drive
    Tickhill
    DN11 9UT Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    62 Wheatfield Drive
    Tickhill
    DN11 9UT Doncaster
    South Yorkshire
    British25637810001
    PEARSON, David
    4 Lyndhurst Rise
    Norton
    DN6 9PT Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Lyndhurst Rise
    Norton
    DN6 9PT Doncaster
    South Yorkshire
    British13413800001
    WATERHOUSE, Alan Charles
    Fourways 66 Brampton Road
    Wath-Upon-Dearne
    S63 6BB Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fourways 66 Brampton Road
    Wath-Upon-Dearne
    S63 6BB Rotherham
    South Yorkshire
    British33625050001

    Hat WATERSTONE GLASSWARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 04. Nov. 1999
    Geliefert am 09. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts (inc, the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason all amounts owing or becoming due to the company on any account inc, the associated rights relating thereto, all goodwill uncalled capital for the time being, all patents, patent applications, inventions, trade marks/names by way of floating charge the remainder of the undertaking and all property rights and assets.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 1999
    Geliefert am 05. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property described as 4 section sg is machine s/no ETM0003, glass moulding machine s/no C6405, new automated acid etch line s/no E3036, balsfulland screen printer s/no 9302503 (for full details of all property charged see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge supplemental to a cross guarantee and debenture dated 14TH june 1978 issued by the company
    Erstellt am 29. Okt. 1999
    Geliefert am 08. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Kurze Angaben
    Fixed charge all right title and interest of the company in and arising out of a factoring, invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 25TH october 1999 between royal bank invoice finance limited and the company and any deed amending or replacing the same and all book debts and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. März 1995
    Geliefert am 06. Apr. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land off common lane wath upon dearne rotherham t/n-SYK108780 and SYK288976.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 1995
    Geliefert am 01. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over the freehold and leasehold property of the company both present and future together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein , the goodwill and the uncalled capital of the company both present and future; the bookdebts and other debts due or owing to the company both present and future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC,
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1994
    Geliefert am 15. Juni 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 rockingham court swinton rotherham south yorkshire t/n-SYK289111.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge
    Erstellt am 20. Apr. 1990
    Geliefert am 27. Apr. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a receivables financing agreement dated 9 march 1990 between barclays commercial services limited and the company see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 24. Jan. 1990
    Geliefert am 26. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land off common lane, wath on dearne in the county of south yorkshire title no syk 108780.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. März 1989
    Geliefert am 08. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 08. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 23. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Sept. 1984
    Geliefert am 27. Sept. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ukp-Ea Growth Fund Limited
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 1984
    Geliefert am 19. Apr. 1984
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery including all patents, patent applications trademarks, trade names, registered designs, copyrights, licences & ancillary & connected rights both present & future of the company. (See doc M103 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Ukp-Ea Growth Fund Limited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 15. Jan. 1981
    Geliefert am 05. Feb. 1981
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land & buildings on north west side of common lane, wath-on-dearne, S. yorks. Syk 108780.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1981Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Juni 1978
    Geliefert am 03. Juli 1978
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juli 1978Registrierung einer Belastung
    • 09. Feb. 2000Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 08. Dez. 2005Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (405 (2))
      • Aktenzeichen 1

    Hat WATERSTONE GLASSWARE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Juni 1978Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dilip K Dattani
    Foxhall Lodge
    Gregory Boulevard
    NG7 6LH Nottingham
    Praktiker
    Foxhall Lodge
    Gregory Boulevard
    NG7 6LH Nottingham
    Patrick B Ellward
    Tenon Recovery
    Foxhall Lodge
    NG7 6LH Gregory Boulevard
    Nottingham
    Praktiker
    Tenon Recovery
    Foxhall Lodge
    NG7 6LH Gregory Boulevard
    Nottingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0