WATERSTONE GLASSWARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WATERSTONE GLASSWARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00388023 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
- (2613) /
- (2615) /
Wo befindet sich WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Charnwood House Gregory Boulevard NG7 6NX Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GLASTICS LIMITED | 05. Juni 1944 | 05. Juni 1944 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2002 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Okt. 2003 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 1998 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 13. Okt. 2016 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 27. Okt. 2016 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Angus George Patrick Forrest als Geschäftsführer am 21. Dez. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Beendigung der Bestellung von Richard Gill als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Chapman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 405(2) | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 2 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 3 Seiten | 3.6 | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 3 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers | 4 Seiten | 3.6 | ||
Bericht des Verwaltungsverwalters | 8 Seiten | 3.10 | ||
legacy | 1 Seiten | 405(1) | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 1998 | 24 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 395 | ||
legacy | 4 Seiten | 395 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von WATERSTONE GLASSWARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDSON, Mary Elizabeth | Sekretär | 7 Deer Park Drive Arnold NG5 8SA Nottingham Nottinghamshire | British | 30830090001 | ||||||
| BRADLEY, Michael | Geschäftsführer | Bilton Brow Bilton In Ainsty YO26 7NN York | United Kingdom | British | 8181080002 | |||||
| RICHARDSON, Mary Elizabeth | Geschäftsführer | 7 Deer Park Drive Arnold NG5 8SA Nottingham Nottinghamshire | British | 30830090001 | ||||||
| GRIFFITHS, Michael John | Sekretär | 245 Springwood Lane High Green S35 4JP Sheffield South Yorkshire | British | 6407490001 | ||||||
| MINCHIN, Peter Humphrey | Sekretär | 171 Watt Lane Crosspool S10 5RD Sheffield Yorkshire | British | 73108170001 | ||||||
| BREESE, Charles Jonathon | Geschäftsführer | Steane Grounds Farm Steane NN13 5NP Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | 33215780004 | |||||
| BRICE, John Roger Simpson | Geschäftsführer | 4/ 262 King Street W6 0SP London England | British | 7886450002 | ||||||
| BUNDY, Christopher | Geschäftsführer | Elvington YO4 5AA York Bridge House | British | 264270005 | ||||||
| CHAPMAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | 28 Pavillion Close Aldridge WS9 8LS Walsall West Midlands | United Kingdom | British | 36543980002 | |||||
| FORREST, Angus George Patrick | Geschäftsführer | 73 Taybridge Road SW11 5PX London | England | British | 9527930001 | |||||
| GILL, Richard | Geschäftsführer | 163 Holymoor Road Holymoorside S42 7DR Chesterfield Derbyshire | Uk | British | 56494000002 | |||||
| GRIFFITHS, Michael John | Geschäftsführer | 245 Springwood Lane High Green S35 4JP Sheffield South Yorkshire | England | British | 6407490001 | |||||
| LAWSON, John | Geschäftsführer | The Old Cottage Park Barn Farm Beacon Road Ditchling BN6 8XB Hassocks West Sussex | British | 25637820001 | ||||||
| MCCAUL, John | Geschäftsführer | Shanagarry South Park Drive SL9 8JJ Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 67993900001 | ||||||
| MINCHIN, Peter Humphrey | Geschäftsführer | 171 Watt Lane Crosspool S10 5RD Sheffield Yorkshire | England | British | 73108170001 | |||||
| PADDOCK, Wilfred | Geschäftsführer | 62 Wheatfield Drive Tickhill DN11 9UT Doncaster South Yorkshire | British | 25637810001 | ||||||
| PEARSON, David | Geschäftsführer | 4 Lyndhurst Rise Norton DN6 9PT Doncaster South Yorkshire | British | 13413800001 | ||||||
| WATERHOUSE, Alan Charles | Geschäftsführer | Fourways 66 Brampton Road Wath-Upon-Dearne S63 6BB Rotherham South Yorkshire | British | 33625050001 |
Hat WATERSTONE GLASSWARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 04. Nov. 1999 Geliefert am 09. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts (inc, the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason all amounts owing or becoming due to the company on any account inc, the associated rights relating thereto, all goodwill uncalled capital for the time being, all patents, patent applications, inventions, trade marks/names by way of floating charge the remainder of the undertaking and all property rights and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1999 Geliefert am 05. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property described as 4 section sg is machine s/no ETM0003, glass moulding machine s/no C6405, new automated acid etch line s/no E3036, balsfulland screen printer s/no 9302503 (for full details of all property charged see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a cross guarantee and debenture dated 14TH june 1978 issued by the company | Erstellt am 29. Okt. 1999 Geliefert am 08. Nov. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Kurze Angaben Fixed charge all right title and interest of the company in and arising out of a factoring, invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 25TH october 1999 between royal bank invoice finance limited and the company and any deed amending or replacing the same and all book debts and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. März 1995 Geliefert am 06. Apr. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-land off common lane wath upon dearne rotherham t/n-SYK108780 and SYK288976. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1995 Geliefert am 01. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over the freehold and leasehold property of the company both present and future together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein , the goodwill and the uncalled capital of the company both present and future; the bookdebts and other debts due or owing to the company both present and future. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1994 Geliefert am 15. Juni 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 4 rockingham court swinton rotherham south yorkshire t/n-SYK289111. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 20. Apr. 1990 Geliefert am 27. Apr. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a receivables financing agreement dated 9 march 1990 between barclays commercial services limited and the company see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1990 Geliefert am 26. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land off common lane, wath on dearne in the county of south yorkshire title no syk 108780. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 1989 Geliefert am 08. März 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Sept. 1984 Geliefert am 27. Sept. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 1984 Geliefert am 19. Apr. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery including all patents, patent applications trademarks, trade names, registered designs, copyrights, licences & ancillary & connected rights both present & future of the company. (See doc M103 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Jan. 1981 Geliefert am 05. Feb. 1981 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land & buildings on north west side of common lane, wath-on-dearne, S. yorks. Syk 108780. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 1978 Geliefert am 03. Juli 1978 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
Hat WATERSTONE GLASSWARE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0