CUTLERS HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CUTLERS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00396956 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 82 St John Street EC1M 4JN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHEFFIELD UNITED LIMITED | 20. Jan. 2014 | 20. Jan. 2014 |
| SHEFFIELD UNITED PLC | 14. Jan. 1997 | 14. Jan. 1997 |
| CONRAD PLC | 19. Apr. 1993 | 19. Apr. 1993 |
| CONRAD CONTINENTAL PLC | 06. Juni 1989 | 06. Juni 1989 |
| TOP VALUE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 28. Aug. 1985 | 28. Aug. 1985 |
| ARTHUR HENRIQUES PUBLIC LIMITED COMPANY | 13. Juli 1945 | 13. Juli 1945 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2023 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2024 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2022 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Juni 2024 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 24. Juni 2024 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Juni 2023 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Nov. 2024 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ England zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 04. Dez. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht | 88 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Charles Mccabe als Geschäftsführer am 24. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Richard Mccabe als Geschäftsführer am 24. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Charles Mccabe als Geschäftsführer am 24. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2023 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2022 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2021 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 003969560014 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 36 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Charles Mccabe am 23. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bramall Lane Sheffield S2 4SU zum Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ am 07. Okt. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 9 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 003969560013 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom |
| 123430250001 | ||||||||||
| TUTTON, Jeremy John | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | United Kingdom | British | 113787520002 | |||||||||
| BURNS, Craig | Sekretär | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | 167991150001 | |||||||||||
| CAPPER, Simon | Sekretär | Bramall Lane S2 4SU Sheffield | British | 118147580002 | ||||||||||
| FENOUGHTY, Mark Thomas | Sekretär | 108 Totley Brook Road S17 3QU Sheffield South Yorkshire | British | 91397360003 | ||||||||||
| HARROP, David | Sekretär | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | 153053480001 | |||||||||||
| LIGHTBURN, Trevor | Sekretär | 75 Grosvenor Avenue Hartford CW8 1RP Northwich Cheshire | British | 27731500001 | ||||||||||
| MANNING, Michael Atkinson | Sekretär | 67 Postern Close YO23 1JF York North Yorkshire | British | 20393860001 | ||||||||||
| MCBOYLE, Colin | Sekretär | The Leas Tedgness Road, Grindleford S32 2HX Hope Valley | British | 88292370001 | ||||||||||
| WHETTON, Barry Newton | Sekretär | The Stables 179 Woodford Road SK7 1QE Bramhall Stockport | British | 14277000002 | ||||||||||
| ARGALL, Simon Neil | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | England | British | 135482050001 | |||||||||
| BAMFORD, Alan Maxwell | Geschäftsführer | Stonecroft 53 Vicarage Lane Dore S17 3GX Sheffield South Yorkshire | British | 11424620001 | ||||||||||
| BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett | Geschäftsführer | 7 Hillingdon Road Whitefield M45 7QQ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 2883500001 | |||||||||
| BIRCH, Trevor | Geschäftsführer | Cherry Street S2 4SU Sheffield Bramall Lane South Yorkshire | Uk | British | 160667800001 | |||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Geschäftsführer | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| BURNS, Craig | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | England | British | 167991320001 | |||||||||
| BURNS, Craig | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | England | British | 167991320001 | |||||||||
| CABORN, Richard George | Geschäftsführer | Quarry Vale Road S12 3EB Sheffield 29 South Yorkshire | England | British | 19964460001 | |||||||||
| CAPPER, David | Geschäftsführer | 5 Wychwood Glen Sothall S20 2QL Sheffield | British | 61833820001 | ||||||||||
| CAPPER, Simon | Geschäftsführer | Bramall Lane S2 4SU Sheffield | United Kingdom | British | 118147580002 | |||||||||
| CHARLTON, Robert, Sir | Geschäftsführer | Garthollerton Chelford Road Ollerton WA16 8RY Knutsford Cheshire | England | British | 24245540001 | |||||||||
| COLOMBOTTI, Carlo Eugenio Pio | Geschäftsführer | Flat 8 Block A The Albany Piccadilly W1J 0AL London | United Kingdom | British | 64380630004 | |||||||||
| DOOLEY, Derek | Geschäftsführer | 83 Norton Park View S8 8GU Sheffield South Yorkshire | British | 34642040001 | ||||||||||
| DUDLEY, Michael Douglas | Geschäftsführer | 40a Ridgeway Moor Ridgeway S12 3XW Sheffield South Yorkshire | England | British | 6988540001 | |||||||||
| EDELSON, John Michael | Geschäftsführer | 17 Carrwood WA15 0ED Hale Barns Cheshire | England | British | 28353840001 | |||||||||
| ESAN, Jacob Babadiya Oyebola | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | Nigeria | Nigerian | 171945750001 | |||||||||
| FAMAN, Michael John | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | United Kingdom | British | 138962320001 | |||||||||
| FENOUGHTY, Mark Thomas | Geschäftsführer | 108 Totley Brook Road S17 3QU Sheffield South Yorkshire | British | 91397360003 | ||||||||||
| GODDARD, Terence Allan | Geschäftsführer | Mockbeggars Bedham, Fittleworth RH20 1JP Pulborough | British | 119417730001 | ||||||||||
| GREEN, Charles Alexander | Geschäftsführer | Oak Tree Farm Blankney Barff LN4 3BJ Wetheringham Lincolnshire | British | 75952680002 | ||||||||||
| HARDISTY, David Garfield | Geschäftsführer | Linross Eaton Park KT11 2JE Cobham Surrey | British | 1705920001 | ||||||||||
| HARROP, David Anthony | Geschäftsführer | Bramall Lane Sheffield S2 4SU | England | British | 160187290001 | |||||||||
| HAWTHORNE, Philip | Geschäftsführer | 11 Avondale Road Swinley WN1 2BE Wigan Lancashire | British | 79740350001 | ||||||||||
| LAVER, Andrew James | Geschäftsführer | Hilltop Hall Farm Kirkby Overblow HG3 1EZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 138223860001 | |||||||||
| MCBOYLE, Colin | Geschäftsführer | The Leas Tedgness Road, Grindleford S32 2HX Hope Valley | British | 88292370001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CUTLERS HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough United Group Limited | 05. Juli 2017 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CUTLERS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 15. Mai 2019 Geliefert am 28. Mai 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 1 ordinary share of £1.00 in john street developments limited with registered number 05805777. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 19. Mai 2016 Geliefert am 20. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of shares | Erstellt am 19. Okt. 2011 Geliefert am 26. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from scarborough finance company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1 ordinary share of £1 in john street developments limited and the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. März 2008 Geliefert am 28. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land at the north side of crookes road, sheffield t/no SYK521171 for details of further property charged please refer to form 395 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 29. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 18. Apr. 2005 Geliefert am 27. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 share in broomco (3713) limited (to be renamed united scarborough estates limited), any securities and related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Jan. 2002 Geliefert am 17. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the east side of shirecliffe road, sheffield, south yorkshire t/no. SYK168119. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Aug. 2001 Geliefert am 31. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whole of the property (including uncalled capital) which is or may be from time to time comprised in the property and undertaking of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Juli 1997 Geliefert am 29. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 24. Jan. 1996 Geliefert am 07. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all monies from time to time held to the credit of the company by the bank on any current deposit or other account(s) which the company may have with the bank or under any deposit receipt (the deposit monies). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 24. Jan. 1996 Geliefert am 07. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property comprised in the deeds policies securities certificates and/or other documents deposited with the bank (the deposited property). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 18. Juni 1992 Geliefert am 24. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group cross. Guarantee indemnity & debenture | Erstellt am 19. Dez. 1990 Geliefert am 04. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 17. Dez. 1990 Geliefert am 20. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including all heritable property and assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CUTLERS HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0